OMD PROPERTY (HOLBORN) LIMITED

OMD PROPERTY (HOLBORN) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameOMD PROPERTY (HOLBORN) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04017598
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von OMD PROPERTY (HOLBORN) LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich OMD PROPERTY (HOLBORN) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von OMD PROPERTY (HOLBORN) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MELONDRIFT LIMITED20. Juni 200020. Juni 2000

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OMD PROPERTY (HOLBORN) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für OMD PROPERTY (HOLBORN) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    8 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 40 Queen Anne Street London W1G 9EL zum 26-28 Bedford Row London WC1R 4HE am 07. Dez. 2015

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 17. Nov. 2015

    LRESSP

    Ernennung von Mr Colin Barry Wagman als Direktor am 17. Nov. 2015

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital24. Nov. 2015

    Kapitalaufstellung am 24. Nov. 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    13 SeitenAA

    Ernennung von Mr James Anthony Piper als Direktor am 31. Dez. 2014

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Ivan Howard Ezekiel als Sekretär am 28. Jan. 2015

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Michael George Cohen als Direktor am 31. Dez. 2014

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Ivan Howard Ezekiel als Geschäftsführer am 28. Jan. 2015

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Timothy Claude Garnham als Geschäftsführer am 28. Jan. 2015

    2 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Alexander Wilson Lamont als Direktor am 31. Dez. 2014

    3 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Paul Jonathan Goswell als Direktor am 31. Dez. 2014

    3 SeitenAP01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 42 Wigmore Street London W1U 2RY zum 40 Queen Anne Street London W1G 9EL am 02. März 2015

    2 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Nov. 2014

    Kapitalaufstellung am 04. Nov. 2014

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital06. Nov. 2013

    Kapitalaufstellung am 06. Nov. 2013

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    16 SeitenAA

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Juni 2012 bis 31. Dez. 2012

    1 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Wer sind die Geschäftsführer von OMD PROPERTY (HOLBORN) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    COHEN, Michael George
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor Lansdowne House
    England
    Geschäftsführer
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor Lansdowne House
    England
    EnglandBritish153509790001
    GOSWELL, Paul Jonathan
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor Lansdowne House
    Uk
    Geschäftsführer
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor Lansdowne House
    Uk
    United KingdomBritish60475780003
    LAMONT, Alexander Wilson
    New Burlington Street
    W1S 3BE London
    6th Floor 10
    Uk
    Geschäftsführer
    New Burlington Street
    W1S 3BE London
    6th Floor 10
    Uk
    EnglandBritish158518680001
    PIPER, James Anthony
    New Burlington Street
    W1S 3BE London
    Ares Management, 10
    England
    Geschäftsführer
    New Burlington Street
    W1S 3BE London
    Ares Management, 10
    England
    EnglandBritish163685440001
    WAGMAN, Colin Barry
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor, Lansdowne House
    England
    Geschäftsführer
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor, Lansdowne House
    England
    EnglandBritish189915990001
    EZEKIEL, Ivan Howard
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Sekretär
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    British56155670004
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    COSTER, Paul Antony
    Garth Steading
    Walpole Avenue
    CR5 3PN Chipstead
    Surrey
    Geschäftsführer
    Garth Steading
    Walpole Avenue
    CR5 3PN Chipstead
    Surrey
    British35406400003
    EZEKIEL, Ivan Howard
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    EnglandBritish56155670004
    GARNHAM, Timothy Claude
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    EnglandBritish66502160002
    GARRARD, David Eardley, Sir
    29 Orchard Court
    Portman Square
    W1H 9PA London
    Geschäftsführer
    29 Orchard Court
    Portman Square
    W1H 9PA London
    EnglandBritish76373440001
    HASAN, Salmaan
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    United KingdomBritish106868320001
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    ROSENFELD, Andrew Ian
    14 Chemin Vert
    Vandoeuvres
    Ch-1253
    Geneva
    Switzerland
    Geschäftsführer
    14 Chemin Vert
    Vandoeuvres
    Ch-1253
    Geneva
    Switzerland
    SwitzerlandBritish118467060001

    Hat OMD PROPERTY (HOLBORN) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 21. Juli 2004
    Geliefert am 23. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from omd property limited and/or the new owners to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 15. Jan. 2003
    Erworben am 21. Juli 2004
    Geliefert am 11. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The beneficial interest in the l/h property k/a 90 high holborn london, the undertaking and all property and assets of 90 high holborn L.P. the legal estate in the l/h property k/a 90 high holborn london, the undertaking and all property and assets of omd holborn nominee company limited and omd holborn second nominee company limited.
    Berechtigte Personen
    • Minerva Corporation PLC
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2004Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 15. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 15. Jan. 2003
    Erworben am 21. Juli 2004
    Geliefert am 11. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The beneficial interest in the l/h property k/a 90 high holborn london, the undertaking and all property and assets of 90 high holborn L.P. the legal estate in the l/h property k/a 90 high holborn london, the undertaking and all property and assets of omd holborn nominee company limited and omd holborn second nominee company limited.
    Berechtigte Personen
    • Minerva PLC
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2004Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 15. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 15. Jan. 2003
    Erworben am 21. Juli 2004
    Geliefert am 11. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The beneficial interest in the l/h property k/a 90 high holborn, london, the undertaking and all property and assets present and future of 90 high holborn L.P.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2004Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 15. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 15. Jan. 2003
    Erworben am 21. Juli 2004
    Geliefert am 11. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The legal estate in the l/h property k/a 90 high holborn, london, the undertaking and all property and assets present and future of omd holborn nominee company limited and omd holborn second nominee company limited.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2004Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 15. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 15. Jan. 2003
    Geliefert am 28. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities due or to become due from the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Minerva Corporation PLC
    Transaktionen
    • 28. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 15. Jan. 2003
    Geliefert am 28. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities due or to become due from the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Minerva PLC
    Transaktionen
    • 28. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 15. Jan. 2003
    Geliefert am 24. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee acting as trustee for the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the l/h property k/a 90 high holborn, london,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 24. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of variation of charge and confirmation
    Erstellt am 23. März 2001
    Geliefert am 04. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All indebtedness or any of the present or future actual or contingent obligations or liabilities of the obligors to the beneficiaries under any finance document (all as defined)
    Kurze Angaben
    The company charges to agent as trustee for the beneficiaries by way of first fixed charge its interest in any money at the date of the deed or at any time thereafter standing to the credit of the projected payment account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bhf-Bank Ag (The "Agent")
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mezzanine debenture
    Erstellt am 28. Juli 2000
    Geliefert am 10. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All indebtedness or any of the present or future, actual or contingent obligations or liabilities of the borrower (as defined) to the chargee under any finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bhf-Bank Ag
    Transaktionen
    • 10. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. Juli 2000
    Geliefert am 10. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All indebtedness or any of the present or future, actual or contingent obligations or liabilities of the obligors (as defined) to the beneficiaries (as defined) under any finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bhf-Bank Ag
    Transaktionen
    • 10. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture made between the company and omd holborn limited acting for (1) themselves and (2) as general partners on behalf of 90 high holborn LP (the borrower) (in each capacity the "chargors" and each a "chargor") and omd holdings limited (the lender)
    Erstellt am 28. Juli 2000
    Geliefert am 04. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent whether owed jointly severally or in any other capacity whatsoever and whether originally incurred by the chargors or by some other person) of the chargors to the lender
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Omd Holdings Limited
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat OMD PROPERTY (HOLBORN) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    17. Nov. 2015Beginn der Liquidation
    07. März 2017Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Asher Miller
    David Rubin & Partners
    26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London
    Praktiker
    David Rubin & Partners
    26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0