GALLEONDEAL LIMITED
Überblick
Unternehmensname | GALLEONDEAL LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04018426 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GALLEONDEAL LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich GALLEONDEAL LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 50 Aylesbury Road Aston Clinton HP22 5AH Aylesbury Buckinghamshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GALLEONDEAL LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Nov. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GALLEONDEAL LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juni 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2021 | 6 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juni 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2020 | 5 Seiten | AA | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2019 | 6 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 2 Seiten | CS01 | ||
Antrag auf administrative Wiederherstellung | 3 Seiten | RT01 | ||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Beendigung der Bestellung von Nigel Harborough Brunskill als Geschäftsführer am 01. Aug. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juni 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2018 | 7 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juni 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2017 | 8 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2016 | 7 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2015 | 7 Seiten | AA | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 |
Wer sind die Geschäftsführer von GALLEONDEAL LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORGAN, Colin Graham | Sekretär | Aylesbury Road Aston Clinton HP22 5AH Aylesbury 50 Buckinghamshire United Kingdom | 185219310001 | |||||||
MILLER, David Charles Lawson | Geschäftsführer | Denner Hill Farm Denner Hill HP16 0HZ Great Missenden Buckinghamshire | England | British | Civil Servant | 188013970001 | ||||
LAKHANI, Amit | Sekretär | The Gate House Barkham Road RG41 4TG Wokingham Berkshire | British | Financial Controller | 52725580003 | |||||
MORIARTY, Michelle Christine | Sekretär | Apollo House 56 New Bond Street W1Y 0SX London | British | 59245990001 | ||||||
PIPE, Christopher John | Sekretär | 91 Green Hill HP13 5QB High Wycombe Bucks | British | Accountant | 77273330001 | |||||
HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||
ANDERSON, David Joseph Alfred | Geschäftsführer | 9 Tithe Meadows GU25 4EU Virgina Water Surrey | England | British | Company Director | 92518640001 | ||||
BRUNSKILL, Nigel Harborough | Geschäftsführer | Aylesbury Road Aston Clinton HP22 5AH Aylesbury 50 Buckinghamshire United Kingdom | England | British | Land Director | 102857260001 | ||||
GRAHAM WATSON, Frederick Paul | Geschäftsführer | Falconers Sincox Lane Shipley RH13 8PT Horsham West Sussex | United Kingdom | British | Finance Director | 80482690001 | ||||
JOHNSON, Dennis Arthur | Geschäftsführer | The Gleanings, Gleanings Mews 58 St Margaret Street ME1 1UF Rochester Kent | England | British | Accountant | 12299810003 | ||||
MCKENZIE, Clive William Price | Geschäftsführer | 3 Warren Lodge Drive KT20 6QN Kingswood Surrey | United Kingdom | British | Solicitor | 78528180001 | ||||
O'CONNELL, John Richard | Geschäftsführer | Apollo House 56 New Bond Street W1Y 0SX London | British | Solicitor | 59246060001 | |||||
PILKINGTON, Richard Michael | Geschäftsführer | 34 Westcombe Park Road Blackheath SE3 7RB London | United Kingdom | British | Director | 88322980002 | ||||
HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GALLEONDEAL LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
---|---|---|---|
Mr David Charles Lawson Miller | 06. Apr. 2016 | Aylesbury Road Aston Clinton HP22 5AH Aylesbury 50 Buckinghamshire | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
|
Hat GALLEONDEAL LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 19. Okt. 2007 Geliefert am 25. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 17. Okt. 2007 Geliefert am 24. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a artillery mansions greycoat place & victoria street london t/no's NGL788697 and NGL751608. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental deed | Erstellt am 03. Mai 2002 Geliefert am 23. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/Hold property known as artillery mansions,south courtyard,victoria st,london SW1 and comprising the property known as part of artillery mansions,greycoat place,london SW1; 788697; property known as part of artillery mansions,victoria st,london; ngl 751608; all fixed plant machinery and fixtures thereon; the proceeds of sale thereof and benefit of any covenants for title and all rights,claims and interest in any policies of insurance; specific equitable charge over all estates or interests in any freehold or leasehold property; first fixed charge over all sums standing to the credit of any account,sales proceeds account and the development account; all book and other debts and floating charge over all undertaking,rights,assets and revenues whatsoever. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 03. Mai 2002 Geliefert am 09. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from artillery mansions limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage all that l/h property known as artillery mansions, south courtyard, victoria street, london,SW1 comprising;(a) the property known as part of artillery mansions, greycoat place, london SW1 t/n NGL799697; and (b) the property known as part of artillery mansions, victoria street, london t/n NGL751608. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 20. Okt. 2000 Geliefert am 31. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the loan agreement, the hedging arrangements or the security documents | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0