QUADRIGA HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | QUADRIGA HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04019893 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von QUADRIGA HOLDINGS LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich QUADRIGA HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Devonshire House 60 Goswell Road EC1M 7AD London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von QUADRIGA HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für QUADRIGA HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung | 16 Seiten | AM23 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 16 Seiten | AM10 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 19 Seiten | AM10 | ||||||||||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | AM19 | ||||||||||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 3 Seiten | AM06 | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 3 Seiten | AM03 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 3 Seiten | AM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Forum 1 Station Road Theale Berkshire RG7 4RA zum Devonshire House 60 Goswell Road London EC1M 7AD am 07. März 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Seale Alonzo Moorer as a person with significant control on 09. Juli 2016 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher John Maityard als Geschäftsführer am 26. Juni 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Gerard Naro als Geschäftsführer am 07. März 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Christopher John Maityard als Direktor am 13. Mai 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 040198930008, erstellt am 18. Dez. 2015 | 112 Seiten | MR01 | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 16 Seiten | MA | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2015 | 35 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Isabelle Sarah Kirk als Sekretär am 21. Aug. 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 040198930007, erstellt am 07. Aug. 2015 | 55 Seiten | MR01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2016 bis 31. Dez. 2015 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Ernennung von Mr James Gerard Naro als Direktor am 09. Juli 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von QUADRIGA HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOORER, Seale Alonzo | Geschäftsführer | Station Road RG7 4RA Theale Forum 1 Berkshire England | United States | American | 199604390001 | |||||
| AULT, Isabel Mary Katherine | Sekretär | 87 Shaftesbury Road SP2 0DU Wilton Jasmine Cottage Wiltshire United Kingdom | 128525910001 | |||||||
| DALLISON, Adrian John | Sekretär | 41 Common Hill BA14 6EE Steeple Ashton Wiltshire | British | 52541710002 | ||||||
| JENKINS, Elisabeth Anne | Sekretär | 50a Cyril Mansions Prince Of Wales Drive SW11 4HW London | British | 72837960002 | ||||||
| KIRK, Isabelle Sarah | Sekretär | Station Road RG7 4RA Theale Forum 1 Berkshire United Kingdom | 199579500001 | |||||||
| MOHINDRA, Ravi Kumar | Sekretär | 12 Falcon House Gardens Woolton Hill RG20 9UQ Newbury Berkshire | British | 122688990001 | ||||||
| MORDECAI, Laura Rose | Sekretär | Flat 15 23 Chartfield Avenue SW15 6DX Putney London | British | 65797190002 | ||||||
| WATSON, David Andrew | Sekretär | 58 Shepherds Lane Caversham Heights RG4 7JL Reading | British | 52990930003 | ||||||
| DAVID VENUS & COMPANY LLP | Sekretär | Hersham Road KT12 1RZ Walton-On-Thames 42-50 Surrey United Kingdom | 131429630001 | |||||||
| TJG SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 900018860001 | |||||||
| ANDRADI, Benedict Pius Marilaan | Geschäftsführer | 16 Knole Way TN13 3RS Sevenoaks Kent | England | British | 82360580001 | |||||
| AUSTIN, Terry Alan | Geschäftsführer | The Barn Handpost Farm Barkham RG41 4TN Wokingham Berkshire | British | 82652640001 | ||||||
| BARDEN-STYLIANOU, Stelios Stephen | Geschäftsführer | 47 Carlyle Court Chelsea Harbour SW10 0UQ London | England | British | 125782940001 | |||||
| BUDIE, Marcus Johanes Theodorus | Geschäftsführer | Portsmouth Road KT10 9AD Esher Thames House Surrey United Kingdom | United Kingdom | Dutch | 105980560001 | |||||
| CRABB, Ian Denis | Geschäftsführer | Portsmouth Road KT10 9AD Esher Thames House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 70017710003 | |||||
| DUNCAN, Fraser Scott | Geschäftsführer | 25 Kippington Road TN13 2LJ Sevenoaks Kent | England | British | 57508670001 | |||||
| FORBES, Alistair Robert Ballantyne | Geschäftsführer | Spring House Browns Lane Great Bedwyn SN8 3LR Marlborough Wiltshire | United Kingdom | British | 168893980001 | |||||
| GALLAGHER, Patrick James | Geschäftsführer | Fulling Mill The Weir RG28 7RA Whitchurch Hampshire | British | 77355310002 | ||||||
| HANDS, Guy | Geschäftsführer | 90 Kippington Road TN13 2LL Sevenoaks Kent | British | 2519120002 | ||||||
| HOWES, Lewis Verlie | Geschäftsführer | Gisburn 50 Woodham Waye GU21 5SJ Woking Surrey | England | British | 62776210004 | |||||
| HULL, Jonathan | Geschäftsführer | Portsmouth Road KT10 9AD Esher Thames House Surrey United Kingdom | England | British | 116761670001 | |||||
| LEVY, Lionel Anthony | Geschäftsführer | 29 Pangbourne Drive Stanmore HA7 4RA Middlesex | United Kingdom | British | 105270770001 | |||||
| MAITYARD, Christopher John | Geschäftsführer | Station Rd RG7 4RA Theale Forum 1 Berkshire England | England | British | 210342460001 | |||||
| MARSH, Gary Neil | Geschäftsführer | Forum 1 Station Road RG7 4RA Theale Berkshire | England | British | 122518590001 | |||||
| MILLER, Louise Ann | Geschäftsführer | Pound Cottages High Street RG8 9JH Streatley 6 Berkshire United Kingdom | British | 127375160002 | ||||||
| NARO, James Gerard | Geschäftsführer | Station Road RG7 4RA Theale Forum 1 Berkshire England | United States | American | 199606110001 | |||||
| NWANA, Hyacinth Sama, Dr | Geschäftsführer | 19 York Gardens KT12 3EP Walton On Thames Surrey | British | 53962580002 | ||||||
| PATEL, Harnish Natubhai | Geschäftsführer | High Pines Milbrook KT10 9EJ Esher Surrey | British | 90038150001 | ||||||
| SPRUZEN, David Andrew | Geschäftsführer | Homewood The Avenue, Farnham Common SL2 3JY Slough Bucks | England | British | 110080200001 | |||||
| SUNDERLAND, Neil Vernon | Geschäftsführer | Zuercherstrasse 80a Uitikon 8142 Switzerland | Swiss | 44808550001 | ||||||
| TAGLIAFERRI, Mark Lee | Geschäftsführer | Flat 2 105 Cadogan Gardens SW3 2RF London | England | British,American | 106792270001 | |||||
| TATARYN, Myron Anton | Geschäftsführer | The Leys The Street NR35 2BJ Topcroft Suffolk | United Kingdom | British | 105980670001 | |||||
| TAYLOR, Roger David | Geschäftsführer | Forum 1 Station Road RG7 4RA Theale Berkshire | United Kingdom | British | 73602910003 | |||||
| TYRRELL, Patricia Valentine | Geschäftsführer | Le Bas Marais Na Lliers La Vendee 85370 France | British | 105980890001 | ||||||
| WAKE, Lorna | Geschäftsführer | Forum 1 Station Road RG7 4RA Theale Berkshire | United Kingdom | British | 210114660001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei QUADRIGA HOLDINGS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr Seale Alonzo Moorer | 09. Juli 2016 | 60 Goswell Road EC1M 7AD London Devonshire House | Nein | ||||||||||
Nationalität: American Staatsangehörigkeit: United States | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Exceptional Innovation B.V. | 06. Apr. 2016 | Hoogoorddreef 15 1101 Ba Amsterdam Amerika Building Netherlands | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat QUADRIGA HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 18. Dez. 2015 Geliefert am 23. Dez. 2015 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 07. Aug. 2015 Geliefert am 18. Aug. 2015 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 05. Dez. 2013 Geliefert am 06. Dez. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 11. Feb. 2010 Geliefert am 12. Feb. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security between, inter alia, the chargor and the security agent (as defined)(the "security document") | Erstellt am 03. Dez. 2001 Geliefert am 19. Dez. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future moneys, debts and liabilities due, owing or incurred by the chargor to any finance party under or in connection with any finance document (all terms as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security document between the chargors (as defined) and the security agent | Erstellt am 03. Dez. 2001 Geliefert am 19. Dez. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company (the "chargor") to any finance party (as defined) under or in connection with any finance document (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of pledge of registered shares between the pledgor the pledgee and the company (as defined) executed outside the united kingdom and comprising property situated there | Erstellt am 14. März 2001 Geliefert am 28. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Any and all of the present and future monetary obligations and liabilities of the pledgor to the pledgee (including the parallel debt) whether due and payable or not and whether contingent or not under or pursuant to the deed (the secured obligations)(as defined) | |
Kurze Angaben As security for the secured obligations the pledgor agrees to grant and grants to the pledgee the right of the pledge and the pledgee accepts the right of the pledge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Sept. 2000 Geliefert am 03. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of the obligors to any finance party under the finance documents or any hedging creditor under the hedging documents | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage all shares and all related rights accruing to the shares and all interest in the shares all moneys standing to the credit of any account all book and other debts the goodwill uncalled capital and by way of floating charge all assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat QUADRIGA HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0