LOGDEAN LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LOGDEAN LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04021435 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LOGDEAN LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich LOGDEAN LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 60 High Street Wimbledon SW19 5EE London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LOGDEAN LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LOGDEAN LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Juni 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2021 | 6 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Ashok Kumar Tanna als Sekretär am 22. Juni 2021 | 1 Seiten | TM02 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2020 | 6 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Juni 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Solomon Baroukh am 31. Jan. 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||
Change of details for Dba Advisors Ltd as a person with significant control on 31. Jan. 2020 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Munro House Portsmouth Road Cobham Surrey KT11 1PP United Kingdom zum 60 High Street Wimbledon London SW19 5EE am 14. Jan. 2020 | 1 Seiten | AD01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Apr. 2019 | 6 Seiten | AA | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 9 Bridle Close Surbiton Road Kingston upon Thames Surrey KT1 2JW zum Munro House Portsmouth Road Cobham Surrey KT11 1PP am 10. Okt. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Solomon Baroukh am 02. Sept. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Juni 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2018 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2017 | 2 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Notification of Dba Advisors Ltd as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 1 Seiten | PSC02 | ||
Notification of Flodrive Holdings Ltd as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 1 Seiten | PSC02 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2016 | 5 Seiten | AA | ||
Erfüllung der Belastung 040214350016 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 040214350018 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von LOGDEAN LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAROUKH, David Solomon | Geschäftsführer | High Street Wimbledon SW19 5EE London 60 England | England | British | 149269770030 | |||||
| KHALASTCHI, Anthony Menashi | Geschäftsführer | Court Lodge 48 Sloane Square SW1W 8AT London 3 United Kingdom | United Kingdom | British | 54709980002 | |||||
| KHALASTCHI, Frank | Geschäftsführer | Court Lodge 48 Sloane Square SW1W 8AT London 3 United Kingdom | United Kingdom | British | 96107780003 | |||||
| KHALASTCHI, Peter Salim David | Geschäftsführer | Court Lodge 48 Sloane Square SW1W 8AT London 3 United Kingdom | United Kingdom | British | 105027750001 | |||||
| KHALASTCHI, Peter Salim David | Sekretär | Court Lodge 48 Sloane Square SW1W 8AT London 3 United Kingdom | British | 105027750001 | ||||||
| TANNA, Ashok Kumar | Sekretär | Court Lodge 48 Sloane Square SW1W 8AT London 3 United Kingdom | British | 98980620002 | ||||||
| LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||
| BAROUKH, Fowzi | Geschäftsführer | 1 High Coombe Place Warren Cuttings KT2 7HH Kingston Upon Thames Surrey | British | 16515080001 | ||||||
| LONDON LAW SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001500001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LOGDEAN LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flodrive Holdings Ltd | 06. Apr. 2016 | Grafton Way W1T 5DS London 68 England | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
| Dba Advisors Ltd | 06. Apr. 2016 | High Street Wimbledon SW19 5EE London 60 England | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
Hat LOGDEAN LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 10. Dez. 2014 Geliefert am 12. Dez. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 17. Nov. 2014 Geliefert am 18. Nov. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 15. Okt. 2014 Geliefert am 17. Okt. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The fir tre public house 170 firs lane leigh t/no GM798227, the vine 8 middle cross street stoke on trent t/no SF75406, the duke of york 124 bolton street chorley t/no LA774877 and 13 high street christchurch dorset t/no DT80665 and DT336712. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 16. Dez. 2005 Geliefert am 21. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property k/a 13 high street, christchurch DT80665. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 30. März 2005 Geliefert am 05. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of floating charge all the undertaking property and assets of the company present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment of rental income | Erstellt am 30. März 2005 Geliefert am 05. Apr. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The company assigns to the society the exclusive rights to receive all rents in respect of the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Commercial mortgage deed | Erstellt am 30. März 2005 Geliefert am 05. Apr. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property k/a 19 valentine close gillingham business park gillingham kent t/no K842134 the goodwill, the full benefit of all licences consents permissions and agreements, any shareholding and all estates or interests in any land. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Commercial mortgage deed | Erstellt am 11. Feb. 2005 Geliefert am 24. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Halfords ings road wakefield t/no WYK402610. The goodwill, the full benefit of all licences consents permissions and agreements, any shareholding and all estates or interests in any land. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 11. Feb. 2005 Geliefert am 24. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of floating charge all the undertaking property and assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment of rental income | Erstellt am 11. Feb. 2005 Geliefert am 24. Feb. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All receive all rents in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 12. Jan. 2005 Geliefert am 17. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a the vine, 8 middlecross street, stoke on trent, t/no SF75406. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 12. Jan. 2005 Geliefert am 17. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a the duke of york, 124 bolton street, chorley, t/no LA774877. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 12. Jan. 2005 Geliefert am 17. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a 170 and 174-180 (even) firs lane, leigh, t/no GM798228 & GM686766. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 20. Sept. 2004 Geliefert am 21. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a the wargrave inn 448 wargrave road newton-le-willows merseyside. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 04. Sept. 2002 Geliefert am 12. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Land and buildings on the east side of queens road sheffield south yorkshire title number SYK163279. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 04. Sept. 2002 Geliefert am 12. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Land and buildings on the east side of queens road,sheffield,south yorkshire; syk 163279. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 11. Okt. 2000 Geliefert am 18. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a mecca bingo site queens road sheffield south yorkshire t/no: SYK163279. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 11. Okt. 2000 Geliefert am 18. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0