REDCENTRIC MS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | REDCENTRIC MS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04027996 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von REDCENTRIC MS LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich REDCENTRIC MS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Central House Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate North Yorkshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von REDCENTRIC MS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
MAXIMA MANAGED SERVICES LIMITED | 13. Juni 2006 | 13. Juni 2006 |
HANSTON TECHNOLOGY PARTNERS LIMITED | 06. Juli 2000 | 06. Juli 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von REDCENTRIC MS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für REDCENTRIC MS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 09. Dez. 2020
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Juli 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ungeprüfter Jahresabschluss, gekürzt, bis 31. März 2020 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Dean Anthony Barber als Geschäftsführer am 03. Apr. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Dean Anthony Barber als Direktor am 02. Sept. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juli 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ungeprüfter Jahresabschluss, gekürzt, bis 31. März 2019 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Brotherton als Sekretär am 03. Sept. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Ernennung von Harneet Jagpal als Sekretär am 03. Sept. 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juli 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Notification of Redcentric Holdings Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||||||
Withdrawal of a person with significant control statement on 27. März 2018 | 2 Seiten | PSC09 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Fraser St John Fisher als Geschäftsführer am 20. Okt. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juli 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016 | 10 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Peter James Brotherton als Direktor am 28. Nov. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Peter Brotherton als Sekretär am 28. Nov. 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von REDCENTRIC MS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGPAL, Harneet | Sekretär | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | 250198300001 | |||||||
BROTHERTON, Peter James | Geschäftsführer | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | England | British | Chartered Accountant | 116701310002 | ||||
ANDREWS, Linda Margaret | Sekretär | 61 Ravenswood Drive Shawlands G41 3UH Glasgow | British | Finance Director | 72431750001 | |||||
BROTHERTON, Peter | Sekretär | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | 220552820001 | |||||||
BUSBY, Nicola | Sekretär | Pheasant Way GL7 1BL Cirencester 6 Gloucestershire United Kingdom | British | 134382880001 | ||||||
COLEMAN, Timothy James | Sekretär | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | 210014180001 | |||||||
CROFT, Estelle Louise | Sekretär | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | 195008180001 | |||||||
HARRISON, Irene Lesley | Bevollmächtigter Sekretär | Fy Mwthin 22 Merthyr Road Tongwynlais CF15 7LH Cardiff South Glamorgan | British | 900003790001 | ||||||
HURLSTONE, Gary | Sekretär | 4 Firview GU30 7JD Liphook Hampshire | British | Business Development Director | 31729020003 | |||||
MYHILL, Paul Harvey | Sekretär | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire England | 184975410001 | |||||||
CLIVE MATHIAS COMPANY SECRETARY LIMITED | Sekretär | 29 Rhodfa Sweldon CF62 5AD Barry Vale Of Glamorgan | 67391590001 | |||||||
ANDREWS, Linda Margaret | Geschäftsführer | 61 Ravenswood Drive Shawlands G41 3UH Glasgow | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 72431750001 | ||||
BARBER, Dean Anthony | Geschäftsführer | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | England | British | Chief Financial Officer | 230739040001 | ||||
BATTING, Tony John | Geschäftsführer | 3 Yewhurst Close Twyford RG10 9PW Reading | British | Technical Director | 121031560001 | |||||
COLEMAN, Timothy James | Geschäftsführer | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire England | United Kingdom | British | Director | 163698620001 | ||||
FISHER, Fraser St John | Geschäftsführer | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | England | British | Director | 201664700001 | ||||
GAUGHAN, John Christopher | Geschäftsführer | Flat 5 16 Eldon Road RG1 4DL Reading Berkshire | British | Sales Director | 71089670001 | |||||
HALLETT, Peter John | Geschäftsführer | Cambridge Business Park, Cowley Road CB4 0WZ Cambridge Newton House United Kingdom | United Kingdom | British | Cfo | 20621770002 | ||||
HARRISON, Kelvin Frank | Geschäftsführer | Turners Hall Farm Mackeyre End AL5 5DU Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | Chartered Engineer | 152236760001 | ||||
HURLSTONE, Gary | Geschäftsführer | 4 Firview GU30 7JD Liphook Hampshire | British | Commercial Director | 31729020003 | |||||
MEMORY, David William | Geschäftsführer | 5 Holbein Gate HA6 3SH Northwood Middlesex | England | English | Accountant | 20274060001 | ||||
PRESCOTT, Jeremy Malcolm | Geschäftsführer | 142 Court Lane SE21 7EB London | United Kingdom | British | Director | 85206230001 | ||||
TAYLOR, John James | Geschäftsführer | Ben Sayers Park North Berwick EH39 5PT Edinburgh 19 East Lothian | Scotland | British | Charterd Accountant | 138774840001 | ||||
WEAVER, Anthony Charles | Geschäftsführer | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire England | United Kingdom | British | It Services Consultant And Company Director | 153397180001 | ||||
BUSINESS INFORMATION RESEARCH & REPORTING LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Crown House 64 Whitchurch Road CF14 3LX Cardiff | 900005500001 | |||||||
CLIVE MATHIAS NOMINEE LIMITED | Geschäftsführer | 29 Rhodfa Sweldon CF62 5AD Barry The Vale Of Glamorgan | 67325330001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei REDCENTRIC MS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redcentric Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für REDCENTRIC MS LIMITED?
Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
---|---|---|
06. Juli 2016 | 06. Juli 2016 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Hat REDCENTRIC MS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 01. Apr. 2015 Geliefert am 08. Apr. 2015 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Lease over part of first floor, john stow house, bevis marks, london EC3A 7JB.. Lease over unit 2 commerce park, brunel road, theale, berkshire, RG7 4AB. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 05. Dez. 2013 Geliefert am 12. Dez. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 08. Apr. 2013 Geliefert am 11. Apr. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Accession deed to a debenture | Erstellt am 09. Nov. 2012 Geliefert am 21. Nov. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to each present and future secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 02. Juli 2008 Geliefert am 17. Juli 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of accession and charge | Erstellt am 26. Sept. 2005 Geliefert am 29. Sept. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any of the chargors to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 27. Feb. 2001 Geliefert am 06. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0