PAN EUROPEAN SEAFOODS UK LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PAN EUROPEAN SEAFOODS UK LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04032203 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PAN EUROPEAN SEAFOODS UK LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich PAN EUROPEAN SEAFOODS UK LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 8 Princes Parade L3 1QH Liverpool Merseyside |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PAN EUROPEAN SEAFOODS UK LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für PAN EUROPEAN SEAFOODS UK LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für PAN EUROPEAN SEAFOODS UK LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. Dez. 2015 | 6 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Ross House Wickham Road Grimsby North East Lincolnshire DN31 3SW zum 8 Princes Parade Liverpool Merseyside L3 1QH am 07. Mai 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Hamish Forbes als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Jenny Nancy Loncaster als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Ernennung von Mr Malcolm Herbert Lofts als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Leadbeater als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Hamish Drummond Forbes als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Britton als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 18 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2012 bis 30. Sept. 2012 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 15 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PAN EUROPEAN SEAFOODS UK LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Town Hall Square DN31 1HE Grimsby New Oxford House North East Lincolnshire United Kingdom |
| 900013350001 | ||||||||||
| LOFTS, Malcolm Herbert | Geschäftsführer | Princes Parade L3 1QH Liverpool 8 Merseyside | England | British | 177239110001 | |||||||||
| LONCASTER, Jenny Nancy | Geschäftsführer | Princes Parade L3 1QH Liverpool 8 Merseyside | England | British | 205633180001 | |||||||||
| GAULT, Sandra | Sekretär | 25 Pitblae Gardens AB43 7BH Fraserburgh Aberdeenshire | British | 61174690002 | ||||||||||
| TM COMPANY SERVICES LIMITED | Sekretär | Edinburgh Quay 133 Fountainbridge EH3 9AG Edinburgh Midlothian | 37914570001 | |||||||||||
| ANDERSON, Stuart Anthony Kidston | Geschäftsführer | Avenue Moscici 5 1180 Brussels FOREIGN Belgium | British | 36315750001 | ||||||||||
| BRITTON, Christopher Paul | Geschäftsführer | Park Grange Main Street LS22 4AP Sicklinghall West Yorkshire | United Kingdom | British | 127835580001 | |||||||||
| FORBES, Hamish Drummond | Geschäftsführer | Ross House Wickham Road DN31 3SW Grimsby North East Lincolnshire | England | British | 66295550001 | |||||||||
| HARKJAER, Per | Geschäftsführer | Oakridge House 6 Montrose Gardens Oxshott KT22 0UU Leatherhead Surrey | England | Danish | 127032620001 | |||||||||
| HAZELDEAN, James William | Geschäftsführer | 29/5 Inverleith Place EH3 5QD Edinburgh | British | 10359650003 | ||||||||||
| LAINE, Jean Claude Robert | Geschäftsführer | Chemin De Montan Mont Brun-Lauragais 31450 France | French | 77572690001 | ||||||||||
| LEADBEATER, Stephen Paul | Geschäftsführer | Allt Nam Breac Mill Lane, Legbourne LN11 8LT Louth Lincolnshire | England | British | 84487230001 | |||||||||
| MACIELINSKI, Peter Martin | Geschäftsführer | New Haven Church Road, Cookham SL6 9PG Maidenhead Berkshire | England | British | 68699160001 | |||||||||
| PARKER, Michael | Geschäftsführer | Humber Lodge Old Post Office Lane South Ferriby DN18 6HH Barton Upon Humber N E Lincolnshire | United Kingdom | British | 2785890001 | |||||||||
| WRIGHT, Robin James Morrison | Geschäftsführer | 7 Buckland Gate Wexham SL3 6LS Slough Berkshire | United Kingdom | British | 71513490001 | |||||||||
| REYNARD NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | Edinburgh Quay 133 Fountainbridge EH3 9AG Edinburgh Midlothian | 40850920001 | |||||||||||
| TM COMPANY SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | Edinburgh Quay 133 Fountainbridge EH3 9AG Edinburgh Midlothian | 37914570001 |
Hat PAN EUROPEAN SEAFOODS UK LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 23. Okt. 2008 Geliefert am 01. Nov. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share pledge | Erstellt am 22. Okt. 2008 Geliefert am 05. Nov. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Its whole right, title, interest and benefit in and to the charged assets see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Sept. 2008 Geliefert am 04. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. März 2007 Geliefert am 31. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. März 2006 Geliefert am 25. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Dez. 2005 Geliefert am 17. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All material premises together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security accession deed | Erstellt am 30. Juni 2004 Geliefert am 10. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben With full title guarantee, both present and future from time to time owned by it or in which it has an interest but excluding the scottish charged assets, the scottish property and the northern irish property; all material premises together with all buildings and fixtures; by way of equitable mortgage all the subsidiary shares and investments and corresponding distribution rights;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 04. Aug. 2000 Geliefert am 15. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or as principal debtor guarantor surety or otherwise or as the equivilent obligor under the laws of any other jurisdiction) of each obligor to the security trustee and the secured parties under the financing documents | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat PAN EUROPEAN SEAFOODS UK LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0