ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED

ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04033332
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED?

    • Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BROADOAKS VCT LIMITED28. Sept. 200028. Sept. 2000
    HILLGATE (181) LIMITED13. Juli 200013. Juli 2000

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär am 09. Okt. 2012

    1 SeitenTM02

    Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs

    6 Seiten1.4

    Beendigung der Bestellung von Timothy James Bolot als Geschäftsführer am 17. Aug. 2012

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital17. Juli 2012

    Kapitalaufstellung am 17. Juli 2012

    • Kapital: GBP 11,190
    SH01

    Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs

    4 Seiten1.1

    Beendigung der Bestellung von William James Buchan als Geschäftsführer am 15. Nov. 2011

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von David Andrew Smith als Geschäftsführer am 01. Nov. 2011

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Stephen Jonathan Taylor als Direktor am 26. Okt. 2011

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Timothy James Bolot als Direktor am 26. Okt. 2011

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010

    27 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    legacy

    7 SeitenMG01

    Beendigung der Bestellung von William Mcleish als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Richard Midmer als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Enter agreements 14/05/2010
    RES13

    Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Sept. 2009

    24 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr David Andrew Smith am 07. Jan. 2010

    2 SeitenCH01

    Ernennung eines Direktors

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von David Smith als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    GAIN, Jonathan Mark
    9 Nash Place
    HP10 8ES Penn
    Buckinghamshire
    Sekretär
    9 Nash Place
    HP10 8ES Penn
    Buckinghamshire
    British47508930005
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Sekretär
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158304380001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Sekretär
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Sekretär
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    British174231320001
    HILLGATE SECRETARIAL LIMITED
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    Bevollmächtigter Sekretär
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    900018850001
    BETTUM, Ole
    54 Primrose Gardens
    NW3 4TP London
    Geschäftsführer
    54 Primrose Gardens
    NW3 4TP London
    EnglandNorwegian50551730002
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    BURGESS, Richard John
    54 Manor Road
    SM2 7AG Cheam
    Surrey
    Geschäftsführer
    54 Manor Road
    SM2 7AG Cheam
    Surrey
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)British35427700001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Geschäftsführer
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    FARMER, Nicholas John
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish124228290001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    FRYER, Martin
    The Badgers
    Cats Lane
    CO10 2SF Sudbury
    Suffolk
    Geschäftsführer
    The Badgers
    Cats Lane
    CO10 2SF Sudbury
    Suffolk
    British72517560003
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Geschäftsführer
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish110640170001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Geschäftsführer
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    MURRAY, Andrew John
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    British110957990001
    ROBINSON, Anthony Leake
    The Rose Garden
    Orchehill Avenue
    SL9 8QE Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    The Rose Garden
    Orchehill Avenue
    SL9 8QE Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British48323880002
    ROGERS, Michael Greig
    1 Jenningsbury Court
    London Road
    SG13 7NS Hertford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    1 Jenningsbury Court
    London Road
    SG13 7NS Hertford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish107156650001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Geschäftsführer
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Geschäftsführer
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Geschäftsführer
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritish77274540003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    Geschäftsführer
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    United KingdomBritish147997950001
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish147997950001
    HILLGATE NOMINEES LIMITED
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    900018840001
    HILLGATE SECRETARIAL LIMITED
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    900018850001

    Hat ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental legal mortgage
    Erstellt am 06. Mai 2011
    Geliefert am 20. Mai 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Broad oaks gaul road march t/no CB295973 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 20. Mai 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 29. Feb. 2008
    Geliefert am 14. März 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 14. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 06. Juni 2007
    Geliefert am 19. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 19. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Juli 2006
    Geliefert am 20. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 20. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. Apr. 2005
    Geliefert am 15. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 15. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Sept. 2004
    Geliefert am 28. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 28. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Apr. 2004
    Geliefert am 11. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent)
    Transaktionen
    • 11. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. Sept. 2000
    Geliefert am 19. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan stock deed whereby the company issued to the lender 14% secured stock loan
    Kurze Angaben
    Land at gaul road march cambridgeshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Venture Capital Trust PLC
    Transaktionen
    • 19. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Juni 2012Datum der Sitzung zur Genehmigung des CVA
    20. Aug. 2012Datum des Abschlusses oder der Beendigung des CVA
    Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA)
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Dixon Fleming
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Praktiker
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0