ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04033332 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED?
- Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BROADOAKS VCT LIMITED | 28. Sept. 2000 | 28. Sept. 2000 |
| HILLGATE (181) LIMITED | 13. Juli 2000 | 13. Juli 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär am 09. Okt. 2012 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs | 6 Seiten | 1.4 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy James Bolot als Geschäftsführer am 17. Aug. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs | 4 Seiten | 1.1 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William James Buchan als Geschäftsführer am 15. Nov. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Andrew Smith als Geschäftsführer am 01. Nov. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Jonathan Taylor als Direktor am 26. Okt. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Timothy James Bolot als Direktor am 26. Okt. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 27 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | MG01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Mcleish als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Midmer als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Sept. 2009 | 24 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Andrew Smith am 07. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung eines Direktors | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Smith als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAYLOR, Stephen Jonathan | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 163496070001 | |||||
| GAIN, Jonathan Mark | Sekretär | 9 Nash Place HP10 8ES Penn Buckinghamshire | British | 47508930005 | ||||||
| MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Sekretär | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | 158304380001 | |||||||
| MCLEISH, William David | Sekretär | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | British | 168970640001 | ||||||
| SCOTT, Philip Henry | Sekretär | The Old Vicarage Newgate DL12 8NW Barnard Castle County Durham | British | 174231320001 | ||||||
| HILLGATE SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 7th Floor Hillgate House 26 Old Bailey EC4M 7HW London | 900018850001 | |||||||
| BETTUM, Ole | Geschäftsführer | 54 Primrose Gardens NW3 4TP London | England | Norwegian | 50551730002 | |||||
| BOLOT, Timothy James | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 107837080002 | |||||
| BUCHAN, William James | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 79917240001 | |||||
| BURGESS, Richard John | Geschäftsführer | 54 Manor Road SM2 7AG Cheam Surrey | United Kingdom ( England ) (Gb-Eng) | British | 35427700001 | |||||
| COLVIN, William | Geschäftsführer | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890003 | |||||
| FARMER, Nicholas John | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 124228290001 | |||||
| FOULKES, Kamma | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 111188390002 | |||||
| FRYER, Martin | Geschäftsführer | The Badgers Cats Lane CO10 2SF Sudbury Suffolk | British | 72517560003 | ||||||
| LOCK, Jason David | Geschäftsführer | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | 144822040001 | |||||
| MIDMER, Richard Neil | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 110640170001 | |||||
| MURPHY, John | Geschäftsführer | 4 Lochend Road KA10 6JJ Troon | United Kingdom | British | 26177180004 | |||||
| MURRAY, Andrew John | Geschäftsführer | 10 Rosgill Drive Middleton M24 4SQ Manchester Lancashire | British | 110957990001 | ||||||
| ROBINSON, Anthony Leake | Geschäftsführer | The Rose Garden Orchehill Avenue SL9 8QE Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 48323880002 | ||||||
| ROGERS, Michael Greig | Geschäftsführer | 1 Jenningsbury Court London Road SG13 7NS Hertford Hertfordshire | United Kingdom | British | 107156650001 | |||||
| RUTTER, Christopher | Geschäftsführer | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | 103588940001 | ||||||
| SCOTT, Philip Henry | Geschäftsführer | The Old Vicarage Newgate DL12 8NW Barnard Castle County Durham | England | British | 174231320001 | |||||
| SIZER, Graham Kevin | Geschäftsführer | Old Salutation Barn Low Street Little Fencote DL7 9LR Northallerton | England | British | 77274540003 | |||||
| SMITH, David Andrew, Mr. | Geschäftsführer | Durham Road Low Fell NE9 5AL Gateshead 377 England England | United Kingdom | British | 147997950001 | |||||
| SMITH, David Andrew, Mr. | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 147997950001 | |||||
| HILLGATE NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 7th Floor Hillgate House 26 Old Bailey EC4M 7HW London | 900018840001 | |||||||
| HILLGATE SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 7th Floor Hillgate House 26 Old Bailey EC4M 7HW London | 900018850001 |
Hat ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental legal mortgage | Erstellt am 06. Mai 2011 Geliefert am 20. Mai 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Broad oaks gaul road march t/no CB295973 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Feb. 2008 Geliefert am 14. März 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 06. Juni 2007 Geliefert am 19. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Juli 2006 Geliefert am 20. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Apr. 2005 Geliefert am 15. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Sept. 2004 Geliefert am 28. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Apr. 2004 Geliefert am 11. Mai 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to each beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Sept. 2000 Geliefert am 19. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan stock deed whereby the company issued to the lender 14% secured stock loan | |
Kurze Angaben Land at gaul road march cambridgeshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA) |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0