TRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED

TRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04033456
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich TRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PAGE & MOY TRAVEL GROUP LIMITED10. Mai 201010. Mai 2010
    KALEIDOSCOPE TRAVEL HOLDINGS LIMITED20. Nov. 200720. Nov. 2007
    TRAVELSPHERE HOLDINGS LIMITED31. Okt. 200031. Okt. 2000
    WILLOUGHBY (289) LIMITED13. Juli 200013. Juli 2000

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Okt. 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für TRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:form LIQ12 - secretary of state's release
    3 SeitenLIQ MISC

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    18 SeitenLIQ14

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    11 SeitenLIQ10

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    4 Seiten600

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    41 SeitenAM22

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    33 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    4 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    38 SeitenAM10

    Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA

    8 SeitenAM02

    Vorschlag des Verwalters

    48 Seiten2.17B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    50 Seiten2.23B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB zum 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB am 20. Jan. 2017

    2 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Compass House Rockingham Road Market Harborough Leicestershire LE16 7QD zum 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB am 16. Jan. 2017

    1 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 30. Dez. 2016

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    4 SeitenMR04

    Ernennung von Mr Peter Eric Buckley als Sekretär am 27. Sept. 2016

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Nigel John Arthur als Sekretär am 27. Sept. 2016

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Nigel John Arthur als Geschäftsführer am 27. Sept. 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2015

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital17. März 2016

    Kapitalaufstellung am 17. März 2016

    • Kapital: GBP 330,160.1
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2014

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital02. März 2015

    Kapitalaufstellung am 02. März 2015

    • Kapital: GBP 330,160.1
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von TRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BUCKLEY, Peter Eric
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Sekretär
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    215219850001
    ALLARD, Roger Jeffrey
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Geschäftsführer
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    United KingdomEnglish81122260002
    MCKINNON, Tracey Anne
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Geschäftsführer
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    EnglandBritish162927400001
    SMITH, Ian
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Geschäftsführer
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    United KingdomBritish5734800003
    WILSON, Colin James
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Geschäftsführer
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    EnglandBritish162927160001
    ARTHUR, Nigel John
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Sekretär
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    193406070001
    CLEMSON, David
    New Sawley Grange Farm
    Gisburn Road, Sawley
    BB7 4LH Clitheroe
    Lancashire
    Sekretär
    New Sawley Grange Farm
    Gisburn Road, Sawley
    BB7 4LH Clitheroe
    Lancashire
    British68160250001
    GADSBY, Christopher
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Sekretär
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    161968210001
    HARDMAN, John Benjamin
    Hill Rise
    Burbage
    LE10 2UA Hinckley
    42
    Leicestershire
    United Kingdom
    Sekretär
    Hill Rise
    Burbage
    LE10 2UA Hinckley
    42
    Leicestershire
    United Kingdom
    British131024350001
    PARKINSON, Ian
    17 South Green
    LA12 0UJ Ulverston
    Cumbria
    Sekretär
    17 South Green
    LA12 0UJ Ulverston
    Cumbria
    British100921910001
    SIMMONS, Susan
    Reservoir Farm
    Church Street Naseby
    NN6 6DA Northampton
    Northamptonshire
    Sekretär
    Reservoir Farm
    Church Street Naseby
    NN6 6DA Northampton
    Northamptonshire
    British125431690001
    THOMAS, Hywel David
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Sekretär
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    British59274640002
    WITTS, Kevan
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Sekretär
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    190941910001
    WILLOUGHBY CORPORATE SECRETARIAL LIMITED
    Willoughby House
    20 Low Pavement
    NG1 7EA Nottingham
    Bevollmächtigter Sekretär
    Willoughby House
    20 Low Pavement
    NG1 7EA Nottingham
    900009590001
    ARTHUR, Nigel John
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandEnglish175689210001
    BRYANT, Robert David
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish152320790001
    BURNS, David Campbell
    12 Broadway
    WA15 0PG Hale
    Cheshire
    Geschäftsführer
    12 Broadway
    WA15 0PG Hale
    Cheshire
    British73653730001
    BURTON, William John
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandBritish64885440001
    CHAPPELOW, Peter Raymond
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandBritish71153170002
    CLEMSON, David
    New Sawley Grange Farm
    Gisburn Road, Sawley
    BB7 4LH Clitheroe
    Lancashire
    Geschäftsführer
    New Sawley Grange Farm
    Gisburn Road, Sawley
    BB7 4LH Clitheroe
    Lancashire
    British68160250001
    COE, Albert Henry
    Finvara Blackhurst Brow
    Wilmslow Road
    SK10 4QT Mottram St Andrew
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Finvara Blackhurst Brow
    Wilmslow Road
    SK10 4QT Mottram St Andrew
    Cheshire
    United KingdomBritish3977310002
    DUFTY, Andrew
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish161857980002
    EDWARDS, Michael John
    The Hall
    Ketton
    PE9 3RB Stamford
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    The Hall
    Ketton
    PE9 3RB Stamford
    Lincolnshire
    British76861010002
    FOSTER, Stephen Albert
    The Lymes
    295 Gisburn Road
    BB9 6AW Barrowford
    Lancashire
    Geschäftsführer
    The Lymes
    295 Gisburn Road
    BB9 6AW Barrowford
    Lancashire
    United KingdomBritish94033560001
    GADSBY, Christopher James
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandBritish118396090002
    HARVEY, Gillian
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish140490960002
    HEWETSON, Benjamin Anthony Patrick
    62 Sugden Road
    SW11 5EF London
    Geschäftsführer
    62 Sugden Road
    SW11 5EF London
    British105633050001
    MACKAY, Richard
    The Malt House 42 Newbold Road
    Desford
    LE9 9GS Leicester
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    The Malt House 42 Newbold Road
    Desford
    LE9 9GS Leicester
    Leicestershire
    British26236830001
    MORRIS, Neil John
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish158818060001
    PARCELL, Graham James
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandBritish52050240001
    PARKINSON, Ian
    17 South Green
    LA12 0UJ Ulverston
    Cumbria
    Geschäftsführer
    17 South Green
    LA12 0UJ Ulverston
    Cumbria
    British100921910001
    SHARMAN, Jeremy William
    33 King William Street
    EC4R 9AS London
    Geschäftsführer
    33 King William Street
    EC4R 9AS London
    British57824380001
    SIMMONS, Susan
    Reservoir Farm
    Church Street Naseby
    NN6 6DA Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Reservoir Farm
    Church Street Naseby
    NN6 6DA Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish125431690001
    THOMAS, Hywel David
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandBritish59274640002
    WATTS, Mark Bingham Titus
    May Tree Lodge
    Newlands, Naseby
    NN6 6DE Northampton
    Geschäftsführer
    May Tree Lodge
    Newlands, Naseby
    NN6 6DE Northampton
    United KingdomBritish43948350004

    Hat TRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 15. Mai 2012
    Geliefert am 01. Juni 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in any other currency or currency unit, and the debt or debts owing by the bank represented by any such sum or sums (each such sum and debt being a credit balance).
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Juni 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 16. Dez. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Key-man policy assignment
    Erstellt am 08. Juni 2009
    Geliefert am 11. Juni 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Life assured: mr william john burton sum assured: £500,000.00 insurer: legal & general p/no. 013330299-2 term: 3 years with full title guarantee as a continuing security for the payment or discharge of all secured sums assigned absolutely and agreed to assign absolutely all its right, title and interest in and to the proceeds of the policies see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 11. Juni 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Insurance assignment
    Erstellt am 02. Mai 2006
    Geliefert am 16. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Insurer phoenix life and pensions life assured david clemson policy number 025794058/001 sum assured £250,000.00 commencement date 10 october 2000. insurer phoenix life and pensions life assured mark watts policy number 0305794058/004 sum assured £250,000.00 commencement date 10 october 2000. insurer scottish equitable PLC life assured sue simmons policy number L019372752 sum assured £250,000.00 commencement date 3 november 2004. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 16. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture accession deed
    Erstellt am 02. Mai 2006
    Geliefert am 16. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 16. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge over shares
    Erstellt am 28. Jan. 2005
    Geliefert am 05. Feb. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any member of the group to each finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First fixed charge all the charged securities referred to in the schedule to form 395 together with (a) all related rights from time to time accruing to those charged securities; and (b) all rights which the company may have at any time against any clearance or settlement system or any custodial rights in respect of any charged securities.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Agent")
    Transaktionen
    • 05. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Insurance assignment
    Erstellt am 28. Jan. 2005
    Geliefert am 05. Feb. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to each finance party or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Right, title and interest in and to the policy. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Agent)
    Transaktionen
    • 05. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Insurance assignment
    Erstellt am 30. Nov. 2004
    Geliefert am 09. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities whatsoever due or to become due from the company (the "assignor") to each finance party (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All encumbrances and dispositions created or made by or pursuant to the deed and any mortgage,pledge,lien,charge (fixed or floating),assgnmentsecurity interest or trust,etc.all right,title and nterest n and to the policies thereto and all monies including bonuses accrued and payabl; see form 395 for detals. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland the Security Agent
    Transaktionen
    • 09. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 30. Nov. 2004
    Geliefert am 09. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities whatsoever due or to become due from any member of the group to each finance party (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland the Security Agent
    Transaktionen
    • 09. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over retail division bank account
    Erstellt am 30. Nov. 2004
    Geliefert am 09. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to each finance party or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Right, title and interest in and to the security account and the account balance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 09. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture between the company and the governor and company of the bank of scotland as agent and trustee for itself and each of the lenders (the "security agent")
    Erstellt am 10. Okt. 2000
    Geliefert am 18. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the finance documents (as defined) or any other document evidencing or securing any such liabilities
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge on cash collateral deposit
    Erstellt am 10. Okt. 2000
    Geliefert am 18. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabiltieis due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the investor agreement (as defined) or the deed
    Kurze Angaben
    The chargor as beneficial owner and with full title guarantee as security for the payment first fixed charge all its right title and interest in the deposit moneys it si the sole legal and beneficial owner of the deposit moneys. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat TRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    30. Dez. 2016Beginn der Verwaltung
    22. Mai 2018Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Matthew Richards
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Edward Williams
    Grant Thornton Uk Llp Colmore Building
    Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp Colmore Building
    Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    2
    DatumTyp
    22. Mai 2018Beginn der Liquidation
    01. Nov. 2019Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Edward Williams
    Grant Thornton Uk Llp Colmore Building
    Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp Colmore Building
    Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    Matthew Richards
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0