TRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04033456 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich TRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 4 Hardman Square Spinningfields M3 3EB Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PAGE & MOY TRAVEL GROUP LIMITED | 10. Mai 2010 | 10. Mai 2010 |
| KALEIDOSCOPE TRAVEL HOLDINGS LIMITED | 20. Nov. 2007 | 20. Nov. 2007 |
| TRAVELSPHERE HOLDINGS LIMITED | 31. Okt. 2000 | 31. Okt. 2000 |
| WILLOUGHBY (289) LIMITED | 13. Juli 2000 | 13. Juli 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Okt. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Insolvenzmeldung Insolvency:form LIQ12 - secretary of state's release | 3 Seiten | LIQ MISC | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 18 Seiten | LIQ14 | ||||||||||
Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss | 11 Seiten | LIQ10 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 4 Seiten | 600 | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger | 41 Seiten | AM22 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 33 Seiten | AM10 | ||||||||||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 4 Seiten | AM19 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 38 Seiten | AM10 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA | 8 Seiten | AM02 | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 48 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Ergebnis der Gläubigerversammlung | 50 Seiten | 2.23B | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB zum 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB am 20. Jan. 2017 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Compass House Rockingham Road Market Harborough Leicestershire LE16 7QD zum 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB am 16. Jan. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 11 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Ernennung von Mr Peter Eric Buckley als Sekretär am 27. Sept. 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nigel John Arthur als Sekretär am 27. Sept. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nigel John Arthur als Geschäftsführer am 27. Sept. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2015 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2014 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUCKLEY, Peter Eric | Sekretär | Hardman Square Spinningfields M3 3EB Manchester 4 | 215219850001 | |||||||
| ALLARD, Roger Jeffrey | Geschäftsführer | Hardman Square Spinningfields M3 3EB Manchester 4 | United Kingdom | English | 81122260002 | |||||
| MCKINNON, Tracey Anne | Geschäftsführer | Hardman Square Spinningfields M3 3EB Manchester 4 | England | British | 162927400001 | |||||
| SMITH, Ian | Geschäftsführer | Hardman Square Spinningfields M3 3EB Manchester 4 | United Kingdom | British | 5734800003 | |||||
| WILSON, Colin James | Geschäftsführer | Hardman Square Spinningfields M3 3EB Manchester 4 | England | British | 162927160001 | |||||
| ARTHUR, Nigel John | Sekretär | Compass House Rockingham Road LE16 7QD Market Harborough Leicestershire | 193406070001 | |||||||
| CLEMSON, David | Sekretär | New Sawley Grange Farm Gisburn Road, Sawley BB7 4LH Clitheroe Lancashire | British | 68160250001 | ||||||
| GADSBY, Christopher | Sekretär | Compass House Rockingham Road LE16 7QD Market Harborough Leicestershire | 161968210001 | |||||||
| HARDMAN, John Benjamin | Sekretär | Hill Rise Burbage LE10 2UA Hinckley 42 Leicestershire United Kingdom | British | 131024350001 | ||||||
| PARKINSON, Ian | Sekretär | 17 South Green LA12 0UJ Ulverston Cumbria | British | 100921910001 | ||||||
| SIMMONS, Susan | Sekretär | Reservoir Farm Church Street Naseby NN6 6DA Northampton Northamptonshire | British | 125431690001 | ||||||
| THOMAS, Hywel David | Sekretär | Compass House Rockingham Road LE16 7QD Market Harborough Leicestershire | British | 59274640002 | ||||||
| WITTS, Kevan | Sekretär | Compass House Rockingham Road LE16 7QD Market Harborough Leicestershire | 190941910001 | |||||||
| WILLOUGHBY CORPORATE SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Willoughby House 20 Low Pavement NG1 7EA Nottingham | 900009590001 | |||||||
| ARTHUR, Nigel John | Geschäftsführer | Compass House Rockingham Road LE16 7QD Market Harborough Leicestershire | England | English | 175689210001 | |||||
| BRYANT, Robert David | Geschäftsführer | Compass House Rockingham Road LE16 7QD Market Harborough Leicestershire | United Kingdom | British | 152320790001 | |||||
| BURNS, David Campbell | Geschäftsführer | 12 Broadway WA15 0PG Hale Cheshire | British | 73653730001 | ||||||
| BURTON, William John | Geschäftsführer | Compass House Rockingham Road LE16 7QD Market Harborough Leicestershire | England | British | 64885440001 | |||||
| CHAPPELOW, Peter Raymond | Geschäftsführer | Compass House Rockingham Road LE16 7QD Market Harborough Leicestershire | England | British | 71153170002 | |||||
| CLEMSON, David | Geschäftsführer | New Sawley Grange Farm Gisburn Road, Sawley BB7 4LH Clitheroe Lancashire | British | 68160250001 | ||||||
| COE, Albert Henry | Geschäftsführer | Finvara Blackhurst Brow Wilmslow Road SK10 4QT Mottram St Andrew Cheshire | United Kingdom | British | 3977310002 | |||||
| DUFTY, Andrew | Geschäftsführer | Compass House Rockingham Road LE16 7QD Market Harborough Leicestershire | United Kingdom | British | 161857980002 | |||||
| EDWARDS, Michael John | Geschäftsführer | The Hall Ketton PE9 3RB Stamford Lincolnshire | British | 76861010002 | ||||||
| FOSTER, Stephen Albert | Geschäftsführer | The Lymes 295 Gisburn Road BB9 6AW Barrowford Lancashire | United Kingdom | British | 94033560001 | |||||
| GADSBY, Christopher James | Geschäftsführer | Compass House Rockingham Road LE16 7QD Market Harborough Leicestershire | England | British | 118396090002 | |||||
| HARVEY, Gillian | Geschäftsführer | Compass House Rockingham Road LE16 7QD Market Harborough Leicestershire | United Kingdom | British | 140490960002 | |||||
| HEWETSON, Benjamin Anthony Patrick | Geschäftsführer | 62 Sugden Road SW11 5EF London | British | 105633050001 | ||||||
| MACKAY, Richard | Geschäftsführer | The Malt House 42 Newbold Road Desford LE9 9GS Leicester Leicestershire | British | 26236830001 | ||||||
| MORRIS, Neil John | Geschäftsführer | Compass House Rockingham Road LE16 7QD Market Harborough Leicestershire | United Kingdom | British | 158818060001 | |||||
| PARCELL, Graham James | Geschäftsführer | Compass House Rockingham Road LE16 7QD Market Harborough Leicestershire | England | British | 52050240001 | |||||
| PARKINSON, Ian | Geschäftsführer | 17 South Green LA12 0UJ Ulverston Cumbria | British | 100921910001 | ||||||
| SHARMAN, Jeremy William | Geschäftsführer | 33 King William Street EC4R 9AS London | British | 57824380001 | ||||||
| SIMMONS, Susan | Geschäftsführer | Reservoir Farm Church Street Naseby NN6 6DA Northampton Northamptonshire | England | British | 125431690001 | |||||
| THOMAS, Hywel David | Geschäftsführer | Compass House Rockingham Road LE16 7QD Market Harborough Leicestershire | England | British | 59274640002 | |||||
| WATTS, Mark Bingham Titus | Geschäftsführer | May Tree Lodge Newlands, Naseby NN6 6DE Northampton | United Kingdom | British | 43948350004 |
Hat TRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 15. Mai 2012 Geliefert am 01. Juni 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in any other currency or currency unit, and the debt or debts owing by the bank represented by any such sum or sums (each such sum and debt being a credit balance). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Key-man policy assignment | Erstellt am 08. Juni 2009 Geliefert am 11. Juni 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Life assured: mr william john burton sum assured: £500,000.00 insurer: legal & general p/no. 013330299-2 term: 3 years with full title guarantee as a continuing security for the payment or discharge of all secured sums assigned absolutely and agreed to assign absolutely all its right, title and interest in and to the proceeds of the policies see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Insurance assignment | Erstellt am 02. Mai 2006 Geliefert am 16. Mai 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Insurer phoenix life and pensions life assured david clemson policy number 025794058/001 sum assured £250,000.00 commencement date 10 october 2000. insurer phoenix life and pensions life assured mark watts policy number 0305794058/004 sum assured £250,000.00 commencement date 10 october 2000. insurer scottish equitable PLC life assured sue simmons policy number L019372752 sum assured £250,000.00 commencement date 3 november 2004. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture accession deed | Erstellt am 02. Mai 2006 Geliefert am 16. Mai 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares | Erstellt am 28. Jan. 2005 Geliefert am 05. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any member of the group to each finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First fixed charge all the charged securities referred to in the schedule to form 395 together with (a) all related rights from time to time accruing to those charged securities; and (b) all rights which the company may have at any time against any clearance or settlement system or any custodial rights in respect of any charged securities.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Insurance assignment | Erstellt am 28. Jan. 2005 Geliefert am 05. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to each finance party or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Right, title and interest in and to the policy. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Insurance assignment | Erstellt am 30. Nov. 2004 Geliefert am 09. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities whatsoever due or to become due from the company (the "assignor") to each finance party (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All encumbrances and dispositions created or made by or pursuant to the deed and any mortgage,pledge,lien,charge (fixed or floating),assgnmentsecurity interest or trust,etc.all right,title and nterest n and to the policies thereto and all monies including bonuses accrued and payabl; see form 395 for detals. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Nov. 2004 Geliefert am 09. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities whatsoever due or to become due from any member of the group to each finance party (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over retail division bank account | Erstellt am 30. Nov. 2004 Geliefert am 09. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to each finance party or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Right, title and interest in and to the security account and the account balance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture between the company and the governor and company of the bank of scotland as agent and trustee for itself and each of the lenders (the "security agent") | Erstellt am 10. Okt. 2000 Geliefert am 18. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the finance documents (as defined) or any other document evidencing or securing any such liabilities | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge on cash collateral deposit | Erstellt am 10. Okt. 2000 Geliefert am 18. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabiltieis due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the investor agreement (as defined) or the deed | |
Kurze Angaben The chargor as beneficial owner and with full title guarantee as security for the payment first fixed charge all its right title and interest in the deposit moneys it si the sole legal and beneficial owner of the deposit moneys. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat TRAVEL GROUP REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0