ONEBILL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ONEBILL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04034148 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ONEBILL LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich ONEBILL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Lindred House 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ONEBILL LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ONEBILL PLC | 14. Juli 2000 | 14. Juli 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ONEBILL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2023 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ONEBILL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2023 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 28. Juni 2023
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2022 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Dwf Company Secretarial Services Limited 1 Scott Place 2 Hardman Street Manchester M3 3AA verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Dwf Company Secretarial Services Limited 1 Scott Place 2 Hardman Street Manchester M3 3AA geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 29 Seiten | MA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom First Floor, Millbank Tower, 21-24 Millbank London SW1P 4QP zum Lindred House 20 Lindred Road Brierfield Nelson BB9 5SR am 15. März 2022 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Francis Conaghan als Geschäftsführer am 04. März 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christian Nellemann als Geschäftsführer am 04. März 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stuart Norman Morten als Direktor am 04. März 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Raymond Mcginn als Direktor am 04. März 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Panayiotis Koullas als Sekretär am 04. März 2022 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 040341480010 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2021 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2020 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ONEBILL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCGINN, David Raymond | Geschäftsführer | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House England | England | British | 286701680001 | |||||
| MORTEN, Stuart Norman | Geschäftsführer | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House England | England | British | 253478290001 | |||||
| BLOODWORTH, Owen | Sekretär | Thornhill Farm Coolham RH13 8QN Horsham West Sussex | British | 109512260001 | ||||||
| GERMAN, Peter James | Sekretär | 17 Kings Crescent Shoreham Beach BN43 5LE Shoreham By Sea West Sussex | British | 59433780003 | ||||||
| KOULLAS, Panayiotis | Sekretär | 21-24 Millbank SW1P 4QP London First Floor, Millbank Tower, England | British | 127212940002 | ||||||
| NOMINEE SECRETARIES LTD | Bevollmächtigter Sekretär | 3 Garden Walk EC2A 3EQ London | 900006780001 | |||||||
| BLOODWORTH, Owen | Geschäftsführer | Thornhill Farm Coolham RH13 8QN Horsham West Sussex | England | British | 109512260001 | |||||
| CONAGHAN, Neil Francis | Geschäftsführer | 21-24 Millbank SW1P 4QP London First Floor, Millbank Tower, England | United Kingdom | British | 159524670001 | |||||
| DICKIN, Anthony John | Geschäftsführer | 7 Ferndown Gardens KT11 2BH Cobham Surrey | England | British | 127212770001 | |||||
| GERMAN, Peter James | Geschäftsführer | 17 Kings Crescent Shoreham Beach BN43 5LE Shoreham By Sea West Sussex | British | 59433780003 | ||||||
| KARIBIAN, Anthony Vahan | Geschäftsführer | Gledhow Gardens SW5 0AY London 13d | United Kingdom | British | 136539170001 | |||||
| MARTIN, Anna | Geschäftsführer | 28 Lesser Foxholes BN43 5NT Shoreham By Sea West Sussex | United Kingdom | British | 68530030001 | |||||
| NELLEMANN, Christian | Geschäftsführer | 21-24 Millbank SW1P 4QP London First Floor, Millbank Tower, | England | Danish | 192758240001 | |||||
| NELLEMANN, Christian | Geschäftsführer | 21-24 Millbank SW1P 4QP London First Floor, Millbank Tower, England | England | Danish | 192758240001 | |||||
| SHEIKH, Saeed Mohammed | Geschäftsführer | 21-24 Millbank SW1P 4QP London First Floor, Millbank Tower, | England | British | 257470750001 | |||||
| THORNLEY, Graham Michael | Geschäftsführer | 28 Lesser Foxholes BN43 5NT Shoreham By Sea West Sussex | England | British | 61766650002 | |||||
| TIPPER, Gary William | Geschäftsführer | The Avenue Sale M33 4PJ Manchester 33 Lancashire | United Kingdom | British | 136539500001 | |||||
| NOMINEE DIRECTORS LTD | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 3 Garden Walk EC2A 3EQ London | 900006850001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ONEBILL LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onebill Group Limited | 06. Apr. 2016 | 21-24 Millbank SW1P 4QP London First Floor, Millbank Tower England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat ONEBILL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 18. Dez. 2020 Geliefert am 21. Dez. 2020 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Please see instrument for further details. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 03. Okt. 2014 Geliefert am 06. Okt. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 02. Dez. 2013 Geliefert am 05. Dez. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Trade mark number 2260289-mark text: onebill 1234567890B telecom (word and mark). Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Group debenture | Erstellt am 24. Sept. 2010 Geliefert am 06. Okt. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future member of the group to the security agent and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 24. Sept. 2010 Geliefert am 02. Okt. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee, the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 17. Feb. 2009 Geliefert am 03. März 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All f/h,l/h property,all the undertaking,property and assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Feb. 2009 Geliefert am 20. Feb. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor (or any of them) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 17. Feb. 2009 Geliefert am 20. Feb. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the security beneficiaries or any of them by any group company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 02. Juli 2004 Geliefert am 17. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a premium house, 102-108 brighton road, worthing. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Juli 2001 Geliefert am 26. Juli 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0