CARPENTER (BATH) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CARPENTER (BATH) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04035575 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CARPENTER (BATH) LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich CARPENTER (BATH) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 5th Floor Leconfield House Curzon Street W1J 5JA London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CARPENTER (BATH) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| WELBECK LAND (BATH) LIMITED | 09. Okt. 2000 | 09. Okt. 2000 |
| INVERTLAW LIMITED | 18. Juli 2000 | 18. Juli 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CARPENTER (BATH) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Mai 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CARPENTER (BATH) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Juli 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Vincent Aziz Tchenguiz am 01. Juli 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2015 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2014 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2013 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Vincent Aziz Tchenguiz am 08. Okt. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2012 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Ingham als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 4Th Floor Leconfield House Curzon Street London W1J 5JA* am 07. Feb. 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2011 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2010 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2009 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2008 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CARPENTER (BATH) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCHENGUIZ, Robert | Geschäftsführer | Royal College Of Organists 26 Kensington Gore SW7 2ET London | England | British | 74322720004 | |||||
| TCHENGUIZ, Vincent Aziz | Geschäftsführer | Floor Leconfield House Curzon Street W1J 5JA London 5th | United Kingdom | British, | 71890500005 | |||||
| INGHAM, Michael Harry Peter | Sekretär | 3 Lauriston Road Wimbledon SW19 4TJ London | British | 2739650001 | ||||||
| LEE, John Philip Macarthur | Sekretär | Garden Flat 104 Cambridge Street SW1V 4QG London | British | 32509900004 | ||||||
| THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Leonard Street EC2A 4QS London 83 | 900013740001 | |||||||
| SHANNON, Toby Richard | Geschäftsführer | 5 Hollybush Close TN13 3XW Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 51036540002 | |||||
| THORPE, Julian David | Geschäftsführer | Flat 8 48 Thurloe Square SW7 2SX London | United Kingdom | British | 100357510001 | |||||
| THORPE, Julian David | Geschäftsführer | Flat 8 48 Thurloe Square SW7 2SX London | United Kingdom | British | 100357510001 | |||||
| WATSON, Alistair James | Geschäftsführer | 119 Fielding Road Chiswick W4 1DA London | United Kingdom | British | 3470940002 | |||||
| LUCIENE JAMES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 83 Leonard Street EC2A 4QS London | 900003210001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CARPENTER (BATH) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domecroft Limited | 06. Apr. 2016 | Curzon Street W1J 5JA London 5th Floor, Leconfield House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat CARPENTER (BATH) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 22. Feb. 2007 Geliefert am 01. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben For details of properties charged please. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Mai 2004 Geliefert am 20. Mai 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the f/h land and buildings at carpenter house, broad quay, bath t/no AV126034; all the f/h land and buildings at carpenter house, broad quay, bath t/no AV126033; all the l/h land and buildings atcarpenter house, broad quay, bath t/no AV126032; all the l/h land and buildingsat carpenter house, broad quay, bath t/N. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Aug. 2002 Geliefert am 14. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Part f/h and part l/h property k/a carpenter house broad quay bath t/ns AV126034 AV126033 AV126032 and AV126028. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Aug. 2001 Geliefert am 22. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the facility documents or otherwise whatsoever | |
Kurze Angaben By way of a first fixed charge by way of legal mortgage the scheduled property and all rights relating to the scheduled property being all that land and buildings at cappenter house broad quay bath title numbers AV126033 and av 126034 in respect of the freehold part and title numbers AV126028 and AV126032 in respect of the leasehold part by way of first fixed charge the property (except the scheduled property validly charged in paragraph 1 above) and all rights relating to such property contracts book debts intellectual property plant and machinery shares and derivative assets goodwill by way of first floating charge all the undertaking and assets of the borrower whatsoever wherever situate whether movable immovable present or future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0