DIMENSION DATA COMMUNICATIONS UK LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | DIMENSION DATA COMMUNICATIONS UK LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04036009 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DIMENSION DATA COMMUNICATIONS UK LIMITED?
- Sonstige Telekommunikationsaktivitäten (61900) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich DIMENSION DATA COMMUNICATIONS UK LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Darwin House Lichfield South Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Staffordshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DIMENSION DATA COMMUNICATIONS UK LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| NEXTIRAONE UK LIMITED | 02. Sept. 2002 | 02. Sept. 2002 |
| ALCATEL E-BUSINESS DISTRIBUTION LIMITED | 21. Sept. 2000 | 21. Sept. 2000 |
| BLAKEDEW 256 LIMITED | 18. Juli 2000 | 18. Juli 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DIMENSION DATA COMMUNICATIONS UK LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für DIMENSION DATA COMMUNICATIONS UK LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anne Colette Jacqueline Thonon als Geschäftsführer am 10. Okt. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew David Coulsen als Geschäftsführer am 10. Okt. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Juli 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Juni 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2017 bis 31. März 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 27. Sept. 2017
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2016 | 26 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Dimension Data Holdings Plc as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 1 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ms Anne Colette Jacqueline Thonon am 29. Aug. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2015 | 30 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Paul Francis Cooper als Direktor am 21. März 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Calvin Paul Wesley Goom als Geschäftsführer am 21. März 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2014 | 28 Seiten | AA | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2014 bis 30. Sept. 2014 | 3 Seiten | AA01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Paul Francis Cooper als Sekretär am 02. Feb. 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Mr Calvin Paul Wesley Goom als Direktor am 02. Feb. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Clare Horner als Sekretär am 02. Feb. 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven Murray Skakel als Geschäftsführer am 02. Feb. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 30 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von DIMENSION DATA COMMUNICATIONS UK LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOPER, Paul Francis | Sekretär | Darwin House Lichfield South Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Staffordshire | 194607120001 | |||||||
| COOPER, Paul Francis | Geschäftsführer | Darwin House Lichfield South Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Staffordshire | England | British | 206909290001 | |||||
| HORNER, Clare | Sekretär | Darwin House Lichfield South Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Staffordshire | British | 81932840001 | ||||||
| MAJURY, Robert Andrew | Sekretär | 24 Canterbury Road GU14 6NW Farnborough Hampshire | British | 72155340001 | ||||||
| PENTER, Nicholas Trevor | Sekretär | 8 Cotsalls Fair Oak SO50 7HP Eastleigh Hampshire | British | 81327550001 | ||||||
| SKAKEL, Steven Murray | Sekretär | 29 Earlswood Road Dorridge B93 8RD Solihull West Midlands | British | 29806610004 | ||||||
| BLAKELAW SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Harbour Court Compass Road North Harbour PO6 4ST Portsmouth Hampshire | 38915800008 | |||||||
| ANE, Jerome Philippe | Geschäftsführer | Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Darwin House Staffordshire | France | French | 148831600001 | |||||
| BERTHELON, Jean Jacques | Geschäftsführer | 59 Boulevard Beausejour FOREIGN Paris Paris 75116 France | French | 114410380001 | ||||||
| COULSEN, Andrew David | Geschäftsführer | Darwin House Lichfield South Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Staffordshire | Switzerland | British | 87390090003 | |||||
| DOWNIE, Ian Michael Stuart | Geschäftsführer | Beech Hill Easton SO21 1ED Winchester Hampshire | United Kingdom | British | 81327720001 | |||||
| GIBBS, Simon Spencer | Geschäftsführer | Weedon Lodge Farm House East End HP22 4NJ Weedon Buckinghamshire | England | British | 90259420001 | |||||
| GOOM, Calvin Paul Wesley | Geschäftsführer | Darwin House Lichfield South Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Staffordshire | United Kingdom | British | 194584790001 | |||||
| KAYLOR, Donald Graham | Geschäftsführer | 1 Styperson Way Poynton SK12 1UJ Stockport Cheshire | British | 73180690001 | ||||||
| LEWIS, David Andrew | Geschäftsführer | 17 Mill Road CF14 0XA Cardiff | United Kingdom | British | 63310660001 | |||||
| MAJURY, Robert Andrew | Geschäftsführer | 24 Canterbury Road GU14 6NW Farnborough Hampshire | England | British | 72155340001 | |||||
| PENTER, Nicholas Trevor | Geschäftsführer | 8 Cotsalls Fair Oak SO50 7HP Eastleigh Hampshire | United Kingdom | British | 81327550001 | |||||
| SALVAGE, James Lloyd | Geschäftsführer | Lissom Shaw Rickmanhill Road CR5 3LA Chipstead Surrey | British | 50498550001 | ||||||
| SKAKEL, Steven Murray | Geschäftsführer | 29 Earlswood Road Dorridge B93 8RD Solihull West Midlands | England | British | 29806610004 | |||||
| THONON, Anne Colette Jacqueline | Geschäftsführer | Darwin House Lichfield South Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Staffordshire | Luxembourg | Belgian | 146053560002 | |||||
| WINN, David Charles | Geschäftsführer | NL-1016 Ex Amsterdam Keizersgracht 302 1v | The Netherlands | Irish | 150733800001 | |||||
| BLAKELAW DIRECTOR SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | New Court 1 Barnes Wallis Road PO15 5UA Fareham Hampshire | 67781590002 | |||||||
| NEXTIRAONE EUROPE HOLDINGS BV | Geschäftsführer | Laan Van's-Gravenmade 24 2495 Aj's Gravenhage Netherlands | 114409680001 | |||||||
| RKO MANAGEMENT AND INVESTMENT B.V. | Geschäftsführer | Laan Van `S-Gravenmade 24 `S-Gravenhage 2495 Aj Netherlands | 117640790001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DIMENSION DATA COMMUNICATIONS UK LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension Data Holdings Plc | 06. Apr. 2016 | Waterfront Business Park Fleet Road GU51 3QT Fleet Dimension Data House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat DIMENSION DATA COMMUNICATIONS UK LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 24. Apr. 2013 Geliefert am 01. Mai 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 12. Okt. 2007 Geliefert am 20. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben A first fixed equitable charge over the deposit £306,315.45. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Dez. 2005 Geliefert am 29. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The real property any goodwill the shares all dividends interest and other monies the proceeds of insurance floating charge the companys undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 29. Aug. 2002 Geliefert am 04. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First legal fixed charge over rent deposit of £164,590.00 and any interest thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 20. März 2002 Geliefert am 27. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Barclays bank PLC re alcatel e-businessdistribution limited business premium account number 50126586. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0