B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameB MIDGLEY SEAFOODS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04036033
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED?

    • Verarbeitung und Konservierung von Fisch, Krusten- und Weichtieren (10200) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Juli 2021

    6 SeitenLIQ03

    Rücktritt eines Liquidators

    3 SeitenLIQ06

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    42 Seiten600

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Kpmg Llp 8 Princes Parade Liverpool L3 1QH zum 1 st. Peters Square Manchester M2 3AE am 07. Mai 2021

    2 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Ross House Wickham Road Grimsby North East Lincolnshire DN31 3SW zum 8 Princes Parade Liverpool L3 1QH am 05. Aug. 2020

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 10. Juli 2020

    LRESSP

    Cessation of English Seafoods Limited as a person with significant control on 29. März 2020

    1 SeitenPSC07

    Notification of Youngs Seafood Ltd as a person with significant control on 29. März 2020

    2 SeitenPSC02

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 30. März 2020

    • Kapital: GBP 200
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Reduce share prem a/c 18/03/2020
    RES13

    Beendigung der Bestellung von Jenny Nancy Loncaster als Geschäftsführer am 25. Sept. 2019

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 18. Juli 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Timothy Mark Busby als Geschäftsführer am 12. Sept. 2019

    1 SeitenTM01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2019 bis 31. März 2020

    1 SeitenAA01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom PO Box 16 Wilkin Chapman Llp New Oxford House Town Hall Square Grimsby North East Lincolnshire DN31 1HE England zum Karro Food Group Hugden Way Norton Grove Industrial Estate Norton Malton North Yorkshire YO17 9HG geändert

    1 SeitenAD02

    Ernennung von Mr Michael Kamiel Jan Alfons Kestemont als Direktor am 04. Juli 2019

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2018

    4 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Wilkin Chapman Company Secretarial Services Limited als Sekretär am 04. Juli 2019

    1 SeitenTM02

    Bestätigungserklärung erstellt am 18. Juli 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Wer sind die Geschäftsführer von B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    KESTEMONT, Michael Kamiel Jan Alfons
    St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    1
    Geschäftsführer
    St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    1
    United KingdomBelgian231792890001
    CHEESEMAN, David Benjamin
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    Sekretär
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    British1031110002
    MIDGLEY, Lisbeth Jane
    64 Mill Road
    Swanland
    HU14 3PL North Ferriby
    North Humberside
    Sekretär
    64 Mill Road
    Swanland
    HU14 3PL North Ferriby
    North Humberside
    British70971410001
    WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Sekretär
    Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer02249348
    75197930001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    BRITTON, Christopher Paul
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish127835580001
    BUSBY, Timothy Mark
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    EnglandEnglish169852920001
    CHEESEMAN, David Benjamin
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    Geschäftsführer
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    EnglandBritish1031110002
    DEN HOLLANDER, Leendert Pieter
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandDutch166335910001
    EVANS, Thomas Jeffrey
    Tudor Lodge
    308 Beverley Road Anlaby
    HU10 7BG Hull
    Geschäftsführer
    Tudor Lodge
    308 Beverley Road Anlaby
    HU10 7BG Hull
    EnglandBritish2183390002
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    EnglandBritish84487230001
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    EnglandBritish84487230001
    LOFTS, Malcolm Herbert
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritish177239110001
    LONCASTER, Jenny Nancy
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritish205633180001
    MIDGLEY, Barry George
    64 Mill Road
    Swanland
    HU14 3PL North Ferriby
    North Humberside
    Geschäftsführer
    64 Mill Road
    Swanland
    HU14 3PL North Ferriby
    North Humberside
    EnglandBritish38013830001
    MIDGLEY, Fraser
    16 Kenilworth Avenue
    HU5 4BH Hull
    Geschäftsführer
    16 Kenilworth Avenue
    HU5 4BH Hull
    British70971400002
    PARKER, Michael
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    United KingdomBritish2785890001
    WARD, Peter Selwyn
    155 Eastgate
    LN11 8DB Louth
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    155 Eastgate
    LN11 8DB Louth
    Lincolnshire
    United KingdomBritish33803400001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    England
    29. März 2020
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    England
    Nein
    RechtsformYoungs Seafood Ltd
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer3751665
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    Ja
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageEngland & Wales
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer02353338
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 23. Okt. 2008
    Geliefert am 01. Nov. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 01. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 23. Sept. 2008
    Geliefert am 04. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 21. März 2007
    Geliefert am 31. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale the Security Agent
    Transaktionen
    • 31. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 16. März 2006
    Geliefert am 25. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties (The 'Security Agent')
    Transaktionen
    • 25. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Dez. 2005
    Geliefert am 17. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All material premises being l/h interest in land and buildings on the north east side of wassand street, kingston upon hull, together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 17. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security accession deed
    Erstellt am 30. Juni 2004
    Geliefert am 10. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    With full title guarantee, both present and future by way of first legal mortgage the property specified in schedule 1 to the accession deed, together with all buildings and fixtures and all the subsidiary shares and investments specified in schedule 2 to the accession deed;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The Securityagent)
    Transaktionen
    • 10. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 02. Mai 2003
    Geliefert am 15. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account with the bank.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. März 2001
    Geliefert am 03. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Okt. 2000
    Geliefert am 01. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    10. Juli 2020Beginn der Liquidation
    13. Jan. 2022Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Nicholas James Timpson
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Praktiker
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Mark Jeremy Orton
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Praktiker
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0