B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04036033 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED?
- Verarbeitung und Konservierung von Fisch, Krusten- und Weichtieren (10200) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 St. Peters Square M2 3AE Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Juli 2021 | 6 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Rücktritt eines Liquidators | 3 Seiten | LIQ06 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 42 Seiten | 600 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Kpmg Llp 8 Princes Parade Liverpool L3 1QH zum 1 st. Peters Square Manchester M2 3AE am 07. Mai 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Ross House Wickham Road Grimsby North East Lincolnshire DN31 3SW zum 8 Princes Parade Liverpool L3 1QH am 05. Aug. 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation of English Seafoods Limited as a person with significant control on 29. März 2020 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Notification of Youngs Seafood Ltd as a person with significant control on 29. März 2020 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 30. März 2020
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jenny Nancy Loncaster als Geschäftsführer am 25. Sept. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Juli 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy Mark Busby als Geschäftsführer am 12. Sept. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2019 bis 31. März 2020 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom PO Box 16 Wilkin Chapman Llp New Oxford House Town Hall Square Grimsby North East Lincolnshire DN31 1HE England zum Karro Food Group Hugden Way Norton Grove Industrial Estate Norton Malton North Yorkshire YO17 9HG geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Michael Kamiel Jan Alfons Kestemont als Direktor am 04. Juli 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Wilkin Chapman Company Secretarial Services Limited als Sekretär am 04. Juli 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Juli 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESTEMONT, Michael Kamiel Jan Alfons | Geschäftsführer | St. Peters Square M2 3AE Manchester 1 | United Kingdom | Belgian | 231792890001 | |||||||||
| CHEESEMAN, David Benjamin | Sekretär | 83 Newland Park HU5 2DR Hull | British | 1031110002 | ||||||||||
| MIDGLEY, Lisbeth Jane | Sekretär | 64 Mill Road Swanland HU14 3PL North Ferriby North Humberside | British | 70971410001 | ||||||||||
| WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | Chantry Lane DN31 2LJ Grimsby Cartergate House England |
| 75197930001 | ||||||||||
| YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000880001 | |||||||||||
| BRITTON, Christopher Paul | Geschäftsführer | Wickham Road DN31 3SW Grimsby Ross House North East Lincolnshire United Kingdom | United Kingdom | British | 127835580001 | |||||||||
| BUSBY, Timothy Mark | Geschäftsführer | Wickham Road DN31 3SW Grimsby Ross House North East Lincolnshire | England | English | 169852920001 | |||||||||
| CHEESEMAN, David Benjamin | Geschäftsführer | 83 Newland Park HU5 2DR Hull | England | British | 1031110002 | |||||||||
| DEN HOLLANDER, Leendert Pieter | Geschäftsführer | Wickham Road DN31 3SW Grimsby Ross House North East Lincolnshire United Kingdom | England | Dutch | 166335910001 | |||||||||
| EVANS, Thomas Jeffrey | Geschäftsführer | Tudor Lodge 308 Beverley Road Anlaby HU10 7BG Hull | England | British | 2183390002 | |||||||||
| LEADBEATER, Stephen Paul | Geschäftsführer | Allt Nam Breac Mill Lane, Legbourne LN11 8LT Louth Lincolnshire | England | British | 84487230001 | |||||||||
| LEADBEATER, Stephen Paul | Geschäftsführer | Allt Nam Breac Mill Lane, Legbourne LN11 8LT Louth Lincolnshire | England | British | 84487230001 | |||||||||
| LOFTS, Malcolm Herbert | Geschäftsführer | Wickham Road DN31 3SW Grimsby Ross House North East Lincolnshire United Kingdom | England | British | 177239110001 | |||||||||
| LONCASTER, Jenny Nancy | Geschäftsführer | Wickham Road DN31 3SW Grimsby Ross House North East Lincolnshire United Kingdom | England | British | 205633180001 | |||||||||
| MIDGLEY, Barry George | Geschäftsführer | 64 Mill Road Swanland HU14 3PL North Ferriby North Humberside | England | British | 38013830001 | |||||||||
| MIDGLEY, Fraser | Geschäftsführer | 16 Kenilworth Avenue HU5 4BH Hull | British | 70971400002 | ||||||||||
| PARKER, Michael | Geschäftsführer | Humber Lodge Old Post Office Lane South Ferriby DN18 6HH Barton Upon Humber N E Lincolnshire | United Kingdom | British | 2785890001 | |||||||||
| WARD, Peter Selwyn | Geschäftsführer | 155 Eastgate LN11 8DB Louth Lincolnshire | United Kingdom | British | 33803400001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Youngs Seafood Ltd | 29. März 2020 | Wickham Road DN31 3SW Grimsby Ross House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| English Seafoods Limited | 06. Apr. 2016 | Wickham Road DN31 3SW Grimsby Ross House North East Lincolnshire United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 23. Okt. 2008 Geliefert am 01. Nov. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Sept. 2008 Geliefert am 04. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. März 2007 Geliefert am 31. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. März 2006 Geliefert am 25. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Dez. 2005 Geliefert am 17. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All material premises being l/h interest in land and buildings on the north east side of wassand street, kingston upon hull, together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security accession deed | Erstellt am 30. Juni 2004 Geliefert am 10. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben With full title guarantee, both present and future by way of first legal mortgage the property specified in schedule 1 to the accession deed, together with all buildings and fixtures and all the subsidiary shares and investments specified in schedule 2 to the accession deed;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 02. Mai 2003 Geliefert am 15. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. März 2001 Geliefert am 03. Apr. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Okt. 2000 Geliefert am 01. Nov. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0