LYPS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLYPS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04036463
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LYPS LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich LYPS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Castlegarth Grange
    Scott Lane
    LS22 6LH Wetherby
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LYPS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PINCO 1475 LIMITED19. Juli 200019. Juli 2000

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LYPS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Aug. 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für LYPS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01
    A7GCKASA

    Bestätigungserklärung erstellt am 19. Juli 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01
    X7ALMLAH

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Aug. 2017

    1 SeitenAA
    A6FKYWAY

    Bestätigungserklärung erstellt am 19. Juli 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01
    X6B4WK7E

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 25 Market Place Wetherby Leeds West Yorkshire LS22 6LQ zum Castlegarth Grange Scott Lane Wetherby LS22 6LH am 12. Mai 2017

    1 SeitenAD01
    X66A1RBV

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2017 bis 31. Aug. 2017

    1 SeitenAA01
    X60XPNG3

    Bestätigungserklärung erstellt am 19. Juli 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01
    X5CR9LVC

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016

    1 SeitenAA
    A557W25M

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital24. Aug. 2015

    Kapitalaufstellung am 24. Aug. 2015

    • Kapital: GBP 470
    SH01
    X4EHRM3K

    Ernennung von Mr Paul Andrew Bullers als Sekretär am 20. Jan. 2015

    2 SeitenAP03
    X4COWGFV

    Beendigung der Bestellung von Peter Graham Hirst als Sekretär am 20. Jan. 2015

    1 SeitenTM02
    X4COWFXK

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015

    1 SeitenAA
    A49BAAK1

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    X3CWEL23

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014

    1 SeitenAA
    A39KMSJ6

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. Juli 2013

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 29. Juli 2013

    SH01
    X2DMNIW9

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013

    1 SeitenAA
    A2BDABNS

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    X1DJ8UEY

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2012

    1 SeitenAA
    A185RLFE

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    15 SeitenAA
    A4XQJXYF

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    XATBHW5T

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010

    15 SeitenAA
    A2AYZNTZ

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    XVPEAMF6

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03
    XVPE9MF5

    Wer sind die Geschäftsführer von LYPS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BULLERS, Paul Andrew
    Scott Lane
    LS22 6LH Wetherby
    Castlegarth Grange
    England
    Sekretär
    Scott Lane
    LS22 6LH Wetherby
    Castlegarth Grange
    England
    199761840001
    FRANCE, Richard Edward
    Appleton House
    Main Street Appleton Roebuck
    YO23 7DG York
    Geschäftsführer
    Appleton House
    Main Street Appleton Roebuck
    YO23 7DG York
    United KingdomBritishDirector56208840002
    HIRST, Peter Graham
    The Coach House
    Outwood Lane Horsforth
    LS18 4HR Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    The Coach House
    Outwood Lane Horsforth
    LS18 4HR Leeds
    West Yorkshire
    BritishFinance Director32603370002
    LEEDHAM, Iain Patrick John
    Field House Providence Farm
    Low Crankley
    YO61 3NY Easingwold
    York
    Sekretär
    Field House Providence Farm
    Low Crankley
    YO61 3NY Easingwold
    York
    BritishDirector26336150004
    WATKINSON, Richard
    12 Lombard Street
    Rawdon
    LS19 6BW Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    12 Lombard Street
    Rawdon
    LS19 6BW Leeds
    West Yorkshire
    BritishSolicitor71654340001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    LEEDHAM, Iain Patrick John
    Field House Providence Farm
    Low Crankley
    YO61 3NY Easingwold
    York
    Geschäftsführer
    Field House Providence Farm
    Low Crankley
    YO61 3NY Easingwold
    York
    EnglandBritishDirector26336150004
    WATKINSON, Richard
    12 Lombard Street
    Rawdon
    LS19 6BW Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    12 Lombard Street
    Rawdon
    LS19 6BW Leeds
    West Yorkshire
    BritishSolicitor71654340001
    WOOD, John Richard
    Scoreby Farm House
    Scoreby
    YO41 1NP York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Scoreby Farm House
    Scoreby
    YO41 1NP York
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector6672200001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LYPS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Oakgate Group Plc
    Market Place
    LS22 6LQ Wetherby
    Oakgate House
    West Yorkshire
    England
    06. Apr. 2016
    Market Place
    LS22 6LQ Wetherby
    Oakgate House
    West Yorkshire
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortEngland And Wales
    Registrierungsnummer03055772
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat LYPS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 30. Nov. 2005
    Geliefert am 08. Dez. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or its associated companies on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land and buildings on the north east side of rougier street, york t/no NYK242032, the l/h property k/a land and buildings on the north east side of rougier street, york t/no NYK242035, and the l/h property k/a 7/9 rougier street, york t/no NYK70505 by way of assignment, the rental income, the goodwill, by way of floating charge its undertaking and all its other property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment
    Erstellt am 19. Sept. 2001
    Geliefert am 09. Okt. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities whatsoever which may now or at any time in the future be due owing or incurred by lyps limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of lyps limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company (group member) to the chargee as trustee for itself and the other lenders from time to time (trustee), or the trustee, cgnu PLC and any company which is or becomes a holding company of any such company or subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed monies by, any group member ("lenders") or for in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders whether present or future, actual or contingent on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the occupational lease/s in respect of f/h land being land and buildings on the northeast side of rougier street york- t/n NYK242032, l/h land being land and buildings on the northeast side of rougier street york- t/n NYK242035, l/h land being 7/9 rougier street york- t/n NYK70505... See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • London and Edinburgh Insurance Co Limited
    Transaktionen
    • 09. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of legal charge
    Erstellt am 19. Sept. 2001
    Geliefert am 09. Okt. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities whatsoever which may now or at any time in the future be due owing or incurred by lyps limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of lyps limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company from time to time which has an obligation to any lender in relation to the indebtedness (group member) to the chargee as trustee for itself and the other lenders (trustee), cgnu PLC and any company which is or becomes a holding company of any such company or subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed monies by, any group member ("lenders") or for in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders whether present or future, actual or contingent on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land being land and buildings on the northeast side of rougier street york- t/n NYK242032, l/h land being land and buildings on the northeast side of rougier street york- t/n NYK242035, l/h land being 7/9 rougier street york- t/n NYK70505 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery..all monies deposited with the trustee..floating charge the whole of the company's undertaking... See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • London and Edinburgh Insurance Co LTD
    Transaktionen
    • 09. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0