ENSIGN HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ENSIGN HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04039129 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ENSIGN HOLDINGS LIMITED?
- (9999) /
Wo befindet sich ENSIGN HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ENSIGN HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MINMAR (524) LIMITED | 24. Juli 2000 | 24. Juli 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ENSIGN HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ENSIGN HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Steven Paul Burns am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David James Winkett am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für John David Neal am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für David Edward Cooney am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Sharon Maria Boland am 01. Okt. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ENSIGN HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLAND, Sharon Maria | Sekretär | 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London Plantation Place | British | 60727940002 | ||||||
| BURNS, Steven Paul | Geschäftsführer | 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London Plantation Place | United Kingdom | British | 18761850004 | |||||
| COONEY, David Edward | Geschäftsführer | 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London Plantation Place | United Kingdom | British | 72000080003 | |||||
| NEAL, John David | Geschäftsführer | 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London Plantation Place | British | 102055920002 | ||||||
| WINKETT, David James | Geschäftsführer | 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London Plantation Place | British | 73175560002 | ||||||
| BECKERSON, Ian David | Sekretär | St Omer Road GU1 2DB Guildford 2d Surrey | British | 73004250004 | ||||||
| DAWE, Andrew Steven | Sekretär | 51 Cherry Tree Road ME8 8JY Rainham Kent | British | 96373270001 | ||||||
| PALLOT, Hugh Glen | Sekretär | 143 Gresham Road TW18 2AG Staines Middlesex | British | 14485660002 | ||||||
| WILLIAMS, Adrian Charles Harold | Sekretär | The Upper Flat 94 Offord Road N1 1PF London | British | 103327620002 | ||||||
| CLYDE SECRETARIES LIMITED | Sekret är | 51 Eastcheap EC3M 1JP London | 38770650001 | |||||||
| ANDREWS, John Michael Geoffrey | Geschäftsführer | 80 Palace Gardens Terrace W8 4RS London | United Kingdom | British | 4263690001 | |||||
| CARTER, Richard Graham | Geschäftsführer | Mill House Brenchley Road, Brenchley TN12 7NS Tonbridge Kent | England | British | 562930002 | |||||
| DUFFY, Christopher William | Geschäftsführer | 7 The Broadwalk HA6 2XF Northwood Middlesex | England | British | 67071750001 | |||||
| LANG, David Mark | Geschäftsführer | Oak Lodge 2 Gypsy Lane Great Amwell SG12 9RN Ware Hertfordshire | British | 83500640003 | ||||||
| PAGE, David William | Geschäftsführer | Rhoden Buckland Hill TN5 6QT Wadhurst East Sussex | British | 61672430001 | ||||||
| PRITCHARD, Michael Stephen Francis | Geschäftsführer | Allens Wall Black Hill RH16 2HE Haywards Heath West Sussex | British | 79170090001 | ||||||
| YOUNG, James Douglas | Geschäftsführer | 3 Hadham Grove Hadham Road CM23 2PW Bishops Stortford Hertfordshire | England | British | 159566240001 |
Hat ENSIGN HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Erstellt am 26. Sept. 2003 Geliefert am 03. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £20,000 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The sum of £20,000 being the deposit. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture deed | Erstellt am 28. März 2002 Geliefert am 10. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Nov. 2000 Geliefert am 07. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined) including any liability in respect of any further advances made under the finance documents on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the company's right title and interest from time to time in and to all shares in the capital of minmar (527) limited; an account in the name of the company (with account number 90367995) maintained with the bank the proceeds of the keyman policy and all related rights and each of the specific contracts and all related rights floating charge over the whole of the company's undertaking and assets present and future present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0