PHILIP PARKINSON HEALTHCARE LTD

PHILIP PARKINSON HEALTHCARE LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePHILIP PARKINSON HEALTHCARE LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04046584
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PHILIP PARKINSON HEALTHCARE LTD?

    • Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich PHILIP PARKINSON HEALTHCARE LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    238 Station Road
    Addlestone
    KT15 2PS Surrey
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PHILIP PARKINSON HEALTHCARE LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2015

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für PHILIP PARKINSON HEALTHCARE LTD?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für PHILIP PARKINSON HEALTHCARE LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Aug. 2015

    Kapitalaufstellung am 18. Aug. 2015

    • Kapital: GBP 96
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2015

    6 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2014

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Aug. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Aug. 2014

    Kapitalaufstellung am 28. Aug. 2014

    • Kapital: GBP 96
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2013

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital21. Aug. 2013

    Kapitalaufstellung am 21. Aug. 2013

    • Kapital: GBP 96
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2012

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2011

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Mahesh Shivabhai Patel am 04. Feb. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Surendra Shivabhai Patel am 04. Feb. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für John Neal Alflatt am 04. Feb. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für John Neal Alflatt am 04. Feb. 2010

    2 SeitenCH03

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2009

    5 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2008

    5 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2007

    5 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von PHILIP PARKINSON HEALTHCARE LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ALFLATT, John Neal
    Station Road
    KT15 2PS Addlestone
    238
    Surrey
    United Kingdom
    Sekretär
    Station Road
    KT15 2PS Addlestone
    238
    Surrey
    United Kingdom
    BritishCompany Secretary86320800002
    ALFLATT, John Neal
    Station Road
    KT15 2PS Addlestone
    238
    Surrey
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Station Road
    KT15 2PS Addlestone
    238
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Secretary86320800002
    PATEL, Mahesh Shivabhai
    Station Road
    KT15 2PS Addlestone
    238
    Surrey
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Station Road
    KT15 2PS Addlestone
    238
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector80756410001
    PATEL, Surendra Shivabhai
    Station Road
    KT15 2PS Addlestone
    238
    Surrey
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Station Road
    KT15 2PS Addlestone
    238
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director44101520001
    BROWN, Deborah Kaye
    286 Rectory Road
    NE8 4RP Gateshead
    Tyne & Wear
    Sekretär
    286 Rectory Road
    NE8 4RP Gateshead
    Tyne & Wear
    British72874140001
    TAYLOR, Nicholas Summers
    19 Shaftesbury Grove
    NE6 5JA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Sekretär
    19 Shaftesbury Grove
    NE6 5JA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British71247700001
    WALLACE, George William
    Rosedale Manor
    Harelaw
    DH9 8OB Stanley
    Co Durham
    Sekretär
    Rosedale Manor
    Harelaw
    DH9 8OB Stanley
    Co Durham
    BritishDirector11912770001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    PARKINSON, Philip Douglas
    Peacock Lodge
    Cleadon Lane
    SR6 7UX Cleadon Village
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    Peacock Lodge
    Cleadon Lane
    SR6 7UX Cleadon Village
    Tyne & Wear
    BritishDirector88282370001
    WALLACE, George William
    Rosedale Manor
    Harelaw
    DH9 8OB Stanley
    Co Durham
    Geschäftsführer
    Rosedale Manor
    Harelaw
    DH9 8OB Stanley
    Co Durham
    BritishDirector11912770001

    Hat PHILIP PARKINSON HEALTHCARE LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 20. Jan. 2006
    Geliefert am 27. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildngs fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Jan. 2006
    Geliefert am 27. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property known as land lying to the east of egton terrace birtley t/n TY366822,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Jan. 2006
    Geliefert am 27. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property known as land at tadema road south shields tyne and wear, t/n TY420873,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 10. Juni 2005
    Geliefert am 24. Juni 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 24. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 10. Juni 2005
    Geliefert am 16. Juni 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a land lying to the east of egton terrace, birtley t/no TY366822. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 16. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 10. Juni 2005
    Geliefert am 16. Juni 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a land at tadema road south shields t/no TY420873. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 16. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Juli 2004
    Geliefert am 08. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that land being land at westhoe south shields. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 08. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Juni 2003
    Geliefert am 17. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land lying to the east of egton terrace birtley known as the highlands gatshead tyne & wear t/n TY366822. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 17. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 13. Juni 2003
    Geliefert am 17. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 17. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge deed
    Erstellt am 08. Mai 2002
    Geliefert am 18. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums and other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h land lying to the east of egton terrace birtley title absolute t/n TY366822 and all its fixtures and by way of specific charge all the income in relation to the property and the proceeds of sale..assigned to the lender the related rights..fixed charge the equipment and goods and all fixtures fittings fixed plant and machinery..floating charge the undertaking all property and assets..assigned the goodwill and the intellectual property.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock PLC
    Transaktionen
    • 18. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Sept. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of contracts rights
    Erstellt am 08. Mai 2002
    Geliefert am 18. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All of the right title and interest present and future to and in and the full benefit of the contract and all rights benefits whatsoever in respect of the amounts recoverable and accruing to company under the contract including all claims or damages in respect of any breach of the contract by any party other than the company.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock PLC
    Transaktionen
    • 18. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Sept. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0