HAREL UNDERWRITING LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHAREL UNDERWRITING LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04049820
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HAREL UNDERWRITING LIMITED?

    • Nicht-Lebensversicherung (65120) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich HAREL UNDERWRITING LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    St Clare House
    30-33 Minories
    EC3N 1PE London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HAREL UNDERWRITING LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LIFTFIRST LIMITED09. Aug. 200009. Aug. 2000

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HAREL UNDERWRITING LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für HAREL UNDERWRITING LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für HAREL UNDERWRITING LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    3 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Kenneth Davidson als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Aug. 2013

    Kapitalaufstellung am 12. Aug. 2013

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Yair Hamburger am 09. Aug. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mark Kiedish am 09. Aug. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Gideon Judah Hamburger am 09. Aug. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Kenneth Muir Davidson am 09. Aug. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mark Kiedish am 09. Aug. 2010

    1 SeitenCH03

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288a

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    6 SeitenAA

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    6 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von HAREL UNDERWRITING LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    KIEDISH, Mark
    St Clare House
    30-33 Minories
    EC3N 1PE London
    Sekretär
    St Clare House
    30-33 Minories
    EC3N 1PE London
    British139932300001
    HAMBURGER, Gideon Judah
    St Clare House
    30-33 Minories
    EC3N 1PE London
    Geschäftsführer
    St Clare House
    30-33 Minories
    EC3N 1PE London
    IsraelIsraeli72257130001
    HAMBURGER, Yair
    St Clare House
    30-33 Minories
    EC3N 1PE London
    Geschäftsführer
    St Clare House
    30-33 Minories
    EC3N 1PE London
    IsraelIsraeli72862650001
    KIEDISH, Mark
    St Clare House
    30-33 Minories
    EC3N 1PE London
    Geschäftsführer
    St Clare House
    30-33 Minories
    EC3N 1PE London
    EnglandBritish139932300001
    RUPAL, Raj Gopal
    30 Fernhall Drive
    Redbridge
    IG4 5BW Ilford
    Essex
    Sekretär
    30 Fernhall Drive
    Redbridge
    IG4 5BW Ilford
    Essex
    British4289680001
    BLG (PROFESSIONAL SERVICES) LIMITED
    7th Floor Beaufort House
    15 St Botolph Street
    EC3A 7NJ London
    Sekretär
    7th Floor Beaufort House
    15 St Botolph Street
    EC3A 7NJ London
    39680630001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    DAVIDSON, Kenneth Muir
    St Clare House
    30-33 Minories
    EC3N 1PE London
    Geschäftsführer
    St Clare House
    30-33 Minories
    EC3N 1PE London
    United KingdomBritish6044290002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat HAREL UNDERWRITING LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge (in the terms of the lloyd's canadian trust deed "the trust deed" dated 26 september 1995. the instrument amends and restates the instrument dated 9 november 1977, as further amended by deeds dated 8 march 1978, 11 june 1989 and 28 december 2000)
    Erstellt am 25. Mai 2001
    Geliefert am 13. Juni 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All losses, claims, expenses, returns of premiums, re-insurance premiums and other outgoings payable at the date of the trust deed or at any time thereafter to become payable in connection with the canadian business of the company, including (1) the payment of any amount into an escrow fund or account to be held in respect of a particular claim of a policyholder or any other person and (2) all expenses whatsoever from time to time incurred by the company (formerly known as liftfirst limited) in connection with or arising out of the canadian business of the company including any salary, commission, other remuneration and reimbursement of outlays payable by the company to the agent or to any other person in connection with the conduct or winding up of the canadian business, the repayment of any outstanding indebtedness incurred by the company to meet valid expenses of the canadian business of such company, the company's due proportion of remuneration and reimbursement of expenses of the canadian trustee, the company's due proportion of any shortfall in the lloyd's canadian business fund (including any costs or expenses in respect thereto) and including also any taxes incurred in or by reason of the canadian business
    Kurze Angaben
    All property which may be (or should be) assigned or transferred to or received by the canadian trustee under the trust deed and any accumulations and increments from any such property. All premiums monies and other assets whatsoever belonging or payable at the date of the trust deed or thereafter at any time belonging or becoming payable to the company in connection with the canadian business and received on behalf of the company by the agent or any other person. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Trustees, Lloyd's and Certain Other Persons or Bodies (As Furtherdefined on Form M395)
    Transaktionen
    • 13. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    A charge dated 25 may 2001 in the terms of the lloyd's canadian margin fund trust deed ("the trust deed")
    Erstellt am 25. Mai 2001
    Geliefert am 13. Juni 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The payment of all claims of a holder of, or third party claimant under, any "policy in canada" to which the trust deed applies and which has been underwritten by the company (formerly known as liftfirst limited) or any other member or former member of lloyd's and for securing the other amounts and obligations referred to in the trust deed
    Kurze Angaben
    All interest of the company in present and future assets comprised in the margin fund constituted under the trust deed including the following (a) the contributions paid to the margin fund by or on behalf of the company pursuant to the lloyd's canadian business requirements of the council of lloyd'S.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Trust Corporation of Canada (The Trustee)
    Transaktionen
    • 13. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0