TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04050400 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Resolve Advisory Limited 22 York Buildings WC2N 6JU London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CITRUSDALE LIMITED | 10. Aug. 2000 | 10. Aug. 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 29. Apr. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 11 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 15. Jan. 2021 | 10 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom zum Resolve Advisory Limited 22 York Buildings London WC2N 6JU am 27. Jan. 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 30. Dez. 2019
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Aug. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Apr. 2018 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Aug. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kirk Dyson Davis als Geschäftsführer am 31. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Richard Smothers als Direktor am 31. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2017 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Aug. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 01. Mai 2016 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Aug. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von Lindsay Anne Keswick als Sekretär am 25. Apr. 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Claire Susan Stewart als Sekretär am 25. Apr. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Sunrise House Ninth Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 3JZ zum Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT am 07. März 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 22. Aug. 2015 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Robert Langford als Geschäftsführer am 26. Jan. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESWICK, Lindsay Anne | Sekretär | 22 York Buildings WC2N 6JU London Resolve Advisory Limited | 207524370001 | |||||||
| SMOTHERS, Richard | Geschäftsführer | IP33 1QT Bury St Edmunds Westgate Brewery Suffolk United Kingdom | United Kingdom | British | 242658700001 | |||||
| FREEMAN, Charles Truscott | Sekretär | 9 The Uplands AL5 2PG Harpenden Hertfordshire | British | 67008750001 | ||||||
| JONES, Henry | Sekretär | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 180592870001 | |||||||
| KENDALL, Timothy James | Sekretär | 31 Canterbury Close Erdington B23 7QL Birmingham West Midlands | British | 117397470002 | ||||||
| RUDD, Susan Clare | Sekretär | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 172446200001 | |||||||
| RUDD, Susan Clare | Sekretär | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
| STEWART, Claire Susan | Sekretär | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 181021590001 | |||||||
| STEWART, Claire Susan | Sekretär | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | Other | 130369890001 | ||||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Sekretär | High Street Pavenham MK43 7NJ Bedford Walnut Barn Bedfordshire | British | 135181230001 | ||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| BELL, Lucy Jane | Geschäftsführer | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 164754670001 | |||||
| BENNETT, Keith Norman | Geschäftsführer | Handley Wood Cottage Longwalls Lane DE56 2DU Belper Derbyshire | British | 6629880006 | ||||||
| CLARKE, Robert | Geschäftsführer | 71 Arthur Road SW19 7DN London | British | 40894440004 | ||||||
| DANDO, Stephen Peter | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750001 | |||||
| DAVIS, Kirk Dyson | Geschäftsführer | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 158484730001 | |||||
| DUTTON, Philip | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||
| FREEMAN, Charles Truscott | Geschäftsführer | 9 The Uplands AL5 2PG Harpenden Hertfordshire | England | British | 67008750001 | |||||
| GALLAGHER, Patrick James | Geschäftsführer | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | 205366190001 | |||||
| GODWIN-BRATT, Robert James | Geschäftsführer | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 170184800001 | |||||
| JONES, Karen Elisabeth Dind | Geschäftsführer | Paddock House 9 Spencer Park Wandsworth SW18 2SX London | United Kingdom | British | 47793260007 | |||||
| KEIGHTLEY SAWDON, Brian David | Geschäftsführer | 12 Dower Park SL4 4BQ Windsor Berkshire | British | 34704210001 | ||||||
| KELLY, Daryl Antony | Geschäftsführer | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 86246470001 | |||||
| KING, Thomas Rupert | Geschäftsführer | Upper Maisonette 29 Campden Grove W8 4JQ London | England | British | 55630790002 | |||||
| LANGFORD, Jonathan Robert | Geschäftsführer | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 135408140001 | |||||
| LAYTON, Matthew Robert | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Flat 49 8 New Crane Wharf New Crane Place E1W 3TX London | British | 900019870001 | ||||||
| MARGERRISON, Russell John | Geschäftsführer | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | 170590800001 | |||||
| MCCOSH, William | Geschäftsführer | Walnut House Burgage Lane NG25 0ER Southwell Nottinghamshire | England | British | 15819540001 | |||||
| MCDONALD, Robert James | Geschäftsführer | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | 42019620001 | ||||||
| PRESTON, Neil David | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 63043630002 | |||||
| RICHARDS, Martin Edgar | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 | ||||||
| RIKLIN, Cornel Carl | Geschäftsführer | 103 Barrow Gate Road Chiswick W4 4QS London | England | Swiss | 78412270001 | |||||
| SILLS, Jeffrey Alan | Geschäftsführer | 11 Heath Park Drive BR1 2WQ Bromley Kent | England | British | 94775770001 | |||||
| SMITH, Benedict James | Geschäftsführer | Flat 9 62 Eccleston Square SW1V 1PH London | United Kingdom | British | 75231110001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spirit Acquisition Properties Limited | 06. Apr. 2016 | Westgate Street IP33 1QT Bury St. Edmunds Westgate Brewery Suffolk England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Erstellt am 31. Okt. 2003 Geliefert am 12. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owned jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to each finance party under each finance document | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession to a security agreement dated 28 february 2003 | Erstellt am 25. Apr. 2003 Geliefert am 14. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities due or to become due from the obligor to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed security over freehold and leasehold property. By way of first fixed charge all present and future freehold and leasehold property and any rights under any other agreement or document which gives the company a right to occupy or use property wheresoever situate now or hereafter belonging to it. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 03. Sept. 2000 Geliefert am 15. Sept. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities due or to become due from the company to the beneficiaries under or pursuant to the senior finance documents and the mezzanine finance documents on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0