04050566 LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    Unternehmensname04050566 LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04050566
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von 04050566 LTD?

    • (7011) /
    • (7415) /

    Wo befindet sich 04050566 LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Griffins Tavistock House South
    Tavistock Square
    WC1H 9LG London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von 04050566 LTD?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ESPALIER PRIVATE EQUITY LIMITED18. Feb. 200318. Feb. 2003
    EARTHCO PROPERTY VENTURES LTD07. Feb. 200207. Feb. 2002
    EARTH PROPERTY VENTURES LIMITED 10. Aug. 200010. Aug. 2000

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von 04050566 LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Aug. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für 04050566 LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    31 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Sept. 2021

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. März 2021

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Sept. 2020

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. März 2020

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Sept. 2019

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. März 2019

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Sept. 2018

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. März 2018

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Sept. 2017

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. März 2017

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Sept. 2016

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. März 2016

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Sept. 2015

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. März 2015

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Sept. 2014

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. März 2014

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Sept. 2013

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. März 2013

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Sept. 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. März 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Sept. 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. März 2011

    5 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 26-28 Bedford Row London WC1R 4HE zum Griffins Tavistock House South Tavistock Square London WC1H 9LG am 02. Mai 2017

    2 SeitenAD01

    Wer sind die Geschäftsführer von 04050566 LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GENESYS 2000 LIMITED
    Northbourne Road
    BN22 8PW Eastbourne
    1-7 Archer House Britland Estate
    East Sussex
    Sekretär
    Northbourne Road
    BN22 8PW Eastbourne
    1-7 Archer House Britland Estate
    East Sussex
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer3859437
    149297910001
    GENESYS 2000 LIMITED
    Archer House
    Britland Estate, Northbourne Road
    BN22 8PW Eastbourne
    1-7
    East Sussex
    United Kingdom
    Sekretär
    Archer House
    Britland Estate, Northbourne Road
    BN22 8PW Eastbourne
    1-7
    East Sussex
    United Kingdom
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer3859437
    149020190001
    AUBREY, Phillip John
    Northbourne Road
    BN22 8PW Eastbourne
    Archer House
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Northbourne Road
    BN22 8PW Eastbourne
    Archer House
    East Sussex
    United KingdomBritishNone118968860001
    AUBREY, Phillip John
    Tavistock House South
    Tavistock Square
    WC1H 9LG London
    Griffins
    Geschäftsführer
    Tavistock House South
    Tavistock Square
    WC1H 9LG London
    Griffins
    United KingdomBritishCompany Director118968860001
    COMPANY CORPORATE TRANSFER LIMITED
    Archer House
    Britland Estate, Northbourne Road
    BN22 8PW Eastbourne
    1-7
    East Sussex
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Archer House
    Britland Estate, Northbourne Road
    BN22 8PW Eastbourne
    1-7
    East Sussex
    United Kingdom
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer4096692
    149020150001
    COMPANY CORPORATE TRANSFER LIMITED
    Northbourne Road
    BN22 8PW Eastbourne
    1-7 Archer House Britland Estate
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Northbourne Road
    BN22 8PW Eastbourne
    1-7 Archer House Britland Estate
    East Sussex
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer4049692
    148990940001
    BARRETT, Stephen David
    2 Hadley Gardens
    Chiswick
    W4 4NX London
    Sekretär
    2 Hadley Gardens
    Chiswick
    W4 4NX London
    BritishSurveyor72182090001
    GORRINGE, John Murray
    West Lodge
    Sheringham Park, Upper Sheringham
    NR26 8TB Sheringham
    Norfolk
    Sekretär
    West Lodge
    Sheringham Park, Upper Sheringham
    NR26 8TB Sheringham
    Norfolk
    British69141670001
    MUGGRIDGE, Caroline
    14c Mill Street
    NR25 6JB Holt
    Norfolk
    Sekretär
    14c Mill Street
    NR25 6JB Holt
    Norfolk
    BritishChartered Accountant81853860006
    CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000860001
    COLIN, Andrew Jeremy
    Flat 1 And 2
    10 Cadogan Gardens
    SW3 2RS London
    Geschäftsführer
    Flat 1 And 2
    10 Cadogan Gardens
    SW3 2RS London
    United KingdomBritishEducationalist109063830001
    GIBBS, Richard Howard
    42 Winchester Avenue
    NW6 7TU London
    Geschäftsführer
    42 Winchester Avenue
    NW6 7TU London
    EnglandBritishSurveyor41789570001
    PREST, Adrian John
    Chess Barn
    Park Farm
    BN5 9BA Henfield
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Chess Barn
    Park Farm
    BN5 9BA Henfield
    West Sussex
    United KingdomBritishProperty Advisor76077050001
    SYKES, John Buchanan
    8 Ashburnham Road
    BN21 2HU Eastbourne
    East Sussex
    Geschäftsführer
    8 Ashburnham Road
    BN21 2HU Eastbourne
    East Sussex
    United KingdomBritishAccountant26723180004

    Hat 04050566 LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge
    Erstellt am 15. Juni 2007
    Geliefert am 05. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from sladen estates (hamilton) limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The share in sladen estates (hamilton) limited, the proceeds of sale of the share adn all dividends interest and other distributions declared paid or made in respect of the share.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    Transaktionen
    • 05. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deposit deed
    Erstellt am 28. Nov. 2005
    Geliefert am 03. Dez. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £35,250.00 and all other monies due or to become due
    Kurze Angaben
    Rent deposit money of £35,250.00 and vat and interest accrued. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Substance Limited
    Transaktionen
    • 03. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Apr. 2005
    Geliefert am 05. Mai 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property known as land and buildings on the north east side of lowmoor road station park kirkby t/n NT363133,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 05. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Third party charge of securities (UK)
    Erstellt am 30. Sept. 2002
    Geliefert am 07. Okt. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from sladen estates (point 28) limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any stocks shares bonds warrants or securities (certified or uncertified) which are from time to time named in any schedule supplied by or on behalf of the company to the bank by reference to the charge of securities together with all income derived from and rights attaching to the same. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Third party legal charge
    Erstellt am 09. Mai 2002
    Geliefert am 20. Mai 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All the liabilities of earth enterprises limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the freehold land and buildings on the north side of maidstone road borough green platt sevenoaks t/n K167538. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 20. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Third party charge of securities
    Erstellt am 30. Juli 2001
    Geliefert am 11. Aug. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from sladen earth property ventures (lowmoor) limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any stocks shares bonds warrants and other securities (certificated or uncertificated) from time to time supplied by or on behalf of the company to the bank by reference to the third party charge and all income deriving therefrom and all rights attaching to the securities. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Third party charge of securities (UK)
    Erstellt am 27. März 2001
    Geliefert am 06. Apr. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All the liabilities of earth property ventures (leeds-west street) limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any stocks shares bonds warrants or securities (certificated or uncertificated) togetther with all income derived from and rights attached to the same. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Third party charge of securities (UK)
    Erstellt am 16. März 2001
    Geliefert am 04. Apr. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from earth property ventures (chadwell heath) limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge any stocks shares bonds warrants or securities (certificated or uncertificated) which are from time to time.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)

    Hat 04050566 LTD Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    05. März 2010Beginn der Liquidation
    07. Mai 2022Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen Mark Katz
    26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London
    Praktiker
    26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London
    Stephen Hunt
    Griffins
    Tavistock House South
    WC1H 9LG Tavistock Square
    London
    Praktiker
    Griffins
    Tavistock House South
    WC1H 9LG Tavistock Square
    London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0