CHENEZ LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CHENEZ LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04051925 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CHENEZ LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich CHENEZ LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Woodhouse Road Scunthorpe DN16 1BD Lincolnshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHENEZ LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CHENEZ LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Feb. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Feb. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Feb. 2018 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 040519250011 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Aug. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Change of details for Mr Shaun Griffiths as a person with significant control on 15. Aug. 2016 | 2 Seiten | PSC04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 040519250007 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 040519250008 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 040519250009 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 040519250011, erstellt am 31. Jan. 2017 | 20 Seiten | MR01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 040519250010 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 040519250010, erstellt am 03. Nov. 2016 | 22 Seiten | MR01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Aug. 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christine Elizabeth Chapman-Watkinson als Geschäftsführer am 01. Jan. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Aug. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CHENEZ LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIFFITHS, Shaun | Sekretär | Rudding Lane Folifoot HG3 1DQ Harrogate The Old Rudding School North Yorkshire United Kingdom | British | 74370360004 | ||||||
| GRIFFITHS, Shaun | Geschäftsführer | Rudding Lane Folifoot HG3 1DQ Harrogate The Old Rudding School North Yorkshire United Kingdom | England | British | 74370360006 | |||||
| FAULDS, Siobhan Alexia | Sekretär | 3 Margaret Street DN40 1JX Immingham North East Lincolnshire | British | 77590280001 | ||||||
| ASHBURTON REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 12-14 St Marys Street TF10 7AB Newport Shropshire | 900014760001 | |||||||
| TAYLOR & COMPANY | Sekretär | Temple Chambers 4 Abbey Road DN32 0HF Grimsby North East Lincolnshire | 42423080001 | |||||||
| CHAPMAN-WATKINSON, Christine Elizabeth | Geschäftsführer | Woodhouse Road Scunthorpe DN16 1BD Lincolnshire | United Kingdom | British | 153071840001 | |||||
| DAY, Richard Hamilton | Geschäftsführer | 6 Hawthorn View Off Kirklands Road BD17 6DU Baildon West Yorkshire | England | British | 192044870001 | |||||
| JABBARY, Christine | Geschäftsführer | Moor Lane Caistor LN7 6SN Market Rasen Moor Farmhouse Lincolnshire United Kingdom | England | British | 188229310001 | |||||
| STEENVOORDEN, Gary | Geschäftsführer | Wold Road DN19 7BT Barrow On Humber Nokomis North Lincolnshire England | England | British | 99535160002 | |||||
| AR NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 12-14 St Marys Street TF10 7AB Newport Shropshire | 900014750001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CHENEZ LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Shaun Griffiths | 06. Apr. 2016 | Folifoot HG3 1DQ Harrogate The Old Rudding School Rudding Lane North Yorkshire United Kingdom | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat CHENEZ LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 31. Jan. 2017 Geliefert am 02. Feb. 2017 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Land and buildings on the south side of woodhouse road scunthorpe t/no HS305004. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 03. Nov. 2016 Geliefert am 03. Nov. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 12. März 2014 Geliefert am 19. März 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung F/H woodhouse road scunthorpe t/no.HS305004. Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 12. März 2014 Geliefert am 14. März 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 09. Jan. 2014 Geliefert am 11. Jan. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung F/H property at woodhouse road scunthorpe t/no HS305004. Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 28. Feb. 2011 Geliefert am 01. März 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Floating charge all of its undertaking and all of its property asset and rights whatsoever and wheresoever situate,present and future see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental chattel mortgage | Erstellt am 28. Feb. 2011 Geliefert am 01. März 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The non-vesting assets being:- giben type prismatic 2 spt H115 cnc beam saw (yom 1999) c/w rear loading 4 off air tables & all associated equipment 374 99 380, giben type prismatic 2 spt H115 cnc beam saw (yom 2000) c/w rear loading 4 off air tables & all associated equipment 610 00 380, giben type prismatic 2 sp H100 front loading beam saw (yom 2000) c/w 4 off air tables & all associated equipment 520 00 380 (for details of further assets charged please refer to the form MG01). See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental chattel mortgage | Erstellt am 17. Feb. 2011 Geliefert am 23. Feb. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The assets. Brema type vektor cnc vertical drilling & laydown line (yom 2001). c/w 8 position tool changer infeed conveyor outfeed conveyer and all associated equipment OBR1/01. Costruzioni meccaniche type stp 96 cabinet press (yom 2001). c/w infeed conveyors outfeed conveyors and all associated equipment 011145. bag dust extraction (for further details of the assets charged please refer to the form MG01) see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 08. Dez. 2003 Geliefert am 22. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property being premises on woodhouse road, scunthorpe t/no HS305004 and HS305003. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Okt. 2003 Geliefert am 08. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 24. Okt. 2000 Geliefert am 28. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0