J L P B S GARRARD LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameJ L P B S GARRARD LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04056297
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von J L P B S GARRARD LIMITED?

    • (7011) /

    Wo befindet sich J L P B S GARRARD LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    257b Croydon Road
    BR3 3PS Beckenham
    Kent
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von J L P B S GARRARD LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    INTERCEDE 1630 LIMITED21. Aug. 200021. Aug. 2000

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von J L P B S GARRARD LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Nov. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für J L P B S GARRARD LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    12 Seiten4.72

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 409-411 Croydon Road Beckenham Kent BR3 3PP United Kingdom am 26. Mai 2011

    1 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    6 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 16. Mai 2011

    LRESEX

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2009

    11 SeitenAA

    Ernennung von Nicholas Nelson Sutton als Direktor

    2 SeitenAP01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Dez. 2009 bis 30. Nov. 2009

    1 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital26. Sept. 2010

    Kapitalaufstellung am 26. Sept. 2010

    • Kapital: GBP 1,000,001
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Imperial Property Company Limited am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH02

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Juni 2009 bis 30. Dez. 2009

    1 SeitenAA01

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2008

    11 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2007

    11 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    8 Seiten155(6)a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von J L P B S GARRARD LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FITZHERBERT, Ivan
    105 Saint Jamess Drive
    SW17 7RP London
    Sekretär
    105 Saint Jamess Drive
    SW17 7RP London
    British156978660001
    SUTTON, Nicholas Nelson
    257b Croydon Road
    BR3 3PS Beckenham
    Kent
    Geschäftsführer
    257b Croydon Road
    BR3 3PS Beckenham
    Kent
    EnglandBritish38171430011
    IMPERIAL PROPERTY COMPANY LIMITED
    Croydon Road
    BR3 3PP Beckenham
    409-411
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Croydon Road
    BR3 3PP Beckenham
    409-411
    Kent
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer3267652
    74138840003
    BOND, Christopher Joseph
    22 George Street
    MK17 9PY Woburn
    Bedfordshire
    Sekretär
    22 George Street
    MK17 9PY Woburn
    Bedfordshire
    British169680930001
    SMITH, David Ian
    35 Wimbolt Street
    E2 7BX London
    Sekretär
    35 Wimbolt Street
    E2 7BX London
    British5186170001
    WOODS, Ian Paul
    17 Wold Road
    Burton Latimer
    NN15 5PN Kettering
    Northamptonshire
    Sekretär
    17 Wold Road
    Burton Latimer
    NN15 5PN Kettering
    Northamptonshire
    British3535740003
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900004680001
    ARDERN, Derrick
    Twyvidales
    85 Eythrope Road
    HP17 8PH Stone Aylesbury
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Twyvidales
    85 Eythrope Road
    HP17 8PH Stone Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish44478670001
    BAIN, Colin Ronald
    Orion Villa
    63 Church Road
    DA7 4DL Bexleyheath
    Kent
    Geschäftsführer
    Orion Villa
    63 Church Road
    DA7 4DL Bexleyheath
    Kent
    United KingdomBritish89021130003
    BOND, Christopher Joseph
    22 George Street
    MK17 9PY Woburn
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    22 George Street
    MK17 9PY Woburn
    Bedfordshire
    EnglandBritish169680930001
    BRADLEY, Pauline Anne
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    Geschäftsführer
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    British122926460001
    BYRNE, James Anthony John
    4 Blythe Way
    B91 3EY Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    4 Blythe Way
    B91 3EY Solihull
    West Midlands
    British83499160001
    CUMMINGS, Peter Joseph
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    Geschäftsführer
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    ScotlandBritish68241910003
    DUNCOMBE, Roger John
    Croft House
    16 Faircross Way
    AL1 4SD St Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Croft House
    16 Faircross Way
    AL1 4SD St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish20158760001
    GILMAN, Thomas George
    70 High Street
    Clifford
    LS23 6HJ Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    70 High Street
    Clifford
    LS23 6HJ Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish103084110001
    LAMBERT, James Paul
    2 Portman Avenue
    East Sheen
    SW14 8NX London
    Geschäftsführer
    2 Portman Avenue
    East Sheen
    SW14 8NX London
    United KingdomBritish103062380001
    RICH, Michael William
    Hillfield
    Gorse Hill Farningham
    DA4 0JU Dartford
    Kent
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Hillfield
    Gorse Hill Farningham
    DA4 0JU Dartford
    Kent
    British900020860001
    SIMKIN, Richard William
    14 Little Plucketts Way
    IG9 5QU Buckhurst Hill
    Essex
    Geschäftsführer
    14 Little Plucketts Way
    IG9 5QU Buckhurst Hill
    Essex
    EnglandBritish13432460001
    TURNER, Nigel Alan, Mr.
    Strood Gate
    Wivelsfield Green
    RH17 7RY Haywards Heath
    10
    West Sussex
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Strood Gate
    Wivelsfield Green
    RH17 7RY Haywards Heath
    10
    West Sussex
    United Kingdom
    EnglandBritish71592210007
    WARNER, William
    2 Honeysuckle Gardens
    CR0 8XU Croydon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    2 Honeysuckle Gardens
    CR0 8XU Croydon
    British900019540001
    WEAR, Melanie Georgene
    Flat 10
    6 Berry Street
    EC1V 0AU London
    Geschäftsführer
    Flat 10
    6 Berry Street
    EC1V 0AU London
    New Zealander73865860001
    WHITE, Andrew Nicholas Howard
    10 South View
    KT19 7LA Epsom
    Surrey
    Geschäftsführer
    10 South View
    KT19 7LA Epsom
    Surrey
    British99292200001
    WOODS, Ian Paul
    17 Wold Road
    Burton Latimer
    NN15 5PN Kettering
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    17 Wold Road
    Burton Latimer
    NN15 5PN Kettering
    Northamptonshire
    EnglandBritish3535740003

    Hat J L P B S GARRARD LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 09. März 2007
    Geliefert am 15. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    30 garrard street, reading, f/h t/no BK184253. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Mai 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 09. März 2007
    Geliefert am 15. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Mai 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 29. Juli 2004
    Geliefert am 12. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property 4 and 6 cavendish place london t/n NGL734622 by way of fixed charge all interests in the new property or the proceeds of sale, the benefit of all options easements agreements for lease and other agreements, all plant and machinery and all rights and interests of the company under all agreements for purchase maintenance or use of plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent and Trustee for Thebeneficiaries
    Transaktionen
    • 12. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Apr. 2002
    Geliefert am 22. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security agent or to each other beneficiary (as defined) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 22. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Apr. 2001
    Geliefert am 17. Mai 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of any of the finance documents
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(In Its Capacity as Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 17. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Dez. 2000
    Geliefert am 14. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the finance documents
    Kurze Angaben
    All that f/h property being land in garrard street and merchant's place, reading t/n BK184253. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat J L P B S GARRARD LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    16. Mai 2011Beginn der Liquidation
    19. Juni 2012Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Tommaso Ahmad
    Bailey Ahmad Limited 257b Croydon Road
    BR3 3PS Beckenham
    Kent
    Praktiker
    Bailey Ahmad Limited 257b Croydon Road
    BR3 3PS Beckenham
    Kent
    Paul Bailey
    Bailey Ahmad Limited 257b Croydon Road
    BR3 3PS Beckenham
    Kent
    Praktiker
    Bailey Ahmad Limited 257b Croydon Road
    BR3 3PS Beckenham
    Kent

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0