PACKETEXCHANGE (METRO) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | PACKETEXCHANGE (METRO) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04063075 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PACKETEXCHANGE (METRO) LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich PACKETEXCHANGE (METRO) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Riverbank House 2 Swan Lane EC4R 3TT London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PACKETEXCHANGE (METRO) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
XCHANGEPOINT HOLDINGS LIMITED | 25. Aug. 2000 | 25. Aug. 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PACKETEXCHANGE (METRO) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für PACKETEXCHANGE (METRO) LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für PACKETEXCHANGE (METRO) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Aug. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Christopher Mckee am 25. Aug. 2014 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Richard Darnell Calder am 25. Aug. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher Turing Mckee am 25. Aug. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 35 Vine Street London EC3N 2AA United Kingdom* am 30. Mai 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Eric Swank als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * First Floor Vintage Yard 59-63 Bermondsey Street London SE1 3XF England* am 14. März 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Fourth Floor 2-4 Great Eastern Street London EC2A 3NT* am 27. Sept. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Richard Darnell Calder als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Christopher Mckee als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Eric Alan Swank als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Christopher Mckee als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Verdin als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PACKETEXCHANGE (METRO) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCKEE, Christopher | Sekretär | c/o Packetexchange (Metro) Limited 2 Swan Lane EC4R 3TT London Riverbank House United Kingdom | 161503190001 | |||||||
CALDER, Richard Darnell | Geschäftsführer | c/o Packetexchange (Metro) Limited 2 Swan Lane EC4R 3TT London Riverbank House United Kingdom | United States | American | Ceo | 161500230001 | ||||
MCKEE, Christopher Turing | Geschäftsführer | c/o Packetexchange (Metro) Limited 2 Swan Lane EC4R 3TT London Riverbank House United Kingdom | United States | American | Attorney | 161500200001 | ||||
COLES, Stephen James | Sekretär | 48 Ardmore Lane IG9 5SA Buckhurst Hill Essex | British | Chartered Accountant | 48921780001 | |||||
DWYER, Daniel John | Bevollmächtigter Sekretär | 6 Brimstone Close Chelsfield Park BR6 7ST Chelsfield Kent | British | 900003970001 | ||||||
FAULL, Michele Jean | Sekretär | Renrag Flowers Bottom Lane HP27 0PZ Speen Buckinghamshire | British | Company Director | 82737830001 | |||||
O'BRIEN, Kieron | Sekretär | Tilly Manor High Street West Harptree BS40 6EB Bristol Avon | British | 100281120001 | ||||||
VERDIN, Christopher Peter | Sekretär | 16 Coates Avenue SW18 2TH London | British | 61524630003 | ||||||
VERDIN, Christopher Peter | Sekretär | 16 Coates Avenue SW18 2TH London | British | Accountant | 61524630003 | |||||
LMG SERVICES LIMITED | Sekretär | 32-35 London Fruit Exchange Brushfield Street E1 6EU London | 51356760002 | |||||||
R.B.S. NOMINEES LIMITED | Sekretär | Challoner House 19 Clerkenwell Close EC1R 0RR London | 157017420001 | |||||||
ALMEIDA, Richard Phillip | Geschäftsführer | Swinley Coronation Road SL5 9LG Ascot Berkshire | England | English | Company Director | 36280330003 | ||||
BLACKALL, Laurence Charles Neil | Geschäftsführer | 2 Ravenna Road Putney SW15 6AW London | United Kingdom | British | Investor | 80624810001 | ||||
BLIGH, Alexander Marc | Geschäftsführer | 75b Nightingale Lane SW12 8LY London | British | Company Director | 48718950002 | |||||
COLES, Stephen James | Geschäftsführer | 48 Ardmore Lane IG9 5SA Buckhurst Hill Essex | England | British | Chartered Accountant | 48921780001 | ||||
DWYER, Daniel John | Geschäftsführer | Goldfinch Close Chelsfield BR6 6NF Orpington 14 Kent | United Kingdom | British | Company Registration Agent | 112335920001 | ||||
DWYER, Daniel James | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fieldstock Vicarage Road DA5 2AW Bexley Kent | British | 900019460001 | ||||||
FAULL, Michele Jean | Geschäftsführer | Renrag Flowers Bottom Lane HP27 0PZ Speen Buckinghamshire | British | Company Director | 82737830001 | |||||
ING, Mike | Geschäftsführer | 6 Lady Lane CM2 0TF Chelmsford Essex | United Kingdom | British | Company Director | 116048390001 | ||||
LUPBERGER, Dirk, Dr | Geschäftsführer | Oberfeldallee 8 Gruenwald D 82031 Germany | German | Director | 93342790001 | |||||
MACE, Richard Edward | Geschäftsführer | Peninsula Road 01451 Havard 38 Usa | United States | American | Company Director | 136970830001 | ||||
MACPHERSON, Ronald Thomas Stewart, Sir | Geschäftsführer | 27 Archery Close W2 2BE London | British | Company Director | 49140580001 | |||||
MITCHELL, Keith Niven | Geschäftsführer | 10 Priory Gardens PE9 2EG Stamford Lincolnshire | British | Company Chairman | 47803380001 | |||||
NABAVI, Annette Patricia, Dr | Geschäftsführer | Claytons Farmhouse Newick Lane TN20 6RE Mayfield East Sussex | United Kingdom | British | Company Director | 71771760001 | ||||
O'BRIEN, Kieron | Geschäftsführer | Tilly Manor High Street West Harptree BS40 6EB Bristol Avon | British | Company Director | 100281120001 | |||||
SHAW, Rupert Henry Gildroy | Geschäftsführer | 73 Archel Road W14 9QL London | British | Director | 83965350001 | |||||
SWANK, Eric Alan | Geschäftsführer | Vine Street EC3N 2AA London 35 United Kingdom | Usa | American | Cfo | 161500580001 | ||||
TEHRANIAN, Terrence Majid | Geschäftsführer | 12 Queen Anne Street W1G 9AU London | American | Managing Partner | 54315530002 | |||||
VELODY, Jason | Geschäftsführer | 1 Bousfield Road New Cross SE14 5TP London | United Kingdom | British | Director | 15341420002 | ||||
VERDIN, Christopher Peter | Geschäftsführer | 16 Coates Avenue SW18 2TH London | England | British | Accountant | 61524630003 | ||||
WILDE, Richard Brett | Geschäftsführer | 20 Summerhouse Lane UB9 6HX Harefield Middlesex | British | Chief Operating Officer | 80620510001 |
Hat PACKETEXCHANGE (METRO) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Mortgage debenture | Erstellt am 15. Feb. 2011 Geliefert am 23. Feb. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 30. Okt. 2009 Geliefert am 07. Nov. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 02. Nov. 2007 Geliefert am 21. Nov. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 15. Jan. 2007 Geliefert am 24. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 09. Aug. 2006 Geliefert am 16. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 17. Mai 2001 Geliefert am 30. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the rent deposit deed | |
Kurze Angaben The initial deposit of £10,656.25 made pursuant to the rent deposit deed together with all money from time to time withrawn in accordance with the rent deposit deed from the deposit account opened and maintained pursuant to the rent deposit deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0