SERVICED OFFICES UK GP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SERVICED OFFICES UK GP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04063878 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1020 Eskdale Road Winnersh RG41 5TS Wokingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CORPORATE CENTRES GP LIMITED | 15. März 2001 | 15. März 2001 |
| STONEMARTIN (GP) LIMITED | 29. Aug. 2000 | 29. Aug. 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Okt. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom St Helen's 1 Undershaft London EC3P 3DQ United Kingdom zum 1020 Eskdale Road Winnersh Wokingham RG41 5TS am 27. Dez. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 4 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kirsty Ann-Marie Wilman als Geschäftsführer am 02. Dez. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Karina Jane Bye als Direktor am 02. Dez. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Tebbutt als Geschäftsführer am 02. Dez. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Rowley Rose als Direktor am 02. Dez. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Julian Miles Cobourne als Geschäftsführer am 02. Dez. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jennifer Anne Lisbey als Geschäftsführer am 02. Dez. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Jennifer Anne Lisbey als Direktor am 15. Okt. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew James Torode als Geschäftsführer am 23. Aug. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2018 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Sept. 2018 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Matthew Torode als Direktor am 13. März 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Leonard Grose als Geschäftsführer am 13. März 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Tebbutt am 19. März 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Sept. 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr. Nicholas Tebbutt als Direktor am 28. Juli 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Catherine Jane Mccall als Geschäftsführer am 28. Juli 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | 1 Undershaft EC3P 3DQ London St Helen's United Kingdom |
| 1278390004 | ||||||||||
| BYE, Karina Jane | Geschäftsführer | 1 Undershaft EC3P 3DQ London St Helen's United Kingdom | United Kingdom | British | 239237640001 | |||||||||
| ROSE, David Rowley | Geschäftsführer | 1 Undershaft EC3P 3DQ London St Helen's United Kingdom | United Kingdom | British | 89567200001 | |||||||||
| LAXTON, Christopher James Wentworth, Mr | Sekretär | High House Ranworth Road Hemblington NR13 4PJ Norwich Norfolk | British | 62939740001 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| ASHCROFT, Jonathan Edwin | Geschäftsführer | Poultry EC2R 8EJ London No 1 Uk | United Kingdom | British | 131434980001 | |||||||||
| BURGESS, Quentin James Neilson | Geschäftsführer | The Red House Chelwood Vachery TN22 3HR Nutley East Sussex | England | British | 42896080002 | |||||||||
| BURGESS, Quentin James Neilson | Geschäftsführer | The Red House Chelwood Vachery TN22 3HR Nutley East Sussex | England | British | 42896080002 | |||||||||
| CLARK, Philip John | Geschäftsführer | 26 Bourne Avenue Southgate N14 6PD London | United Kingdom | British | 101932350001 | |||||||||
| COBOURNE, Julian Miles | Geschäftsführer | 1 Undershaft EC3P 3DQ London St Helen's United Kingdom | England | British | 198725060001 | |||||||||
| DAWSON, Robert George Maxwell | Geschäftsführer | Worrin Road Shenfield CM15 8DH Brentwood 64 Essex | England | British | 77316930001 | |||||||||
| DRYSDALE, James Ferguson | Geschäftsführer | Flat 5 2 Fair Street SE1 2XT London | British | 61174240003 | ||||||||||
| ELLIS, Philip Frederick | Geschäftsführer | Piglet Manner Bramerton Road, Burlingham NR14 7DE Norwich Norfolk | United Kingdom | British | 75296640001 | |||||||||
| GOTTLIEB, Julius | Geschäftsführer | 8 Southway Totteridge N20 8EA London | England | British | 32807790002 | |||||||||
| GROSE, David Leonard | Geschäftsführer | c/o Hermes 1 Portsoken Street E1 8HZ London Lloyds Chambers United Kingdom | United Kingdom | Australian | 120479020001 | |||||||||
| JONES, Richard Peter | Geschäftsführer | Tudor House 11 Lower Street CM24 8LN Stansted | England | British | 76584200002 | |||||||||
| LAXTON, Chris James Wentworth | Geschäftsführer | Poultry EC2R 8EJ London No 1 Uk | United Kingdom | British | 198871760001 | |||||||||
| LAXTON, Christopher James Wentworth, Mr | Geschäftsführer | High House Ranworth Road Hemblington NR13 4PJ Norwich Norfolk | United Kingdom | British | 62939740001 | |||||||||
| LINDSEY, Joel Mark Woodliffe | Geschäftsführer | Poultry EC2R 8EJ London No 1 Uk | United Kingdom | New Zealand | 140768720001 | |||||||||
| LINEHAM, Timothy Mark Vaughan | Geschäftsführer | Eastgate House Park Lane TN15 0JD Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 66505360002 | |||||||||
| LISBEY, Jennifer Anne | Geschäftsführer | 150 Cheapside EC2V 6ET London Hermes Investment Management United Kingdom | United Kingdom | British | 259968930001 | |||||||||
| MANSLEY, Nicholas John Fermor | Geschäftsführer | 4 Willis Road CB1 2AQ Cambridge | England | British | 73817060002 | |||||||||
| MCCALL, Catherine Jane | Geschäftsführer | 1 Undershaft EC3P 3DQ London St Helen's United Kingdom | United Kingdom | British | 204318160001 | |||||||||
| MCKEOWN, Audrey | Geschäftsführer | Poultry EC2R 8EJ London No 1 Uk | United Kingdom | Irish | 124787300002 | |||||||||
| SHAH, Nikunj Nalin | Geschäftsführer | Norval Road HA0 3TE Wembley 16 Middlesex Uk | United Kingdom | British | 131325870001 | |||||||||
| TEBBUTT, Nicholas, Mr. | Geschäftsführer | 1 Undershaft EC3P 3DQ London St Helens United Kingdom | United Kingdom | British | 228645590002 | |||||||||
| THODAY, Corin Leonard | Geschäftsführer | Poultry EC2R 8EJ London No 1 Uk | United Kingdom | British | 138095630001 | |||||||||
| TORODE, Matthew James | Geschäftsführer | Cheapside EC2U 6ET London 150 United Kingdom | United Kingdom | British | 196412900002 | |||||||||
| TURNER, Alex James | Geschäftsführer | Priory Way SG4 9BH Hitchin 12 Hertfordshire | United Kingdom | British | 110252440002 | |||||||||
| WILMAN, Kirsty Ann-Marie | Geschäftsführer | c/o Hermes Fund Managers Limited 1 Portsoken Street E1 8HZ London Lloyds Chambers England | England | British | 155163600002 | |||||||||
| WISE, David Andrew John | Geschäftsführer | 20 Parkway Southgate N14 6QU London | United Kingdom | British | 74016310001 | |||||||||
| WOMACK, Ian Bryan | Geschäftsführer | 116 Union Street NR1 2TG Norwich | United Kingdom | British | 33902000002 | |||||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwich Union (Shareholder Gp) Limited | 06. Apr. 2016 | Poultry EC2R 8EJ London No. 1 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat SERVICED OFFICES UK GP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 08. Dez. 2008 Geliefert am 16. Dez. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company as general partner on behalf of the partnership and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a temple circus temple way bristol t/no. BL97044 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Juli 2008 Geliefert am 22. Juli 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property k/a peter house st peter's square manchester t/no GM597635 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Juli 2008 Geliefert am 22. Juli 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property k/a 1 victoria square birmingham t/no WM172095 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Juli 2008 Geliefert am 22. Juli 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property k/a 45-48 (inclusive) swallow street birmingham T.no WM367351 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Juli 2008 Geliefert am 22. Juli 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property k/a land on the south side of swallow street birmingham t/no WM368514 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Juli 2008 Geliefert am 22. Juli 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The propert k/a the golden eagle corner of hill street and swallow street birmingham t/no WM389526. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. Juni 2004 Geliefert am 19. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property known as forbury square reading. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture containing fixed and floating charges | Erstellt am 25. Jan. 2002 Geliefert am 29. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All undertaking property and assets of the partnership whatsoever and wheresoever. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat SERVICED OFFICES UK GP LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0