SERVICED OFFICES UK GP LIMITED

SERVICED OFFICES UK GP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSERVICED OFFICES UK GP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04063878
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CORPORATE CENTRES GP LIMITED15. März 200115. März 2001
    STONEMARTIN (GP) LIMITED29. Aug. 200029. Aug. 2000

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    8 SeitenLIQ13

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Okt. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom St Helen's 1 Undershaft London EC3P 3DQ United Kingdom zum 1020 Eskdale Road Winnersh Wokingham RG41 5TS am 27. Dez. 2019

    1 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    4 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 10. Dez. 2019

    LRESSP

    Beendigung der Bestellung von Kirsty Ann-Marie Wilman als Geschäftsführer am 02. Dez. 2019

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mrs Karina Jane Bye als Direktor am 02. Dez. 2019

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Nicholas Tebbutt als Geschäftsführer am 02. Dez. 2019

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr David Rowley Rose als Direktor am 02. Dez. 2019

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Julian Miles Cobourne als Geschäftsführer am 02. Dez. 2019

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Jennifer Anne Lisbey als Geschäftsführer am 02. Dez. 2019

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Ms Jennifer Anne Lisbey als Direktor am 15. Okt. 2019

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Matthew James Torode als Geschäftsführer am 23. Aug. 2019

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2018

    2 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 18. Sept. 2018 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Matthew Torode als Direktor am 13. März 2018

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von David Leonard Grose als Geschäftsführer am 13. März 2018

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2017

    2 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Tebbutt am 19. März 2018

    2 SeitenCH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 18. Sept. 2017 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Ernennung von Mr. Nicholas Tebbutt als Direktor am 28. Juli 2017

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Catherine Jane Mccall als Geschäftsführer am 28. Juli 2017

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Sekretär
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer2084205
    1278390004
    BYE, Karina Jane
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    United KingdomBritish239237640001
    ROSE, David Rowley
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    United KingdomBritish89567200001
    LAXTON, Christopher James Wentworth, Mr
    High House Ranworth Road
    Hemblington
    NR13 4PJ Norwich
    Norfolk
    Sekretär
    High House Ranworth Road
    Hemblington
    NR13 4PJ Norwich
    Norfolk
    British62939740001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ASHCROFT, Jonathan Edwin
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Geschäftsführer
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomBritish131434980001
    BURGESS, Quentin James Neilson
    The Red House Chelwood Vachery
    TN22 3HR Nutley
    East Sussex
    Geschäftsführer
    The Red House Chelwood Vachery
    TN22 3HR Nutley
    East Sussex
    EnglandBritish42896080002
    BURGESS, Quentin James Neilson
    The Red House Chelwood Vachery
    TN22 3HR Nutley
    East Sussex
    Geschäftsführer
    The Red House Chelwood Vachery
    TN22 3HR Nutley
    East Sussex
    EnglandBritish42896080002
    CLARK, Philip John
    26 Bourne Avenue
    Southgate
    N14 6PD London
    Geschäftsführer
    26 Bourne Avenue
    Southgate
    N14 6PD London
    United KingdomBritish101932350001
    COBOURNE, Julian Miles
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    EnglandBritish198725060001
    DAWSON, Robert George Maxwell
    Worrin Road
    Shenfield
    CM15 8DH Brentwood
    64
    Essex
    Geschäftsführer
    Worrin Road
    Shenfield
    CM15 8DH Brentwood
    64
    Essex
    EnglandBritish77316930001
    DRYSDALE, James Ferguson
    Flat 5
    2 Fair Street
    SE1 2XT London
    Geschäftsführer
    Flat 5
    2 Fair Street
    SE1 2XT London
    British61174240003
    ELLIS, Philip Frederick
    Piglet Manner
    Bramerton Road, Burlingham
    NR14 7DE Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Piglet Manner
    Bramerton Road, Burlingham
    NR14 7DE Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish75296640001
    GOTTLIEB, Julius
    8 Southway
    Totteridge
    N20 8EA London
    Geschäftsführer
    8 Southway
    Totteridge
    N20 8EA London
    EnglandBritish32807790002
    GROSE, David Leonard
    c/o Hermes
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    Lloyds Chambers
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o Hermes
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    Lloyds Chambers
    United Kingdom
    United KingdomAustralian120479020001
    JONES, Richard Peter
    Tudor House
    11 Lower Street
    CM24 8LN Stansted
    Geschäftsführer
    Tudor House
    11 Lower Street
    CM24 8LN Stansted
    EnglandBritish76584200002
    LAXTON, Chris James Wentworth
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Geschäftsführer
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomBritish198871760001
    LAXTON, Christopher James Wentworth, Mr
    High House Ranworth Road
    Hemblington
    NR13 4PJ Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    High House Ranworth Road
    Hemblington
    NR13 4PJ Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish62939740001
    LINDSEY, Joel Mark Woodliffe
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Geschäftsführer
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomNew Zealand140768720001
    LINEHAM, Timothy Mark Vaughan
    Eastgate House
    Park Lane
    TN15 0JD Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    Eastgate House
    Park Lane
    TN15 0JD Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish66505360002
    LISBEY, Jennifer Anne
    150 Cheapside
    EC2V 6ET London
    Hermes Investment Management
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    150 Cheapside
    EC2V 6ET London
    Hermes Investment Management
    United Kingdom
    United KingdomBritish259968930001
    MANSLEY, Nicholas John Fermor
    4 Willis Road
    CB1 2AQ Cambridge
    Geschäftsführer
    4 Willis Road
    CB1 2AQ Cambridge
    EnglandBritish73817060002
    MCCALL, Catherine Jane
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    United KingdomBritish204318160001
    MCKEOWN, Audrey
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Geschäftsführer
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomIrish124787300002
    SHAH, Nikunj Nalin
    Norval Road
    HA0 3TE Wembley
    16
    Middlesex
    Uk
    Geschäftsführer
    Norval Road
    HA0 3TE Wembley
    16
    Middlesex
    Uk
    United KingdomBritish131325870001
    TEBBUTT, Nicholas, Mr.
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helens
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helens
    United Kingdom
    United KingdomBritish228645590002
    THODAY, Corin Leonard
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Geschäftsführer
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomBritish138095630001
    TORODE, Matthew James
    Cheapside
    EC2U 6ET London
    150
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Cheapside
    EC2U 6ET London
    150
    United Kingdom
    United KingdomBritish196412900002
    TURNER, Alex James
    Priory Way
    SG4 9BH Hitchin
    12
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Priory Way
    SG4 9BH Hitchin
    12
    Hertfordshire
    United KingdomBritish110252440002
    WILMAN, Kirsty Ann-Marie
    c/o Hermes Fund Managers Limited
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    Lloyds Chambers
    England
    Geschäftsführer
    c/o Hermes Fund Managers Limited
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    Lloyds Chambers
    England
    EnglandBritish155163600002
    WISE, David Andrew John
    20 Parkway
    Southgate
    N14 6QU London
    Geschäftsführer
    20 Parkway
    Southgate
    N14 6QU London
    United KingdomBritish74016310001
    WOMACK, Ian Bryan
    116 Union Street
    NR1 2TG Norwich
    Geschäftsführer
    116 Union Street
    NR1 2TG Norwich
    United KingdomBritish33902000002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Norwich Union (Shareholder Gp) Limited
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No. 1
    England
    06. Apr. 2016
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No. 1
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Company Limited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortRegister Of Companies
    Registrierungsnummer03783750
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat SERVICED OFFICES UK GP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 08. Dez. 2008
    Geliefert am 16. Dez. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company as general partner on behalf of the partnership and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a temple circus temple way bristol t/no. BL97044 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 16. Dez. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Juli 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Juli 2008
    Geliefert am 22. Juli 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a peter house st peter's square manchester t/no GM597635 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Juli 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Juli 2008
    Geliefert am 22. Juli 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a 1 victoria square birmingham t/no WM172095 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Juli 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Juli 2008
    Geliefert am 22. Juli 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a 45-48 (inclusive) swallow street birmingham T.no WM367351 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Sscotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Juli 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Juli 2008
    Geliefert am 22. Juli 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a land on the south side of swallow street birmingham t/no WM368514 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Juli 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Juli 2008
    Geliefert am 22. Juli 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The propert k/a the golden eagle corner of hill street and swallow street birmingham t/no WM389526.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Juli 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Juni 2004
    Geliefert am 19. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property known as forbury square reading. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Juli 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Erstellt am 25. Jan. 2002
    Geliefert am 29. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All undertaking property and assets of the partnership whatsoever and wheresoever. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 29. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Juli 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat SERVICED OFFICES UK GP LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    10. Dez. 2019Beginn der Liquidation
    18. Feb. 2021Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0