CARP (UK) 2 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CARP (UK) 2 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04066196 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CARP (UK) 2 LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich CARP (UK) 2 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | One Edison Rise, New Ollerton Newark NG22 9DP Nottinghamshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CARP (UK) 2 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ALNERY NO. 2088 LIMITED | 06. Sept. 2000 | 06. Sept. 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CARP (UK) 2 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 23. Apr. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CARP (UK) 2 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | 4.71 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 5 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 23. März 2016
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 23. Apr. 2015 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Inglett am 01. Sept. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 24. Apr. 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 25. Apr. 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Martin Peter Dalby am 17. Apr. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Martin Peter Dalby am 17. Apr. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 26. Apr. 2012 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CARP (UK) 2 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGH-DEHAL, Rajbinder | Sekretär | Knighton Rise LE2 2RE Oadby 6 Leicestershire United Kingdom | Other | 138962680001 | ||||||
| DALBY, Martin Peter | Geschäftsführer | The Old Granary, Went Farm Main Street, Womersley DN6 9BQ Doncaster South Yorkshire | United Kingdom | British | 83381250004 | |||||
| INGLETT, Paul | Geschäftsführer | New Ollerton NG22 9DP Newark One Edison Rise Nottinghamshire | United Kingdom | British | 81617110003 | |||||
| BRADSHAW, Andrew Philip | Sekretär | The Chapel House Haseley Road OX44 7PP Little Milton Oxfordshire | British | 114356940001 | ||||||
| BRIGGS, Hugh Alexander | Sekretär | 6 Austral Street Kennington SE11 4SJ London | British | 79558350002 | ||||||
| CUMMINS, Diarmuid | Sekretär | Westfieldbury Westland Green SG11 2AL Little Hadham Hertfordshire | British | 78791890003 | ||||||
| FRANCE, Malcolm Ronald | Sekretär | 34 Tybenham Road SW19 3LA London | British | 50060390001 | ||||||
| GRAHAM, Annabel Susan | Sekretär | 9 Manor Mount SE23 3PY London | British | 108637650001 | ||||||
| PARKER, Timothy Hugh | Sekretär | Kirton Road Egmanton NG2 0HF Newark Twitchell Barn Nottinghamshire | British | 138694570001 | ||||||
| STOLL, Peter Huston | Sekretär | Flat 5 20 Earls Court Square SW5 9DN London | United States | 107030970001 | ||||||
| ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 9 Cheapside EC2V 6AD London | 900002920001 | |||||||
| MOURANT & CO SECRETARIES LIMITED | Sekretär | PO BOX 87 22 Grenville Street JE4 8PX St Helier Jersey Channel Islands | 73684100001 | |||||||
| BARATTA, Joseph Patrick | Geschäftsführer | One Edison Rise New Ollerton NG22 9DP Newark Nottinghamshire | Other | 94259330004 | ||||||
| BONSALL, Margaret Ruth | Geschäftsführer | Horton Priory Monks Horton TN25 6DZ Ashford Kent | England | British | 69588940001 | |||||
| CASTLEDINE, Trevor Vaughan | Geschäftsführer | 22 Woodhayes Road Wimbledon SW19 4RF London | British | 98778780002 | ||||||
| CHAPMAN, Julia Anne Jennifer | Geschäftsführer | Vincent Hall Becquet Vincent Trinity JE3 5FG Jersey | United Kingdom | British | 51408760001 | |||||
| DALBY, Martin Peter | Geschäftsführer | 12 Easthorpe NG25 0HY Southwell Nottinghamshire | British | 83381250001 | ||||||
| DALE, Manjit | Geschäftsführer | 84 Highgate West Hill N6 6LU London | England | British | 69966070002 | |||||
| DAVIES, Nicola Claire | Geschäftsführer | Roche Du Lion La Grande Route De La Cote JE3 6DR Gorey St Martin Jersey | British | 53592710004 | ||||||
| EIGHTEEN, Stephen Brian | Geschäftsführer | Flat 56 Cinnabar Wharf Central 24 Wapping High Street E1W 1NQ London | United Kingdom | British | 76313640003 | |||||
| ESSEX CATER, Gareth | Geschäftsführer | 11 Duhamel Place St Helier JE2 4TP Jersey | British | 91555540001 | ||||||
| FRANCE, Malcolm Ronald | Geschäftsführer | 34 Tybenham Road SW19 3LA London | United Kingdom | British | 50060390001 | |||||
| HAWKES, Edward Jonathan Cameron | Geschäftsführer | 143 Taybridge Street SW11 5PY London | United Kingdom | British | 93239900002 | |||||
| JONAS, Marc Nicholas | Geschäftsführer | Flat 2 89 Holland Park W11 3RZ London | England | British | 55841850004 | |||||
| MCINTOSH, William Alan | Geschäftsführer | 7 Earls Terrace Kensington W8 6LP London | British | 46361590002 | ||||||
| MOY, Neal St John | Geschäftsführer | 1 Highberry ME19 5QT Leybourne Kent | British | 98781970001 | ||||||
| PIKE, Chad Rustan | Geschäftsführer | 25 Burnsall Street SW3 3SR London | United Kingdom | British | 87606860002 | |||||
| PURSLOW, Christian Mark Cecil | Geschäftsführer | The Grove Warren Park Coombe Hill KT2 7HX Kingston Upon Thames | United Kingdom | British | 83244210001 | |||||
| ROBERTSON, Stephen James | Geschäftsführer | 1 Hereford House 13 Lauriston Road SW19 4JJ London | British | 78505200001 | ||||||
| SPENCER CHURCHILL, Edward Albert Charles, Lord | Geschäftsführer | 1 Shepherds Place Upper Brook Street W1K 6ED London | England | British | 54889660001 | |||||
| STOLL, Peter Huston | Geschäftsführer | Flat 5 20 Earls Court Square SW5 9DN London | United States | 107030970001 | ||||||
| WILSON, Christopher | Geschäftsführer | Ilex Wood 23 Clare Hill KT10 9NB Esher Surrey | British | 103272700001 | ||||||
| ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 9 Cheapside EC2V 6AD London | 900002920001 | |||||||
| ALNERY INCORPORATIONS NO 2 LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 9 Cheapside EC2V 6AD London | 900002910001 |
Hat CARP (UK) 2 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Borrower deed of charge | Erstellt am 28. Feb. 2012 Geliefert am 20. März 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any borrower secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben For details of property charged please see form MG01 fixed and floating charge over all property and assets present and future, including shares, insurances, goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Securitisation floating charge debenture | Erstellt am 19. Juni 2007 Geliefert am 04. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Floating charge all present and future assets property and undertaking (save for any assets situate in jersey). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Juni 2007 Geliefert am 04. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Intercreditor deed | Erstellt am 19. Juni 2007 Geliefert am 05. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben If an obligor makes any payment in cash or in kind on account of or for the purchase or other acquisition of all or any part of the secured debt or unsecured debt or any secured creditor or un secured creditor receives all or any amount in cash or in kind of the secured debt or unsecured debt as applicable. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security over shares deed | Erstellt am 19. Juni 2007 Geliefert am 04. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the tax covenant benficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The charged portfolio meaning in relation to the company its charged shares and related assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Nov. 2002 Geliefert am 15. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed equitable charge all securities belonging to the company and by way of floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Aug. 2001 Geliefert am 05. Sept. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations due or to become due from any obligor (as defined) to the chargee as trustee for the secured parties (as defined) (the "trustee") under the facility documents or b team loan documents or the long term facility documentation (all as defined) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. März 2001 Geliefert am 19. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All indebtedness and other liabilities due or to become due from each obligor (as defined) under or in connection with the senior finance documents (as defined) to the chargee as security agent and/or the senior finance parties (as defined) and/or any receiver on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CARP (UK) 2 LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0