RMAC 2000-NS3
Überblick
Unternehmensname | RMAC 2000-NS3 |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital |
Unternehmensnummer | 04070211 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von RMAC 2000-NS3?
- (6523) /
Wo befindet sich RMAC 2000-NS3?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 5 Arlington Square Downshire Way RG12 1WA Bracknell Berkshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von RMAC 2000-NS3?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
RMAC 2000-NS3 LIMITED | 24. Sept. 2009 | 24. Sept. 2009 |
RMAC 2000-NS3 PLC | 12. Sept. 2000 | 12. Sept. 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RMAC 2000-NS3?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für RMAC 2000-NS3?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jefrey Lundgren als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 14 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Zustimmung zur Umwandlung | 1 Seiten | FOA-RR | ||||||||||
Bescheinigung über die Umregistrierung von beschränkt haftend in unbeschränkt haftend | 1 Seiten | CERT3 | ||||||||||
Neuregistrierung von Gesellschaftsvertrag und Satzung | 13 Seiten | MAR | ||||||||||
Umwandlung von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung | 2 Seiten | RR05 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Eileen Mcmillan als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
Bescheinigung über die Umregistrierung von einer Aktiengesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 1 Seiten | CERT10 | ||||||||||
Neuregistrierung von Gesellschaftsvertrag und Satzung | 13 Seiten | MAR | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 53 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von RMAC 2000-NS3?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMPSON, Phillip Bertram | Sekretär | 16 Gatscombe Crescent Hanover Park SL5 7HA Ascot | British | Solicitor | 54705580002 | |||||
BLIGHT, Godfrey | Geschäftsführer | Arlington Square Downshire Way RG12 1WA Bracknell 5 Berkshire | United Kingdom | British | Director | 135102120001 | ||||
EDMONDS, Karen Britt | Sekretär | Badgers Barn Farthings Paddock BA7 7QA Alford Somerset | British | 42484650004 | ||||||
HAMZEHPOUR, Tammy | Sekretär | 7816 Bush Lake Drive Bloomington Minnesota Mn 55438 Usa | American | Joint Secretary | 64501790002 | |||||
ACHESON, William Brian | Geschäftsführer | Eastern Gate Brants Bridge RG12 9BZ Bracknell Berkshire | American | Director | 100315920003 | |||||
APPEL, Robert Louis | Geschäftsführer | 2 Sheridan Grange Broomhall Lane SL5 0BX Sunningdale Berkshire | American | Director | 86709370001 | |||||
BRADLEY, Colin Walter | Geschäftsführer | Williamsgate The Street RG27 0PJ Eversley Hampshire | British | Finance Director | 70001440003 | |||||
DUGGLEBY, Colin | Geschäftsführer | Red Cottages Pilcot Hill RG27 8SZ Dogmersfield Hampshire | British | Director | 69027230001 | |||||
HIGGINS, Christopher James | Geschäftsführer | 24 Ennismore Avenue GU1 1SR Guildford Surrey | British | Finance Director | 115417740001 | |||||
LUNDGREN, Jefrey Andrew | Geschäftsführer | Arlington Square Downshire Way RG12 1WA Bracknell 5 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 130391340002 | ||||
MCMILLAN, Eileen | Geschäftsführer | Arlington Square Downshire Way RG12 1WA Bracknell 5 Berkshire | British | Director | 118951850003 | |||||
NORDEEN, Christopher Jon | Geschäftsführer | 9413 Brooke Drive Bethesda Maryland 20817 2109 Usa | German | Director | 61535870005 | |||||
SEARLE, Barry Roy | Geschäftsführer | Eastern Gate Brants Bridge RG12 9BZ Bracknell Berkshire | British | Director | 70897720003 |
Hat RMAC 2000-NS3 Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Deed of amendment | Erstellt am 30. Sept. 2005 Geliefert am 17. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the issuer to the trustee and/or any receiver and to ambac and to each of the other secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed security with full title guarantee all right title interest and benefit in the english mortgage loans and the english mortgages in the mortgage pool and the title deeds and documents relating to the property in england and wales. All right tiel and interest in the scottish trust property, the northern irish mortgage loans, the charged obligation documents, floating chargeall undertaking property and assets present and future,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignation in security (incorporating intimation thereof) | Erstellt am 01. Dez. 2000 Geliefert am 15. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities whatsoever due or to become due from the company to the chargee and/or any receiver (as defined) under the deed of charge (as defined),the trust deed (as defined) or the conditions at the times and in the manner provided therein;under or in respect of the notes (as defined);under the ambac financial guarantee insurance policy,the premium letter and the insurance and indemnity agreement (all terms as defined) and also under the transaction documents (as defined) and all other monies and liabilities whatsoever due or to become due from the company to each of the other secured creditors (as defined) in accordance respectively with each of the other documents (as defined) | |
Kurze Angaben All right,title and interest in and to the beneficial interest in the additional scottish trust property as defined in the supplemental declaration under clause 5.10 of the mortgage sale agreement,as defined. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge and assignment (as defined) | Erstellt am 09. Nov. 2000 Geliefert am 14. Nov. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the deed of charge,the trust deed or the conditions at the times and in the manner provided therein,under or in respect of the notes,to ambac under the premium letter and the insurance and indemnity agreement,to the trustee under the transaction documents and all monies and liabilities whatsoever which from time to time become due,owing or payable by the issuer to each of the other secured creditors in accordance respectively with each of the other documents (all terms as defined) | |
Kurze Angaben First fixed equitable charge over all right,title,interest and benefit in,to and under the english mortgage loans and the english mortgages (as defined) and all monies payable under the same and the benefit of all covenants relating thereto; all powers and remedies and title deeds,documents relating to the properties in england and wales and any consents,postponements,reports,opinions,certificates and other statements of fact or opinion. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0