FIFTHGRANGE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | FIFTHGRANGE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04071712 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FIFTHGRANGE LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich FIFTHGRANGE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Witan Gate House 500-600 Witan Gate MK9 1BA Milton Keynes United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FIFTHGRANGE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 27. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FIFTHGRANGE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Damian Garry Mcgloughlin am 12. Okt. 2022 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Charles Coleman am 12. Okt. 2022 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simone Tudor als Sekretär am 31. Aug. 2022 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juni 2022 mit Aktualisierungen | 7 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Homebase (Uk&I) Holdings Limited as a person with significant control on 15. Dez. 2021 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Cessation of Homebase Group Limited as a person with significant control on 15. Dez. 2021 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Andrew Charles Coleman am 15. Dez. 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Damian Garry Mcgloughlin am 15. Dez. 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 14. Dez. 2021
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Dez. 2020 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Dez. 2019 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juni 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juni 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Dez. 2018 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Juni 2019 bis 30. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2018 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Ms Simone Tudor als Sekretär am 03. Jan. 2019 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 28 Seiten | MA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FIFTHGRANGE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A G SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 60 Chiswell Street EC1Y 4AG London Milton Gate England |
| 90084920001 | ||||||||||
| COLEMAN, Andrew Charles | Geschäftsführer | 500-600 Witan Gate MK9 1BA Milton Keynes Witan Gate House United Kingdom | England | British | 252067350001 | |||||||||
| MCGLOUGHLIN, Damian Garry | Geschäftsführer | 500-600 Witan Gate MK9 1BA Milton Keynes Witan Gate House United Kingdom | United Kingdom | British | 242086250008 | |||||||||
| HAMILTON, Deborah Pamela | Sekretär | Avebury 489-499 Avebury Boulevard MK9 2NW Milton Keynes | 190890130001 | |||||||||||
| MCKELVEY, Penelope Ann | Sekretär | Avebury 489-499 Avebury Boulevard MK9 2NW Milton Keynes | 179886780001 | |||||||||||
| PARKER, Philip Alexander | Sekretär | Avebury 489-499 Avebury Boulevard MK9 2NW Milton Keynes | British | 202472990003 | ||||||||||
| SHENTON, Paul Henry | Sekretär | 25 Gilmais Bookham KT23 4RP Leatherhead Surrey | British | 64486620001 | ||||||||||
| TUDOR, Simone | Sekretär | 500-600 Witan Gate MK9 1BA Milton Keynes Witan Gate House United Kingdom | 255103480001 | |||||||||||
| WILLIS, Michael Haydn Allen | Sekretär | 32 Old Oak Drive NN12 8DN Silverstone Northamptonshire | British | 2684970005 | ||||||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||||||
| ADAMS, David William | Geschäftsführer | Avebury 489-499 Avebury Boulevard MK9 2NW Milton Keynes | England | British | 153463840001 | |||||||||
| BENTLEY, Gordon Andrew | Geschäftsführer | 7 Hollybush Lane AL5 4AL Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | 43125610002 | |||||||||
| BOYS, Rodney John | Geschäftsführer | 500-600 Witan Gate MK9 1BA Milton Keynes Witan Gate House United Kingdom | United Kingdom | Australian | 204065540002 | |||||||||
| DAVIS, Donald Fuller | Geschäftsführer | Avebury 489-499 Avebury Boulevard MK9 2NW Milton Keynes | England | American | 153470640001 | |||||||||
| DAVIS, Peter-John Charles | Geschäftsführer | 500-600 Witan Gate MK9 1BA Milton Keynes Witan Gate House United Kingdom | United Kingdom | Australian | 240193510002 | |||||||||
| FULLER, Neil Frank | Geschäftsführer | Rye House Icknield Way HP23 4JU Tring Hertfordshire | United Kingdom | British | 71239990003 | |||||||||
| GRESHAM, Nicholas John | Geschäftsführer | Avebury 489-499 Avebury Boulevard MK9 2NW Milton Keynes | United Kingdom | British | 91773790001 | |||||||||
| HAMILTON, Deborah Pamela | Geschäftsführer | Avebury 489-499 Avebury Boulevard MK9 2NW Milton Keynes | United Kingdom | British | 116752570006 | |||||||||
| HAYDON, David James | Geschäftsführer | 500-600 Witan Gate MK9 1BA Milton Keynes Witan Gate House United Kingdom | England | British | 329593090001 | |||||||||
| HOLMES, Colin John | Geschäftsführer | The Stone House Welford Road NN6 8SJ Thornby Northamptonshire | British | 30687300002 | ||||||||||
| LAYTON, Matthew Robert | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Flat 49 8 New Crane Wharf New Crane Place E1W 3TX London | British | 900019870001 | ||||||||||
| LOVERING, John David | Geschäftsführer | 75 Capital Wharf High Street Wapping E1W 1LY London | British | 73573160001 | ||||||||||
| PARKER, Philip Alexander | Geschäftsführer | Avebury 489-499 Avebury Boulevard MK9 2NW Milton Keynes | United Kingdom | British | 202472990003 | |||||||||
| POTTER, Cheryl | Geschäftsführer | 175 Hillcrest KT13 8AS Weybridge Surrey | British | 75177990001 | ||||||||||
| RICHARDS, Martin Edgar | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 | ||||||||||
| SELLARS, Ian | Geschäftsführer | 1 Ranelagh Avenue SW6 3PJ London | United Kingdom | British | 107731430001 | |||||||||
| SHENTON, Paul Henry | Geschäftsführer | Avebury 489-499 Avebury Boulevard MK9 2NW Milton Keynes | England | British | 64486620001 | |||||||||
| SHERWOOD, Charles Nigel Cross | Geschäftsführer | Cavewood Rectory Lane SG3 6RD Datchworth Hertfordshire | United Kingdom | British | 142567110001 | |||||||||
| TEMPLEMAN, Robert William | Geschäftsführer | Greenlands Bellwood Court ME3 8RT St. Mary Hoo Kent | British | 75683610001 | ||||||||||
| WOODHOUSE, Christopher Kevin | Geschäftsführer | 25 Chester Row SW1W 9JF London | British | 48827150004 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FIFTHGRANGE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homebase (Uk&I) Holdings Limited | 15. Dez. 2021 | 3rd Floor 11-12 St James's Square SW1Y 4LB London Suite 1 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Homebase Group Limited | 01. Aug. 2016 | 500-600 Witan Gate MK9 1BA Milton Keynes Witan Gate House United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat FIFTHGRANGE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 09. Nov. 2018 Geliefert am 15. Nov. 2018 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung See clause 3.1 of the debenture, which creates a fixed charge over any right, title or interest which the company has now or may subsequently acquire to or in any land (as defined in the debenture). See clause 3.9 of the debenture, which creates a fixed charge over all intellectual property rights (as defined in the debenture) (including all fees, royalties and other rights of every kind relating to or deriving from such rights) such as:. Country mark status app no. App date reg no.. United kingdom. Apotments registered 2544622 14-apr-2010 2544622. united kingdom. Compot registered 2312248 03-oct-2002 2312248. hong kong duracoat registered 300974160 16-oct-2007 300974160. please also see schedule 6 (specified intellectual property) within the debenture for further details (this schedule includes further charged intellectual property rights). Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 01. Nov. 2018 Geliefert am 06. Nov. 2018 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Not applicable. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. März 2001 Geliefert am 21. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All indebtedness and other liabilities due or to become due from the company to all or any of the finance parties (as defined) and/or any receiver (as defined) under all or any of the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0