SOURCE BIOSCIENCE UK LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SOURCE BIOSCIENCE UK LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04078501 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SOURCE BIOSCIENCE UK LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich SOURCE BIOSCIENCE UK LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 Orchard Place Nottingham Business Park NG8 6PX Nottingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SOURCE BIOSCIENCE UK LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MEDICAL SOLUTIONS (NOTTINGHAM) LIMITED | 12. Juli 2007 | 12. Juli 2007 |
| PATHLORE LTD | 19. Apr. 2001 | 19. Apr. 2001 |
| ADVANCED DIAGNOSTIC SOLUTIONS LIMITED | 27. Nov. 2000 | 27. Nov. 2000 |
| ADVANCED DIAGNOSTIC LABORATORIES LIMITED | 24. Okt. 2000 | 24. Okt. 2000 |
| ANGLIA TELECOMMUNICATIONS LIMITED | 26. Sept. 2000 | 26. Sept. 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SOURCE BIOSCIENCE UK LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 30. Dez. 2025 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2024 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für SOURCE BIOSCIENCE UK LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 09. Jan. 2027 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 23. Jan. 2027 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 09. Jan. 2026 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für SOURCE BIOSCIENCE UK LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Jan. 2026 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2024 | 32 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Jan. 2025 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 34 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Jan. 2024 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anthony James Ratcliffe als Geschäftsführer am 27. Sept. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Ernennung von Mrs Amanda Louise Barlow als Direktor am 27. Sept. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 35 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Jan. 2023 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Eintragung der Belastung 040785010006, erstellt am 22. Nov. 2022 | 73 Seiten | MR01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Michael Kirkham als Geschäftsführer am 26. Sept. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Sept. 2022 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 36 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 33 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Sept. 2021 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Anthony Ratcliffe am 22. Juli 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||||||
Ernennung von Mr David Michael Kirkham als Direktor am 16. Juni 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Russell Steven Wheatcroft als Geschäftsführer am 15. Juni 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 040785010004 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 040785010005 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||||||
Ernennung von Mr Anthony Ratcliffe als Direktor am 17. Nov. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 29 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 22. Sept. 2020
| 2 Seiten | SH19 | ||||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SOURCE BIOSCIENCE UK LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARLOW, Amanda Louise | Geschäftsführer | Orchard Place Nottingham Business Park NG8 6PX Nottingham 1 Nottinghamshire United Kingdom | England | British | 121964690002 | |||||
| LECOQUE, Jay Charles | Geschäftsführer | 1 Orchard Place Nottingham Business Park NG8 6PX Nottingham | United States | American | 74368360024 | |||||
| ASH, Nicholas Watson, Dr | Sekretär | Orchard Place, Nottingham Business Park NG8 6PX Nottingham 1 United Kingdom | British | 115599370001 | ||||||
| ASTLE, Michael John | Sekretär | 1 Orchard Place Nottingham Business Park NG8 6PX Nottingham | 231349270001 | |||||||
| JOHNSTON, Neil Gerard, Dr | Sekretär | 14 Long Furlong Over CB4 5PG Cambridge | British | 321751730001 | ||||||
| LONGSTAFFE, Andrew David | Sekretär | 320 Drub Lane Gomersal BD19 4BX Bradford West Yorkshie | British | 197462400001 | ||||||
| LONGSTAFFE, Andrew David | Sekretär | 171 Drub Lane Gomersal BD19 4BZ Bradford West Yorkshire | British | 52045100001 | ||||||
| MINSHALL, Mark Richard | Sekretär | 56 Rivergreen Crescent Bramcote NG9 3ET Nottingham | British | 75245770002 | ||||||
| HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London | 67382580002 | |||||||
| RUTLAND SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Rutland House 148 Edmund Street B3 2JR Birmingham | 900005290001 | |||||||
| AGNEW, James Douglas | Geschäftsführer | 1 Orchard Place Nottingham Business Park NG8 6PX Nottingham | England | British | 111270210002 | |||||
| ASH, Nicholas Watson, Dr | Geschäftsführer | Orchard Place, Nottingham Business Park NG8 6PX Nottingham 1 | England | British | 156704060001 | |||||
| BAKEWELL, Robert | Geschäftsführer | Orchard Place, Nottingham Business Park NG8 6PX Nottingham 1 United Kingdom | England | British | 171644680001 | |||||
| CHISHOLM, Iain Macdonald | Geschäftsführer | 1 Orchard Place Nottingham Business Park NG8 6PX Nottingham | England | British | 231355750001 | |||||
| ELLIS, Ian Ogilvie, Professor | Geschäftsführer | Yew Tree House 2 Kenworth Road The Park NG7 1DD Nottingham Notts | United Kingdom | British | 6812090001 | |||||
| GREEN, Charles Alexander | Geschäftsführer | The Gaires Bradley DN37 0AN Grimsby North Lincolnshire | British | 75952680004 | ||||||
| JOHNSTON, Neil Gerard, Dr | Geschäftsführer | 14 Long Furlong Over CB4 5PG Cambridge | United Kingdom | British | 321751730001 | |||||
| KIRKHAM, David Michael | Geschäftsführer | 1 Orchard Place Nottingham Business Park NG8 6PX Nottingham | England | British | 284259930001 | |||||
| LEAVES, Nicholas Ivor, Dr | Geschäftsführer | Orchard Place, Nottingham Business Park NG8 6PX Nottingham 1 United Kingdom | England | British | 102979420004 | |||||
| LONGSTAFFE, Andrew David | Geschäftsführer | 320 Drub Lane Gomersal BD19 4BX Bradford West Yorkshie | England | British | 197462400001 | |||||
| METCALFE, Timothy Charles | Geschäftsführer | Orchard Place Nottingham Business Park NG8 6PX Nottingham 1 England | England | British | 190681700001 | |||||
| MINSHALL, Mark Richard | Geschäftsführer | 56 Rivergreen Crescent Bramcote NG9 3ET Nottingham | England | British | 75245770002 | |||||
| NOLAN, Trevor Frank | Geschäftsführer | 1 Orchard Place Nottingham Business Park NG8 6PX Nottingham | United Kingdom | British | 270886000001 | |||||
| RATCLIFFE, Anthony James | Geschäftsführer | 1 Orchard Place Nottingham Business Park NG8 6PX Nottingham | England | British | 322203440001 | |||||
| ROBERTS, Gareth Gwyn, Professor Sir | Geschäftsführer | 10 Chadlington Road OX2 6SY Oxford Oxfordshire | British | 75370020002 | ||||||
| TWOSE, Trevor Martin, Doctor | Geschäftsführer | Belchers Cottage Fyfield Wick OX13 5NB Abingdon Oxfordshire | British | 63590560003 | ||||||
| WELLS, Michael, Professor | Geschäftsführer | 57 Ranmoor Crescent S10 3GW Sheffield South Yorkshire | British | 83258520001 | ||||||
| WHEATCROFT, Russell Steven | Geschäftsführer | 1 Orchard Place Nottingham Business Park NG8 6PX Nottingham | England | British | 230279810003 | |||||
| HSE DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London England | 73774730002 | |||||||
| RUTLAND DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Rutland House 148 Edmund Street B3 2JR Birmingham | 900005280001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SOURCE BIOSCIENCE UK LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Source Bioscience Limited | 26. Sept. 2016 | Orchard Place, Nottingham Business Park NG8 6PX Nottingham 1 Orchard Place England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0