NFUM (BRENTWOOD JUBILEE) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | NFUM (BRENTWOOD JUBILEE) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04083708 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NFUM (BRENTWOOD JUBILEE) LIMITED?
- (7011) /
Wo befindet sich NFUM (BRENTWOOD JUBILEE) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | N F U Mutual Tiddington Road CV37 7BJ Stratford Upon Avon Warwickshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von NFUM (BRENTWOOD JUBILEE) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SHP (BRENTWOOD) LIMITED | 29. Sept. 2000 | 29. Sept. 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NFUM (BRENTWOOD JUBILEE) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für NFUM (BRENTWOOD JUBILEE) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Richard Mark Topps am 16. Okt. 2009 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Graham Wood am 13. Okt. 2009 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Sian Elizabeth Cooper am 26. Okt. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | Seiten | 363(353) | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von NFUM (BRENTWOOD JUBILEE) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOPER, Sian Elizabeth | Sekretär | N F U Mutual Tiddington Road CV37 7BJ Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 108867090001 | ||||||
| TOPPS, Richard Mark | Geschäftsführer | N F U Mutual Tiddington Road CV37 7BJ Stratford Upon Avon Warwickshire | United Kingdom | British | 73489460002 | |||||
| WOOD, Graham | Geschäftsführer | N F U Mutual Tiddington Road CV37 7BJ Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 73489380001 | ||||||
| CREECHAN, James Damian | Sekretär | Lifford House Luddington Road CV37 9SE Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 28317510001 | ||||||
| SMITH, Annette Elizabeth | Sekretär | 4 Rowan Close CV37 0DT Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 43252750001 | ||||||
| ABOGADO NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 100 New Bridge Street EC4V 6JA London | 900021150001 | |||||||
| HENDERSON, Rorie Graham Farquharson | Geschäftsführer | Tudor Cottage East Road St Georges Road KT13 0LD Weybridge Surrey | British | 67640130004 | ||||||
| MARTIN, Robert Ainsley | Geschäftsführer | 5 The Dovecote Charlton WR10 3LL Pershore Worcestershire | Uk | British | 16064210001 | |||||
| OLIVER, Christopher Patrick | Geschäftsführer | Hopendene House Holmbury St Mary RH5 6PE Abinger Surrey | United Kingdom | British | 45415600002 | |||||
| ABOGADO CUSTODIANS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 100 New Bridge Street EC4V 6JA London | 900021140001 | |||||||
| ABOGADO NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 100 New Bridge Street EC4V 6JA London | 900021150001 |
Hat NFUM (BRENTWOOD JUBILEE) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Third party legal charge | Erstellt am 04. Feb. 2002 Geliefert am 06. Feb. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from salmon harvester properties limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the charged land being f/h land and property k/a jubilee house chindtis lane warley business park brentwood essex t/n-EX358316. Assigns to the bank all the plant machinery fixtures and fittings now and in the future belonging to the chargor and situate on the charged land and all right title and interest of the chargor under any agreements (present of future),. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third party legal charge | Erstellt am 09. Jan. 2002 Geliefert am 11. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from salmon harvester properties limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The freehold land and property known as jubliee house chindtis lane warley business park brentwood essex title number EX35816 the benefit of all covenants and rights relating to the charged land the benefit of the rental income the proceeds of each policy of insurance now or in the future issued in relation to the charged land and other assets subject to reassignment on redemption and all the plant machinery fixtures and fittings now and in the future belonging to the chargor and situate on the charged land. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 18. Dez. 2000 Geliefert am 22. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and salmon harvester properties limited to the chargee under a facility letter dated 13TH december 2000 and the deed of charge | |
Kurze Angaben F/H property k/a jubilee house chindits lane warley business park brentwood essex t/no.EX358316 together with all present and future buildings structures fixtures. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Dez. 2000 Geliefert am 18. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under a facility letter dated 13 december 2000 | |
Kurze Angaben Jubilee house chindits lane warley business park brentwood essex t/n EX358316. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0