SERENA PROPERTIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSERENA PROPERTIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04085816
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SERENA PROPERTIES LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich SERENA PROPERTIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SERENA PROPERTIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    WELCOME BREAK PROPERTY COMPANY LIMITED06. März 200306. März 2003
    FLOWERFERN LIMITED09. Okt. 200009. Okt. 2000

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SERENA PROPERTIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Mai 2011

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für SERENA PROPERTIES LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für SERENA PROPERTIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung

    18 Seiten2.35B
    A33JBL6I

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. Sept. 2013

    17 Seiten2.24B
    A2JAJ4WR

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18
    A29G1BHS

    Vorschlag des Verwalters

    30 Seiten2.17B
    A2766TU9

    legacy

    3 SeitenMG02
    A25LSE48

    legacy

    3 SeitenMG02
    A25LSE40

    legacy

    3 SeitenMG02
    A25LSE3S

    legacy

    3 SeitenMG02
    A25LSE3K

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    6 Seiten2.16B
    A25QXI5S

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 5Th Floor Leconfield House Curzon Street London W1J 5JA United Kingdom* am 10. Apr. 2013

    2 SeitenAD01
    A25J6K15

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B
    A24R7GLM

    Ernennung von Sara Geraghty als Direktor

    2 SeitenAP01
    X1ITUBH4

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2011

    19 SeitenAA
    A1I7E04J

    Beendigung der Bestellung von Timothy Smalley als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01
    X1H69GWG

    Beendigung der Bestellung von Michael Ingham als Sekretär

    1 SeitenTM02
    X18Y52SP

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital26. Apr. 2012

    Kapitalaufstellung am 26. Apr. 2012

    • Kapital: GBP 2
    SH01
    X17NSALD

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 4Th Floor Leconfield House Curzon Street London W1J 5JA* am 10. Feb. 2012

    1 SeitenAD01
    X12FCE5U

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    X9KEDT2C

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2010

    19 SeitenAA
    L9Y8TS1M

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2009

    20 SeitenAA
    ACEHYL33

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    XCOVRIXY

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    legacy

    1 Seiten123
    P3A1BDI9

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2008

    20 SeitenAA
    AYPDZDE0

    Wer sind die Geschäftsführer von SERENA PROPERTIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GERAGHTY, Sara
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    Geschäftsführer
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    United KingdomBritishBusiness Consultant172596170001
    TCHENGUIZ, Robert
    Royal College Of Organists
    26 Kensington Gore
    SW7 2ET London
    Geschäftsführer
    Royal College Of Organists
    26 Kensington Gore
    SW7 2ET London
    EnglandBritishDirector74322720004
    HARRIS, Ian Michael Brian
    Meadowsteep
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    Sekretär
    Meadowsteep
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    BritishFinance Director116885790001
    INGHAM, Michael Harry Peter
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    Sekretär
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    BritishChartered Accountant2739650001
    WRIGHT, Nicholas David
    112 Bramfield Road
    SG3 6SA Bulls Green
    Hertfordshire
    Sekretär
    112 Bramfield Road
    SG3 6SA Bulls Green
    Hertfordshire
    BritishFinance Director92442510001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CHARTERS, Robert George Beattie
    The Coach House
    Manor Lane
    LE15 7EG Barleythorpe
    Rutland
    Geschäftsführer
    The Coach House
    Manor Lane
    LE15 7EG Barleythorpe
    Rutland
    United KingdomBritishCeo86741360001
    HARRIS, Ian Michael Brian
    Meadowsteep
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Meadowsteep
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Director116885790001
    HARRIS, Michael Roderick
    Sandgate
    Marley Way, Storrington
    RH20 3NH Pulborough
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Sandgate
    Marley Way, Storrington
    RH20 3NH Pulborough
    West Sussex
    EnglandBritishChartered Surveyor4768360001
    MCKAY, Ian, Dr
    Lower End
    Salford
    OX7 5YP Chipping Norton
    Lower End Cottage
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Lower End
    Salford
    OX7 5YP Chipping Norton
    Lower End Cottage
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishProperty Director138381520001
    MCKIE, Roderick Wallace
    Lindon House
    1 Wilton Road
    HP9 2BS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Lindon House
    1 Wilton Road
    HP9 2BS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishOperations Director80931680001
    PENNYCOOK, Richard
    Sherington Place
    Church End
    MK16 9PA Sherington
    Bucks
    Geschäftsführer
    Sherington Place
    Church End
    MK16 9PA Sherington
    Bucks
    BritishCeo112734470001
    SIMPSON, Nicholas John
    16 King Edwards Road
    HA4 7AJ Ruislip
    Middlesex
    Geschäftsführer
    16 King Edwards Road
    HA4 7AJ Ruislip
    Middlesex
    BritishSolicitor98200760001
    SMALLEY, Timothy John
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    Geschäftsführer
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director102593650002
    TAYLOR, Paul Vincent
    Destiny
    49 The Highway
    SM2 5QS South Sutton
    Surrey
    Geschäftsführer
    Destiny
    49 The Highway
    SM2 5QS South Sutton
    Surrey
    United KingdomBritishChief Executive71978710001
    WRIGHT, Nicholas David
    112 Bramfield Road
    SG3 6SA Bulls Green
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    112 Bramfield Road
    SG3 6SA Bulls Green
    Hertfordshire
    BritishFinance Director92442510001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat SERENA PROPERTIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Assignation of rents
    Erstellt am 17. Juni 2004
    Geliefert am 23. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The rental income arising from the letting use or occupation of all or any part of the property being all and whole those subjects known generally as the M74 motorway service area abington t/no LAN79685. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland (The Lender)
    Transaktionen
    • 23. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Apr. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Assignation of rents
    Erstellt am 17. Juni 2004
    Geliefert am 23. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any senior/mezzanine finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The rental income arising from the letting use or occupation of all or any part of the property being all and whole those subjects known generally as the M74 motorway service area abington t/no LAN79685. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland for Itself and as Agent and Trustee for Each of the Senior/Mezzaninefinance Parties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Apr. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Assignation in security
    Erstellt am 17. Juni 2004
    Geliefert am 23. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any senior/mezzanine finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The agreement being the minute of agreement between the secretary of state for scotland and forte (UK) limited dated 1 may and 2 june 1995. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland for Itself and as Agent and Trustee for Each of the Senior/Mezzaninefinance Parties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Apr. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 29 june 2004 and
    Erstellt am 08. Juni 2004
    Geliefert am 08. Juli 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Those subjects known as the M74 motorway service area abington t/no LAN79685 together with 1) the parts privileges and pertinents 2) the whole right title and interest in and to the subjects and 3) the heritable fittings and fixtures therein and thereon.
    Berechtigte Personen
    • Frostlake Limited
    Transaktionen
    • 08. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 24 june 2004 and
    Erstellt am 08. Juni 2004
    Geliefert am 02. Juli 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    M74 motorway service area abington t/no LAN79865 together with the parts privileges and pertinents thereof the whole right title and interest of the company in and to the said subjects and the heritable fixtures and fittings therein and thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 02. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 24 june 2004 and
    Erstellt am 08. Juni 2004
    Geliefert am 02. Juli 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any senior/mezzanine finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    M74 motorway service area abington t/no LAN79865 together with the parts privileges and pertinents thereof the whole right title and interest of the company in and to the said subjects and the heritable fixtures and fittings therein and thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 02. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 08. Juni 2004
    Geliefert am 26. Juni 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H and l/h property k/a charnock richard motorway service area t/no LA68119 (f/h) and LA790729 (l/h); f/h property k/a fleet motorway service area, M3 t/no HP508258; f/h property k/a sedgemoor motorway service area, M5 t/no ST122381. For details of further properties charged please refer to form 395.all present and future shares in any member of the group. Benefit of all its right, title and interest to, in and under agreements, licences, rental income and insurance policies. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Frostlake Limited
    Transaktionen
    • 26. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Assignation of rents
    Erstellt am 08. Juni 2004
    Geliefert am 26. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The rental income from the subjects being all sums paid or payable to or for the benefit of the company arising from the letting use or occupation of all or any part of the property known generally as the M74 motorway service area abington t/no LAN79685.
    Berechtigte Personen
    • Frostlake Limited
    Transaktionen
    • 26. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Apr. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 08. Juni 2004
    Geliefert am 17. Juni 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The property being charnock richard M6 all that freehold and leasehold property known as charnock richard t/no LA768119 (freehold) and t/no LA790729 (leasehold) fleet M3 - all that freehold property known as fleet motorway service area M3 t/no HP508258, sedgemoor M5 - all that freehold property known as sedgemoor motorway service area M5 t/no ST122381 for further details of the properties charged please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 17. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 08. Juni 2004
    Geliefert am 17. Juni 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any senior/mezzanine finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 17. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Assignation of rent dated 27 march 2003 and
    Erstellt am 09. Apr. 2003
    Geliefert am 24. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Right title and interest in and to the rent and all other monies. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Trustee Company Limited
    Transaktionen
    • 24. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 15TH april 2003 and
    Erstellt am 27. März 2003
    Geliefert am 25. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole 8.1 hectares on the west side of the M74 at abington t/no LAN79685.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Trustee Company Limited (Formerly Known as Bankers Trustee Company Limited) as Agentand Trustee for the Wb Group Secured Parties (the Security Trustee)
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fourth supplemental deed of charge
    Erstellt am 27. März 2003
    Geliefert am 09. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities whatsoever due or to become due from wbgl,the other borrowers,the parent,wb ownership,the parent,wb ownership,wb holdings 1,wb holdings 2 and the company or any other guarantor to the chargee or any of the other wb group secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right,title,interest and benefit in and to the reorganisation properties and all other rights,estates or interest in any freehold or leasehold property hereafter; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Trustee Company Limited (Formerly Known as Bankers Trustee Company Limited)
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security
    Erstellt am 20. März 2003
    Erworben am 27. März 2003
    Geliefert am 15. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects comprising 8.21 hectares on the west side of 374 at abington t/n lan 79685.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Trustee Company Limited , as Agent and Trustees for the Wb Group Secured Parties
    Transaktionen
    • 15. Apr. 2003Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 22. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A third supplemental deed of charge (wb group)
    Erstellt am 20. März 2003
    Erworben am 27. März 2003
    Geliefert am 09. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities whatsoever due or to become due from wbgl,any other borrower,the parent,wb ownership,wb holdings 1,wb holdings 2 and the company or any guarantor to the chargee or any of the other wb group secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right,title,and interest in,and to charnock richard motorway service area t/n LA768119, fleet motorway service area t/n HP508258, hartshead moor motorway service area t/n WYK577957 (for further details of property charged please refer to the form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Trustee Company Limited (Formerly Known as Bankers Trustee Company Limited)
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2003Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 22. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third supplemental deed of charge
    Erstellt am 20. März 2003
    Geliefert am 04. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities whatsoever due or to become due from wbgl,any other borrower,the parent,wb ownership,wb holdings 1,wb holdings 2 and the company or any guarantor to the chargee or any of the other wb group secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right,title,and interest in,to and under the relevant documents,as defined. See form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Trustee Company Limited (Formerly Known as Bankers Trustee Company Limited)
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A first supplemental deed of charge (wb group)
    Erstellt am 26. Okt. 1998
    Erworben am 27. März 2003
    Geliefert am 09. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower, the parent, or any guarantor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to hopwood motorway service area on the M42 motorway t/n HW55645. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Trustee Company Limited (Formerly Known as Bankers Trustee Company Limited) Thesecurity Trustee (as Defined Therein)
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2003Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 22. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security
    Erstellt am 12. Aug. 1997
    Erworben am 27. März 2003
    Geliefert am 11. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Abingdon mortorway services area lying to the west of the A73 public road lanark t/n LAN79685.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Trustee Company Limited
    Transaktionen
    • 11. Apr. 2003Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 22. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A deed of charge (wb group)
    Erstellt am 12. Aug. 1997
    Erworben am 27. März 2003
    Geliefert am 09. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower, the parent, or any guarantor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The property k/a oxford motorway service area t/n ON195336 and abington motorway service area t/n LAN79685. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Trustee Company Limited (Formerly Known as Bankers Trustee Company Limited) as Thesecurity Trustee (as Defined Therein)
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2003Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 22. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat SERENA PROPERTIES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    10. März 2014Ende der Verwaltung
    20. März 2013Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Robert Jonathan Hunt
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Mark Charles Batten
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0