PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04086676 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 2nd Floor One Gosforth Park Way Gosforth Business Park NE12 8ET Newcastle Upon Tyne |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CROSSCO (512) LIMITED | 09. Okt. 2000 | 09. Okt. 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 9 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Anthony Waterworth als Geschäftsführer am 31. März 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael John Wilmot als Geschäftsführer am 19. Juli 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 7 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 4 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Alan Bull als Geschäftsführer am 29. Juni 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 21. Dez. 2017
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 20. Dez. 2017
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 3 Bunhill Row London EC1Y 8YZ England zum C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp St Ann's Wharf 112 Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DX geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 3 Bunhill Row London EC1Y 8YZ verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Okt. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 44 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Okt. 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Ian Alan Bull als Direktor am 13. Juni 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf 3 Bunhill Row London EC1Y 8YZ geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Jan. 2016 bis 31. Dez. 2015 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 44 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHIBOLD, Judith Ann | Sekretär | 2nd Floor One Gosforth Park Way Gosforth Business Park NE12 8ET Newcastle Upon Tyne | British | 85878920001 | ||||||
| NORDEN, Michael Robert | Sekretär | 85 Neale Street SR6 9EY Sunderland Tyne & Wear | British | 121560410001 | ||||||
| DICKINSON DEES | Bevollmächtigter Sekretär | St Anns Wharf 112 Quayside NE99 1SB Newcastle Upon Tyne | 900005460001 | |||||||
| BAMSEY, Darrin | Geschäftsführer | 2nd Floor One Gosforth Park Way Gosforth Business Park NE12 8ET Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | 123369200006 | |||||
| BULL, Ian Alan | Geschäftsführer | One Gosforth Park Way Gosforth Business Park NE12 8ET Newcastle Upon Tyne 2nd Floor England | England | British | 210299090001 | |||||
| CARE, Timothy James | Bevollmächtigter Geschäftsführer | West House Whorlton Hall Farm Westerhope NE5 1NP Newcastle Upon Tyne | British | 900005450001 | ||||||
| MCDONNELL, Bernard Neillus | Geschäftsführer | 16 Malone Valley Park BT9 5PZ Belfast County Antrim | Northern Ireland | Irish | 123369120001 | |||||
| NORDEN, Michael Robert | Geschäftsführer | 85 Neale Street SR6 9EY Sunderland Tyne & Wear | England | British | 121560410001 | |||||
| WATERWORTH, John Anthony | Geschäftsführer | 2nd Floor One Gosforth Park Way Gosforth Business Park NE12 8ET Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | 203710900001 | |||||
| WILMOT, Michael John | Geschäftsführer | 2nd Floor One Gosforth Park Way Gosforth Business Park NE12 8ET Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | 91108150004 | |||||
| WILSON, Robert Graham | Geschäftsführer | 8 Oaklands Darras Hall Ponteland NE20 9PH Newcastle Upon Tyne Tyne And Wear | United Kingdom | British | 6564660002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkdean Holiday Parks Limited | 06. Apr. 2016 | One Gosforth Park Way Gosforth Business Park NE12 8ET Newcastle Upon Tyne 2nd Floor England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 28. März 2014 Geliefert am 04. Apr. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Intellectual property including tm 2392814, tm 2603583, tm 2604489 & tm 2604490 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Mai 2006 Geliefert am 10. Mai 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and all the other companies named in the debenture to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Crantock beach holiday park crantock beach newquay cornwall t/n CL72935,CL64619,CL58334 holywell bay holiday park holywell bay newquay cornwall t/n CL163998 and CL146183 st minver holiday park nr rock wadebridge cornwall t/n CL167364 for details of further properties charged please refer to form 395 equitable mortgage the investments in each and all of the occupational leases any hedging agreement all fixtures and fittings the accounts all monies uncalled capital floating charge all the assets property and undertaking. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture and guarantee | Erstellt am 15. März 2002 Geliefert am 28. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from parkdean holidays limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. März 2002 Geliefert am 21. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from teach obligor to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 15. März 2001 Geliefert am 02. Apr. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies, obligations and liabilities due owing or incurred by the company formerly known as crossco (512) limited to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined) and the debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplement deed to a composite guarantee and debenture dated 13TH november 1999 | Erstellt am 15. März 2001 Geliefert am 19. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and discharge all obligations and liabilities now or hereafter due, owing or incurred by the company to the secured parties or any of them and/or the chargee under or pursuant to any finance documents (all terms as defined) and all monies and discharge all obligations and liabilities due from each other company (as defined) and any other present and future subsidiary of the parent or of any company (except any obligations or liabilities of such other company as guarantor for the company concerned but including any such obligations under any negative pledge (as defined)). | |
Kurze Angaben Property being challaborough bay holiday park, title number DN175053 and DN218021, st minver holiday park, west bay holiday park os number 0065 and 0994 and paart 0086 for further details of property charged please refer to form 395. all buildings, fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery. All stocks, shares, securities and other interests both present and future. All of its present and future book debts and other debts. Floating charge as a undertaking and all its property, assets and rights.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0