PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED

PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04086676
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CROSSCO (512) LIMITED09. Okt. 200009. Okt. 2000

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    9 SeitenLIQ13

    Beendigung der Bestellung von John Anthony Waterworth als Geschäftsführer am 31. März 2019

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Michael John Wilmot als Geschäftsführer am 19. Juli 2018

    1 SeitenTM01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    7 SeitenLIQ01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 26. Juni 2018

    LRESSP

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    4 Seiten600

    Beendigung der Bestellung von Ian Alan Bull als Geschäftsführer am 29. Juni 2018

    1 SeitenTM01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    resolution

    Beschluss zur Kapitalisierung oder Ausgabe von Gratisaktien

    That authority is hereby granted for the directors to capitalise and appropriate as capital the sum of £800,000 being the total amount of the company's reserves and to apply such sum in paying up in full 800,000 ordinary shares of £1.00 each in the capital of the company 20/12/2017
    RES14
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10

    Kapitalaufstellung am 21. Dez. 2017

    • Kapital: GBP 1.00
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 20. Dez. 2017

    • Kapital: GBP 8,300,100
    4 SeitenSH01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 3 Bunhill Row London EC1Y 8YZ England zum C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp St Ann's Wharf 112 Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DX geändert

    1 SeitenAD02

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 3 Bunhill Row London EC1Y 8YZ verlegt

    1 SeitenAD03

    Bestätigungserklärung erstellt am 09. Okt. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    6 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    44 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Bestätigungserklärung erstellt am 09. Okt. 2016 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Ian Alan Bull als Direktor am 13. Juni 2016

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    6 SeitenAA

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf 3 Bunhill Row London EC1Y 8YZ geändert

    1 SeitenAD02

    Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Jan. 2016 bis 31. Dez. 2015

    1 SeitenAA01

    Beschlüsse

    Resolutions
    44 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01
    capital

    Beschlüsse

    Facilities agreement 10/11/2015
    RES13

    Wer sind die Geschäftsführer von PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ARCHIBOLD, Judith Ann
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Sekretär
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    British85878920001
    NORDEN, Michael Robert
    85 Neale Street
    SR6 9EY Sunderland
    Tyne & Wear
    Sekretär
    85 Neale Street
    SR6 9EY Sunderland
    Tyne & Wear
    British121560410001
    DICKINSON DEES
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    Bevollmächtigter Sekretär
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    900005460001
    BAMSEY, Darrin
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish123369200006
    BULL, Ian Alan
    One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    2nd Floor
    England
    Geschäftsführer
    One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    2nd Floor
    England
    EnglandBritish210299090001
    CARE, Timothy James
    West House Whorlton Hall Farm
    Westerhope
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    West House Whorlton Hall Farm
    Westerhope
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    British900005450001
    MCDONNELL, Bernard Neillus
    16 Malone Valley Park
    BT9 5PZ Belfast
    County Antrim
    Geschäftsführer
    16 Malone Valley Park
    BT9 5PZ Belfast
    County Antrim
    Northern IrelandIrish123369120001
    NORDEN, Michael Robert
    85 Neale Street
    SR6 9EY Sunderland
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    85 Neale Street
    SR6 9EY Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish121560410001
    WATERWORTH, John Anthony
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish203710900001
    WILMOT, Michael John
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish91108150004
    WILSON, Robert Graham
    8 Oaklands Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9PH Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Geschäftsführer
    8 Oaklands Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9PH Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    United KingdomBritish6564660002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    2nd Floor
    England
    06. Apr. 2016
    One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    2nd Floor
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageEnglish Law
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer04086679
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 28. März 2014
    Geliefert am 04. Apr. 2014
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Intellectual property including tm 2392814, tm 2603583, tm 2604489 & tm 2604490 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Ares Management Limited (In Its Capacity as Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 13. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 03. Mai 2006
    Geliefert am 10. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and all the other companies named in the debenture to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Crantock beach holiday park crantock beach newquay cornwall t/n CL72935,CL64619,CL58334 holywell bay holiday park holywell bay newquay cornwall t/n CL163998 and CL146183 st minver holiday park nr rock wadebridge cornwall t/n CL167364 for details of further properties charged please refer to form 395 equitable mortgage the investments in each and all of the occupational leases any hedging agreement all fixtures and fittings the accounts all monies uncalled capital floating charge all the assets property and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 10. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite debenture and guarantee
    Erstellt am 15. März 2002
    Geliefert am 28. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from parkdean holidays limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Paul Anthony Yates and Jill Susan Yates
    Transaktionen
    • 28. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 15. März 2002
    Geliefert am 21. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from teach obligor to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • N M Rothschild & Sons Limited (As Agent and Trustee for Itself and Each Ofthe Other Finance Parties (the Security Trustee))
    Transaktionen
    • 21. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 15. März 2001
    Geliefert am 02. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies, obligations and liabilities due owing or incurred by the company formerly known as crossco (512) limited to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined) and the debenture
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Haven Leisure Limited
    Transaktionen
    • 02. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. März 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplement deed to a composite guarantee and debenture dated 13TH november 1999
    Erstellt am 15. März 2001
    Geliefert am 19. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and discharge all obligations and liabilities now or hereafter due, owing or incurred by the company to the secured parties or any of them and/or the chargee under or pursuant to any finance documents (all terms as defined) and all monies and discharge all obligations and liabilities due from each other company (as defined) and any other present and future subsidiary of the parent or of any company (except any obligations or liabilities of such other company as guarantor for the company concerned but including any such obligations under any negative pledge (as defined)).
    Kurze Angaben
    Property being challaborough bay holiday park, title number DN175053 and DN218021, st minver holiday park, west bay holiday park os number 0065 and 0994 and paart 0086 for further details of property charged please refer to form 395. all buildings, fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery. All stocks, shares, securities and other interests both present and future. All of its present and future book debts and other debts. Floating charge as a undertaking and all its property, assets and rights.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • N M Rothschilds & Sons Limited as Agent and Trustee for the Secured Parties(The "Security Agent")
    Transaktionen
    • 19. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat PARKDEAN HOLIDAYS (SOUTH WEST) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    26. Juni 2018Beginn der Liquidation
    30. Aug. 2019Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praktiker
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Toby Scott Underwood
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0