ELEPHANT WEST LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ELEPHANT WEST LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04089358 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ELEPHANT WEST LIMITED?
- Sonstige Herstellung n.e.c. (32990) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich ELEPHANT WEST LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Studio Building 21 Evesham Street W11 4AJ London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ELEPHANT WEST LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| LETRASET LIMITED | 19. Juni 2001 | 19. Juni 2001 |
| CREATIVE OPPORTUNITIES LIMITED | 31. Jan. 2001 | 31. Jan. 2001 |
| LETRASET LIMITED | 09. Okt. 2000 | 09. Okt. 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ELEPHANT WEST LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ELEPHANT WEST LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Apr. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Geänderte vollständige Konten erstellt bis 31. Dez. 2017 | 19 Seiten | AAMD | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Okt. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Adrianus Van Schie als Direktor am 06. Feb. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Barratt als Geschäftsführer am 16. Aug. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Jonathan Paul William Spight als Direktor am 06. Feb. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 23. Jan. 2018
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Okt. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 11 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Okt. 2016 mit Aktualisierungen | 9 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 15 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Thomas Carl Hanz Brautigam als Geschäftsführer am 02. Okt. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Thomas Carl Hanz Brautigam als Geschäftsführer am 02. Okt. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Michael Adams als Geschäftsführer am 31. Okt. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Michael Adams als Geschäftsführer am 31. Okt. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 16 Seiten | AA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ELEPHANT WEST LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIGHT, Jonathan Paul William | Geschäftsführer | 21 Evesham Street W11 4AJ London Studio Building | England | British | 216794410001 | |||||
| VAN SCHIE, Adrianus Hendrikus Maria | Geschäftsführer | 21 Evesham Street W11 4AJ London Studio Building | England | Dutch | 202024180002 | |||||
| BALDOCK, Simon Paul | Sekretär | Kingsnorth Industrial Estate Wotton Road TN23 6FL Ashford Kent | British | 117307130001 | ||||||
| GOTHARD, Nigel | Sekretär | 3 Chaucer Mews CT2 9BF Upper Harbledown Kent | British | 77437250001 | ||||||
| PEPALL, Lewis John | Sekretär | Goldthorn Road DY11 7JN Kidderminster Colart England | 175170150001 | |||||||
| BRACHERS LIMITED | Sekretär | Somerfield House, 59 London Road ME16 8JH Maidstone Kent | 80957680001 | |||||||
| ADAMS, Stephen Michael | Geschäftsführer | 21 Evesham Street W11 4AJ London Studio Building United Kingdom | England | British | 175188190001 | |||||
| BALDOCK, Simon Paul | Geschäftsführer | Kingsnorth Industrial Estate Wotton Road TN23 6FL Ashford Kent | England | British | 117307130001 | |||||
| BARRATT, Mark | Geschäftsführer | 21 Evesham Street W11 4AJ London Studio Building | England | British | 201080080001 | |||||
| BOWEN, Anthony David | Geschäftsführer | Kingsnorth Industrial Estate Wotton Road TN23 6FL Ashford Kent | United Kingdom | British | 150068230001 | |||||
| BRANDON, John Robert | Geschäftsführer | 28 Marsh Lane Mill Hill NW7 4QP London | United Kingdom | British | 99584240001 | |||||
| BRAUTIGAM, Thomas Carl Hanz | Geschäftsführer | 21 Evesham Street W11 4AJ London Studio Building United Kingdom | United Kingdom | Swedish | 134706290001 | |||||
| GIBBS, Roy Martin | Geschäftsführer | Kingsnorth Industrial Estate Wotton Road TN23 6FL Ashford Kent | England | British | 37073140002 | |||||
| GOTHARD, Nigel | Geschäftsführer | 3 Chaucer Mews CT2 9BF Upper Harbledown Kent | England | British | 77437250001 | |||||
| GREGORY, Jonathan David Leigh | Geschäftsführer | Millbeck 31 The Hordens Barns Green RH13 7PH Horsham West Sussex | England | British | 44708850001 | |||||
| HOAREAU, Guillaume | Geschäftsführer | Kingsnorth Industrial Estate Wotton Road TN23 6FL Ashford Kent | England | French | 137444890001 | |||||
| HODGES, Simon Christopher | Geschäftsführer | Kingsnorth Industrial Estate Wotton Road TN23 6FL Ashford Kent | England | British | 149484790001 | |||||
| JOHNSTON, Mark Frederick | Geschäftsführer | Kingsnorth Industrial Estate Wotton Road TN23 6FL Ashford Kent | England | British | 86246750001 | |||||
| PEPALL, Lewis John | Geschäftsführer | Goldthorn Road DY11 7JN Kidderminster Colart England | United Kingdom | British | 161095610001 | |||||
| ROPER, Gordon Edward Lawrence | Geschäftsführer | 21 Evesham Street W11 4AJ London Studio Building United Kingdom | Great Britain | British | 120319980002 | |||||
| TRAVERS, Michael Brian | Geschäftsführer | La-Vista 19 Temeraire Heights CT20 3TL Folkestone Kent | United Kingdom | British | 72345270002 | |||||
| WRAIGHT, Justin | Geschäftsführer | 21 Evesham Street W11 4AJ London Studio Building United Kingdom | United Kingdom | British | 169908430001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ELEPHANT WEST LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colart International Holdings Ltd | 09. Okt. 2016 | Evesham Street W11 4AJ London 21 England | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
Hat ELEPHANT WEST LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 09. März 2009 Geliefert am 12. März 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 21. Juli 2006 Geliefert am 01. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Porex LS1030 PWZ2 new production tool, porex LS1030 PWZ3 new production tool and dg mortimer & co LTD barrel tool new main cartridge barrel tools for details of further equipment charged please refer to form 395. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 14. Nov. 2005 Geliefert am 19. Nov. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Okt. 2005 Geliefert am 15. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 06. Jan. 2004 Geliefert am 08. Jan. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of assurance policies | Erstellt am 19. Juni 2001 Geliefert am 27. Juni 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formerly known as creative opportunities limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben With full title guarantee assigns to the bank all the policy or policies of assurance described in the the schedule to the mortgage being the policy over the life of roy martin gibbs (policy number 0091202366) assuring the sum of £250,000 exclusive of bonus and the policy over the life of michael brian travers (policy number 0091201889) assuring the sum of £250,000 exclusive of bonus. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Juni 2001 Geliefert am 27. Juni 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formerly known as creative opportunities limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0