BIKERS LEGAL DEFENCE LIMITED

BIKERS LEGAL DEFENCE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBIKERS LEGAL DEFENCE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04089471
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BIKERS LEGAL DEFENCE LIMITED?

    • Vermietung und Leasing von anderen Maschinen, Geräten und Sachanlagen n.a. (77390) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich BIKERS LEGAL DEFENCE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Bdo Llp Thames Tower 12th Floor
    Station Road
    RG1 1LX Reading
    Berkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BIKERS LEGAL DEFENCE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Okt. 2013

    Welche sind die letzten Einreichungen für BIKERS LEGAL DEFENCE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Kings Wharf 20-30 Kings Road Reading Berkshire RG1 3EX zum Bdo Llp Thames Tower 12th Floor Station Road Reading Berkshire RG1 1LX am 12. Okt. 2017

    2 SeitenAD01

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung

    11 SeitenAM23

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 08. März 2017

    24 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 08. Sept. 2016

    25 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    13 Seiten2.16B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 08. März 2016

    25 Seiten2.24B

    Beendigung der Bestellung von Jason Neville Timothy Richards als Geschäftsführer am 26. Nov. 2015

    1 SeitenTM01

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    52 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    50 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Unit 3a Carvers Industrial Estate Southampton Road Ringwood BH24 1JR zum Kings Wharf 20-30 Kings Road Reading Berkshire RG1 3EX am 21. Sept. 2015

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 teilweise

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 040894710010 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    1 SeitenMR04

    Ernennung von Mr Henry Lafferty als Direktor am 26. März 2015

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Chuck Ives als Geschäftsführer am 31. Dez. 2014

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von David Morgan Hancox als Geschäftsführer am 05. Dez. 2014

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von David Morgan Hancox als Sekretär am 05. Dez. 2014

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Paul Gregory Hunt als Geschäftsführer am 19. Sept. 2014

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital14. Okt. 2014

    Kapitalaufstellung am 14. Okt. 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von BIKERS LEGAL DEFENCE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LAFFERTY, Henry
    High Street
    Sharnbrook
    MK44 1PG Bedford
    Windmill House
    England
    Geschäftsführer
    High Street
    Sharnbrook
    MK44 1PG Bedford
    Windmill House
    England
    EnglandBritishAccountant146249130001
    HANCOX, David Morgan
    Unit 3a Carvers Industrial
    Estate Southampton Road
    BH24 1JR Ringwood
    Sekretär
    Unit 3a Carvers Industrial
    Estate Southampton Road
    BH24 1JR Ringwood
    175034170001
    HORTON, Dominique Shay
    Unit 3a Carvers Industrial
    Estate Southampton Road
    BH24 1JR Ringwood
    Sekretär
    Unit 3a Carvers Industrial
    Estate Southampton Road
    BH24 1JR Ringwood
    147723230001
    MENZIES WILSON, Charles Napier
    Newport House Newport Lane
    Braishfield
    SO51 0PL Romsey
    Hampshire
    Sekretär
    Newport House Newport Lane
    Braishfield
    SO51 0PL Romsey
    Hampshire
    BritishCompany Director46123720001
    OLIVER, John Philip
    14 Minterne Road
    BH23 3LD Christchurch
    Dorset
    Sekretär
    14 Minterne Road
    BH23 3LD Christchurch
    Dorset
    British89919570001
    PARRY, Bradley John
    3 Erica Court
    Corfe Mullen
    BH21 3TQ Wimborne
    Dorset
    Sekretär
    3 Erica Court
    Corfe Mullen
    BH21 3TQ Wimborne
    Dorset
    BritishCompany Director73039540003
    RUSSELL DE CLIFFORD, Michael
    Minterne Lower Street
    Donhead St Andrew
    SP7 9EE Shaftesbury
    Dorset
    Sekretär
    Minterne Lower Street
    Donhead St Andrew
    SP7 9EE Shaftesbury
    Dorset
    British122757650001
    TUCK, Christine
    Unit 3a Carvers Industrial
    Estate Southampton Road
    BH24 1JR Ringwood
    Sekretär
    Unit 3a Carvers Industrial
    Estate Southampton Road
    BH24 1JR Ringwood
    BritishPa134760400001
    WAY, Sarah
    Unit 3a Carvers Industrial
    Estate Southampton Road
    BH24 1JR Ringwood
    Sekretär
    Unit 3a Carvers Industrial
    Estate Southampton Road
    BH24 1JR Ringwood
    173603280001
    MORGAN WEBSTER LAWRIE (SECRETARIES) LTD
    23 Keytes Lane
    Barford
    CV35 8EP Warwick
    Warwickshire
    Sekretär
    23 Keytes Lane
    Barford
    CV35 8EP Warwick
    Warwickshire
    71936870001
    BURNS, John
    Linhay Farm Hartley Lane
    SO43 7JN Bramshaw
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Linhay Farm Hartley Lane
    SO43 7JN Bramshaw
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector73039410001
    FEARON, Andrew Jason
    Unit 3a Carvers Industrial
    Estate Southampton Road
    BH24 1JR Ringwood
    Geschäftsführer
    Unit 3a Carvers Industrial
    Estate Southampton Road
    BH24 1JR Ringwood
    United KingdomBritishCompany Director69281370002
    GLYDON, Patrick Richard
    8 Mount Pleasant Road
    CB11 3EA Saffron Walden
    Essex
    Geschäftsführer
    8 Mount Pleasant Road
    CB11 3EA Saffron Walden
    Essex
    EnglandBritishCompany Director110646220001
    HANCOX, David Morgan
    Unit 3a Carvers Industrial
    Estate Southampton Road
    BH24 1JR Ringwood
    Geschäftsführer
    Unit 3a Carvers Industrial
    Estate Southampton Road
    BH24 1JR Ringwood
    EnglandBritishChartered Accountant127734940002
    HORTON, Dominique Shay
    Unit 3a Carvers Industrial
    Estate Southampton Road
    BH24 1JR Ringwood
    Geschäftsführer
    Unit 3a Carvers Industrial
    Estate Southampton Road
    BH24 1JR Ringwood
    EnglandBritishFinance Director91199550001
    HUNT, Paul Gregory
    Unit 3a Carvers Industrial
    Estate Southampton Road
    BH24 1JR Ringwood
    Geschäftsführer
    Unit 3a Carvers Industrial
    Estate Southampton Road
    BH24 1JR Ringwood
    United KingdomBritishDirector152176830001
    IVES, Chuck
    Unit 3a Carvers Industrial
    Estate Southampton Road
    BH24 1JR Ringwood
    Geschäftsführer
    Unit 3a Carvers Industrial
    Estate Southampton Road
    BH24 1JR Ringwood
    United KingdomBritishDirector166630560001
    MENZIES WILSON, Charles Napier
    Newport House Newport Lane
    Braishfield
    SO51 0PL Romsey
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Newport House Newport Lane
    Braishfield
    SO51 0PL Romsey
    Hampshire
    United KingdomBritishFinance Director46123720001
    PARRY, Bradley John
    Taylor Drive
    Throop
    BH8 0PZ Bournemouth
    16
    Geschäftsführer
    Taylor Drive
    Throop
    BH8 0PZ Bournemouth
    16
    UkSouth AfricanCompany Director73039540006
    POTTS, Graeme John
    Unit 3a Carvers Industrial
    Estate Southampton Road
    BH24 1JR Ringwood
    Geschäftsführer
    Unit 3a Carvers Industrial
    Estate Southampton Road
    BH24 1JR Ringwood
    EnglandBritishCompany Director89665780001
    RICHARDS, Jason Neville Timothy
    Unit 3a Carvers Industrial
    Estate Southampton Road
    BH24 1JR Ringwood
    Geschäftsführer
    Unit 3a Carvers Industrial
    Estate Southampton Road
    BH24 1JR Ringwood
    United KingdomBritishChartered Accountant278190190001
    STEIN, Rolf
    Unit 3a Carvers Industrial
    Estate Southampton Road
    BH24 1JR Ringwood
    Geschäftsführer
    Unit 3a Carvers Industrial
    Estate Southampton Road
    BH24 1JR Ringwood
    United KingdomGermanDirector152176590001
    STRAFFON, Martin
    The Street
    BS40 8UU Chew Stoke
    The Old Post Office
    Somerset
    Geschäftsführer
    The Street
    BS40 8UU Chew Stoke
    The Old Post Office
    Somerset
    EnglandBritishSales And Marketing Director128180140001
    MWL DIRECTORS LTD
    23 Keytes Lane
    Barford
    CV35 8EP Warwick
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    23 Keytes Lane
    Barford
    CV35 8EP Warwick
    Warwickshire
    69381770001

    Hat BIKERS LEGAL DEFENCE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 29. Juli 2013
    Geliefert am 30. Juli 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • State Securities PLC
    Transaktionen
    • 30. Juli 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 26. Juni 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    All assets debenture
    Erstellt am 31. Juli 2012
    Geliefert am 17. Aug. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 17. Aug. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 31. Juli 2012
    Geliefert am 03. Aug. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the charging company to the security beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Paul Hunt and Parviz Moayedi
    Transaktionen
    • 03. Aug. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 08. Feb. 2007
    Geliefert am 20. Feb. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Golden Pond Corporation Nv and Bradley John Parry (The "Creditors")
    Transaktionen
    • 20. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juni 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 08. Feb. 2007
    Geliefert am 13. Feb. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juni 2015Teilweise Erfüllung einer Belastung (MR04)
    • 26. Juni 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 01. Dez. 2004
    Geliefert am 03. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juni 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage of intellectual property (including software)
    Erstellt am 25. Nov. 2004
    Geliefert am 03. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All right title and interest in the intellectual property rights, third party rights,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juni 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 05. Juni 2003
    Geliefert am 06. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hampshire Trust Factors Limited
    Transaktionen
    • 06. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 13. Nov. 2000
    Geliefert am 17. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bradley John Parry
    Transaktionen
    • 17. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 13. Nov. 2000
    Geliefert am 17. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • John Burns
    Transaktionen
    • 17. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat BIKERS LEGAL DEFENCE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    09. Sept. 2015Beginn der Verwaltung
    04. Sept. 2017Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Simon Edward Jex Girling
    20-30 Kings Road
    RG1 3EX Reading
    Praktiker
    20-30 Kings Road
    RG1 3EX Reading
    Danny Dartnaill
    Kings Wharf 20-30 Kings Road
    RG1 3EX Reading
    Berkshire
    Praktiker
    Kings Wharf 20-30 Kings Road
    RG1 3EX Reading
    Berkshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0