CANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04090240 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich CANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 21 Palmer Street SW1H 0AD London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MWB CANNON CENTRE LEASE NO.2 LIMITED | 26. Jan. 2001 | 26. Jan. 2001 |
| IBIS (625) LIMITED | 13. Okt. 2000 | 13. Okt. 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Okt. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Ms Lucy Baird als Direktor am 19. Juni 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Christine Anne Mattimore als Geschäftsführer am 19. Juni 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Ms Christine Anne Mattimore als Direktor am 27. Apr. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Sanne Secretaries Limited als Sekretär am 27. Apr. 2017 | 2 Seiten | AP04 | ||
Ernennung von Mr Anton Seatter als Direktor am 27. Apr. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Ian James Palmer Brown als Geschäftsführer am 27. Apr. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Ross Blair als Geschäftsführer am 27. Apr. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 100 New Bridge Street London EC4V 6JA zum 21 Palmer Street London SW1H 0AD am 15. Mai 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 5 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 040902400010 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 040902400009 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 9 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Michael James Topham als Geschäftsführer am 31. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 9 Seiten | AA | ||
Ernennung von Ross Blair als Direktor am 19. Dez. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Michael James Topham am 05. Dez. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von CANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANNE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Castle Street JE4 5UT St Helier 13 Jersey Channel Islands |
| 231525890001 | ||||||||||||
| BAIRD, Lucy | Geschäftsführer | Castle Street JE4 5UT St Helier 13 Jersey Channel Islands | Jersey | British | 214316900001 | |||||||||||
| SEATTER, Anton | Geschäftsführer | Palmer Street SW1H 0AD London 21 England | England | British | 231518160001 | |||||||||||
| REYNOLDS, Andrew John | Sekretär | The Portobello Arms Chartridge Lane Chartridge HP5 2TF Chesham Buckinghamshire | British | 70863380005 | ||||||||||||
| ROBSON SKEETE, Gail | Sekretär | 22a Woodpecker Copse Locks Heath SO31 6WS Southampton Hampshire | British | 66939460001 | ||||||||||||
| DECHERT NOMINEES LIMITED | Sekretär | 2 Serjeants Inn EC4Y 1LT London | 73625410001 | |||||||||||||
| FILEX SERVICES LIMITED | Sekretär | 179 Great Portland Street W1W 5LS London | 3620420001 | |||||||||||||
| BALFOUR-LYNN, Richard Gary | Geschäftsführer | Connaught Square W2 2HG London 6 | United Kingdom | British | 34251500001 | |||||||||||
| BIBRING, Michael Albert | Geschäftsführer | Conifers Hive Road WD23 1JG Bushey Heath Hertfordshire | England | British | 9320160002 | |||||||||||
| BLAIR, Ross | Geschäftsführer | Welbeck Street W1G 9YQ London 5 United Kingdom | United Kingdom | British | 154858730001 | |||||||||||
| BLURTON, Andrew Francis | Geschäftsführer | Old Cedar House Guildford Road GU6 8LT Cranleigh Surrey | England | British | 53724380001 | |||||||||||
| BROWN, Ian James Palmer | Geschäftsführer | Welbeck Street W1G 9YQ London 5 United Kingdom | England | British | 127801560001 | |||||||||||
| CONNOLLEY, Dominic | Geschäftsführer | 151 Gladstone Road Wimbledon SW19 1QS London | British | 119088700001 | ||||||||||||
| HARRISON, John William | Geschäftsführer | 97 Clifton Hill NW8 0JR London | United Kingdom | British | 69263980002 | |||||||||||
| JONES, Neil | Geschäftsführer | 29 Langland Gardens NW3 6QE London | American | 58464510001 | ||||||||||||
| LEWIS, Philip Geoffrey | Geschäftsführer | 1 Parkside NW7 2LJ London | England | British | 6639590001 | |||||||||||
| MATTIMORE, Christine Anne | Geschäftsführer | Palmer Street SW1H 0AD London 21 England | United Kingdom | American | 207880160001 | |||||||||||
| MUSGRAVE, Stephen Howard Rhodes | Geschäftsführer | 4 Haverfield Gardens Kew TW9 3DD Richmond Surrey | United Kingdom | British | 6981200001 | |||||||||||
| REYNOLDS, Andrew John | Geschäftsführer | The Portobello Arms Chartridge Lane Chartridge HP5 2TF Chesham Buckinghamshire | England | British | 70863380005 | |||||||||||
| RIDDELL, James Hendry | Geschäftsführer | 17 Clearwater House Langley Waterside BR3 3GD Beckenham Kent | England | British | 119000220001 | |||||||||||
| SHASHOU, Joseph Saleem | Geschäftsführer | 28 Elm Tree Road NW8 9JT London | United Kingdom | Brazilian | 51723030002 | |||||||||||
| SINGH, Jagtar | Geschäftsführer | 6 Paines Lane HA5 3DQ Pinner Middlesex | United Kingdom | British | 121710890001 | |||||||||||
| TOPHAM, Michael James | Geschäftsführer | Welbeck Street W1G 9YQ London 5 United Kingdom | United Kingdom | British | 153072620019 | |||||||||||
| WYPER, John Stuurman | Geschäftsführer | 100 New Bridge Street London EC4V 6JA | United Kingdom | Usa | 110361190007 | |||||||||||
| DECHERT NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | 2 Serjeants Inn EC4Y 1LT London | 73625410001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 Cannon Street Gp Limited | 06. Apr. 2016 | New Bridge Street EC4V 6JA London 100 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat CANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 13. Sept. 2013 Geliefert am 30. Sept. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Land and buildings at 78 cannon street london. Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 13. Sept. 2013 Geliefert am 30. Sept. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Land and buildings at 78 cannon street london. Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third party legal charge | Erstellt am 11. Juni 2009 Geliefert am 15. Juni 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from 78 cannon street limited partnership to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the l/h land and premises situate and k/a main block bush lane block and podium block situated on, over and under cannon street station cannon street london t/no. LN252045 and l/h land and premises situate at and k/a main block bush lane block and podium block situate on, over and under cannon street station cannon street london t/no. LN252857 and each and every part thereof including all rights powers easements and liberties attached inlcuding also all buildings erected including the development meaning the scheme of works to be carried out at the property of 400,000 sq ft of office accommodation over 8 storeys above mainline station na d approx 17,300 sq ft. Of retail accommodation see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Junior debenture | Erstellt am 07. Dez. 2007 Geliefert am 20. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mezzanine debenture | Erstellt am 26. März 2007 Geliefert am 30. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 26. März 2007 Geliefert am 30. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Dez. 2006 Geliefert am 22. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 78 cannon street london l/h t/no LN252045 fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill uncalled capital book debts buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mezzanine debenture | Erstellt am 12. Dez. 2006 Geliefert am 22. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 78 cannon street london l/h t/no LN252045 fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill uncalled capital book debts buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Juli 2002 Geliefert am 26. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the 78 cannon street limited partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture made between mwb cannon centre no.1 Limited, mwb cannon centre no.2 Limited, mwb cannon centre lease no.1 Limited, mwb cannon centre lease no. 2 limited (1) and the chargee (2) and 3 (the "debenture") | Erstellt am 15. März 2001 Geliefert am 20. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations due or to become due from any borrower to the chargee (as agent and trustee for the secured parties (as defined under (and as defined in) the credit agreement dated 16TH may 2000) under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0