TRAVELEX GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TRAVELEX GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04090247 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TRAVELEX GROUP LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich TRAVELEX GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 6 Snow Hill EC1A 2AY London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TRAVELEX GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TRAVELEX HOLDINGS LIMITED | 09. Jan. 2001 | 09. Jan. 2001 |
| IBIS (621) LIMITED | 13. Okt. 2000 | 13. Okt. 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TRAVELEX GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TRAVELEX GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Victoria Benis-Lonsdale als Sekretär am 17. Aug. 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ellen Loi als Sekretär am 17. Aug. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 9 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Kings Place 4th Floor, 90 York Way London N1 9AG United Kingdom zum 6 Snow Hill London EC1A 2AY am 12. Jan. 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 040902470008 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sylvain Marc Pignet als Geschäftsführer am 31. Juli 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 040902470008, erstellt am 05. Mai 2017 | 50 Seiten | MR01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 040902470007 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Ernennung von Miss Ellen Loi als Sekretär am 01. März 2017 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sylvain Marc Pignet als Sekretär am 01. März 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Apr. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Sylvain Marc Pignet als Direktor am 01. März 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Martyn Lewis Emmerson als Geschäftsführer am 15. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael David Ball als Geschäftsführer am 31. März 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Anthony Francis D'souza als Direktor am 31. März 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 2 Seiten | AUD | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TRAVELEX GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENIS-LONSDALE, Victoria | Sekretär | Imperial Mansions 13 Victoria Parade SE10 9FR London 18 United Kingdom | 249555300001 | |||||||
| BIRCH, James Edward Sullivan | Geschäftsführer | Snow Hill EC1A 2AY London 6 | United Kingdom | British | 88871990003 | |||||
| D'SOUZA, Anthony Francis | Geschäftsführer | Snow Hill EC1A 2AY London 6 | United Kingdom | British | 206676300001 | |||||
| KAHN, Clive Ian | Sekretär | 10 Totnes Walk N2 0AD London | British | 54658110001 | ||||||
| LOI, Ellen | Sekretär | Snow Hill EC1A 2AY London 6 | 230000710001 | |||||||
| PIGNET, Sylvain Marc | Sekretär | 4th Floor, 90 York Way N1 9AG London Kings Place United Kingdom | French | 74493960002 | ||||||
| DECHERT SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 2 Serjeants Inn EC4Y 1LT London | 78403190002 | |||||||
| BALL, Michael David | Geschäftsführer | 4th Floor, 90 York Way N1 9AG London Kings Place United Kingdom | United Kingdom | British | 58961410002 | |||||
| BIRCH, Peter Gibbs | Geschäftsführer | Bibury 24 Broad High Way KT11 2RP Cobham Surrey | United Kingdom | British | 58500710002 | |||||
| COLLEY, Ann | Geschäftsführer | 9 Penyale Longthorpe PE3 6RY Peterborough | British | 92838120001 | ||||||
| CONROY, John Gerald | Geschäftsführer | 620 Platinum House Lyon Road HA1 2EX Harrow | Irish | 63394000002 | ||||||
| CRAWFORD, Martin Andrew | Geschäftsführer | 76 Ellalong Road Cremorne Nsw 2090 Australia | Australian | 109128650001 | ||||||
| DAVAR, Mohit | Geschäftsführer | 12 Crespigny Road Hendon NW4 3DY London | United Kingdom | British | 33796970006 | |||||
| DORFMAN, Lloyd Marshall | Geschäftsführer | Travelex 65 Kingsway WC2B 6TD London | England | British | 89428640001 | |||||
| EMMERSON, Martyn Lewis | Geschäftsführer | 4th Floor, 90 York Way N1 9AG London Kings Place United Kingdom | United Kingdom | British | 119841680003 | |||||
| HAJILOU, Omid Amin | Geschäftsführer | 22 Saint Thomas Hill CT2 8EH Canterbury Kent | British | 64375780001 | ||||||
| HARRISON, Neil Andrew | Geschäftsführer | 5 Badinton Lane Bainton PE9 3AU Stamford Lincolnshire | England | British | 98878650001 | |||||
| HEMPSEY, John | Geschäftsführer | 152 Thorpe Road PE3 6JJ Peterborough Cambridgeshire | British | 82015990001 | ||||||
| HILL, Christopher Frederick | Geschäftsführer | 65 Kingsway London WC2B 6TD | United Kingdom | British | 113901470001 | |||||
| JONES, Richard Anthony | Geschäftsführer | 47 High Street Carlby PE9 4LX Stamford | England | British | 99586370001 | |||||
| KAHN, Clive Ian | Geschäftsführer | 10 Totnes Walk N2 0AD London | British | 54658110001 | ||||||
| MARTIN, John Walley | Geschäftsführer | Locksley Tennysons Lane GU27 3AF Haslemere Surrey | British | 143523590001 | ||||||
| PAGE, Nicholas Hurst | Geschäftsführer | 7 Ravenslea Road SW12 8SA London | United Kingdom | British | 14383680001 | |||||
| PAINTER, David Charles, Mr. | Geschäftsführer | Home Farmhouse Main Street Empingham LE15 8PS Oakham Rutland | United Kingdom | British | 42833940002 | |||||
| PIGNET, Sylvain Marc | Geschäftsführer | 4th Floor, 90 York Way N1 9AG London Kings Place United Kingdom | United Kingdom | French | 74493960002 | |||||
| RICHBELL, Keith Robert | Geschäftsführer | 12 Royal Close SW19 5RS London | British | 66258000003 | ||||||
| SHETTY, Yogesh | Geschäftsführer | 57 Royston Park Road Hatch End HA5 4AB Pinner London | British | 91631810001 | ||||||
| STEVENS, John, Lord | Geschäftsführer | Lgc Queens Road TW11 0LY Teddington Middlesex | United Kingdom | British | 69294240003 | |||||
| TAYLOR, Larry Douglas | Geschäftsführer | 64 Wandover Road Toronto Ontario M8x 2l3 Canada | Canadian | 109128770001 | ||||||
| WAGERMAN, Anthony | Geschäftsführer | 22 Park View Gardens NW4 2PN London | England | British | 109128860001 | |||||
| WHITEHOUSE, Melanie | Geschäftsführer | Home Farm Carlby PE9 4LX Stamford Lincs | British | 122290290001 | ||||||
| WILCKE, Stephan | Geschäftsführer | Parsifal Road NW6 1UH London 6 | England | German | 141699500001 | |||||
| DECHERT NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | 2 Serjeants Inn EC4Y 1LT London | 73625410001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TRAVELEX GROUP LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Dr Bavaguthu Raghuram Shetty | 06. Apr. 2016 | Snow Hill EC1A 2AY London 6 | Nein |
Nationalität: Indian Staatsangehörigkeit: United Arab Emirates | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat TRAVELEX GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 05. Mai 2017 Geliefert am 11. Mai 2017 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 01. Aug. 2013 Geliefert am 02. Aug. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Juni 2012 Geliefert am 12. Juni 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Aug. 2005 Geliefert am 19. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security trustee of any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed charges on all of its right title and interest in the following assets being the real property the tangible moveable property any goodwill and rights in relation to the uncalled capital the investments the shares all dividiends interest and other monies all monetary claims and all related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Nov. 2002 Geliefert am 27. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. März 2001 Geliefert am 09. Apr. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations which the company may at any time have to the trustee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or to the secured parties under or pursuant to the finance documents including any liability in respect of any further advances made under the finance documents, whether present or future, actual or contingent (and whether incurred solely or jointly and whether as principal or as surety or in some other capacity) and the company shall pay to the trustee when due and payable every sum at any time owing, due or incurred by the principals (or any member of the group) to the trustee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or to the secured parties in respect of any such liabilities | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security assignment over funding arrangement of even date made by the company in favour of the chargee as security trustee for the beneficiaries (as defined) | Erstellt am 27. März 2001 Geliefert am 09. Apr. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Each and every liability and obligation which the principals (as defined) (or any member of the group) may at any time have to the trustee (whether for its own account or as trustee for the secured parties (as defined)) or to the secured parties under or pursuant to the finance documents (both as defined) including any liability in respect of any further advances made under the finance documents whether present or future actual or contingent | |
Kurze Angaben The company assigns to the trustee as trustee for secured parties all its right title and interest in and to rights and claims on relation to assigned contracts collateral rights and related rights (all as defined). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Feb. 2001 Geliefert am 07. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat TRAVELEX GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0