CEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04091152 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich CEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CEDAR UK LIMITED | 23. Jan. 2001 | 23. Jan. 2001 |
| DIPLEMA 499 LIMITED | 17. Okt. 2000 | 17. Okt. 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 28. Feb. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für CEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 29. Nov. 2013
| 6 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Feb. 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Barbara Ann Firth am 11. Dez. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Feb. 2012 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Paul David Gibson am 06. Sept. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Feb. 2011 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Hilary Lowe als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Ernennung von Hilary Anne Lowe als Sekretär | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Harry Thompson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Gibson als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ms Vinodka Murria am 01. Juni 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Barbara Ann Firth am 01. Juni 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Paul David Gibson am 01. Jan. 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Feb. 2010 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRTH, Barbara Ann | Geschäftsführer | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey | United Kingdom | British | 73934790009 | |||||
| GIBSON, Paul David | Geschäftsführer | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey | United Kingdom | British | 192439290001 | |||||
| MURRIA, Vinodka | Geschäftsführer | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey | United Kingdom | British | 57998050002 | |||||
| BRANIFF, Edward | Sekretär | 19 Red Oak Lane FOREIGN Kinnelon New Jersey 07405 Usa | Us | 80613310001 | ||||||
| GIBSON, Paul David | Sekretär | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey | British | 192439290001 | ||||||
| HOSIE, Michael Douglas | Sekretär | Woodbine Cottage The Long Road GU10 4DL Rowledge Surrey | British | 23706640001 | ||||||
| LOWE, Hilary Anne | Sekretär | Portsmouth Road KT11 3HQ Cobham Munro House Surrey | British | 159479760001 | ||||||
| MADDOX, Adrienne Anne | Sekretär | 6 Heather Grove Hartley Wintney RG27 8SE Hook Hampshire | British | 84231690001 | ||||||
| TEACHEN, Sharon | Sekretär | 49 Arthur Road ME8 9BT Rainham Kent | British | 72383680001 | ||||||
| BRANIFF, Edward | Geschäftsführer | 19 Red Oak Lane FOREIGN Kinnelon New Jersey 07405 Usa | Us | 80613310001 | ||||||
| FRAGER, Todd | Geschäftsführer | 100 E Pratt Street IRISH Baltimore Md 21202 Usa | Us | 91869050001 | ||||||
| HARRISON, Michael Geoffrey | Geschäftsführer | Clive House Portsmouth Road KT10 9LH Esher Surrey | Great Britain | British | 42238790001 | |||||
| HOSIE, Michael Douglas | Geschäftsführer | Woodbine Cottage The Long Road GU10 4DL Rowledge Surrey | England | British | 23706640001 | |||||
| RAINE, Colin David | Geschäftsführer | 11 Chiltern Road SL6 1XA Maidenhead Berkshire | British | 74086510001 | ||||||
| REARDON, Jonathan Andrew | Geschäftsführer | Westfield Latchmore Bank Little Hallingbury CM22 7PH Bishops Stortford Hertfordshire | British | 46067390002 | ||||||
| RUMP, Thomas James | Geschäftsführer | 15319 Chinaberry Street North Potomac Maryland Md 20878 Usa | American | 88726780001 | ||||||
| THOMPSON, Mark Harry | Geschäftsführer | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey | United Kingdom | British | 156095450001 | |||||
| TIMOTHY, Fiona Maria | Geschäftsführer | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey | England | British | 161343370001 | |||||
| TIMOTHY, Fiona Maria | Geschäftsführer | Holly Cottage Kings Lane SL6 9AY Cookham Dean Berkshire | England | British | 161343370001 | |||||
| WEBSTER, Martin | Geschäftsführer | 9 West Square SE11 4SN London | British | 56348760002 |
Hat CEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 07. März 2007 Geliefert am 10. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Collateral assignment | Erstellt am 17. Dez. 2004 Geliefert am 31. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest in the subordinate tcgi pledge agreement,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third amended and restated pledge agreement | Erstellt am 17. Dez. 2004 Geliefert am 31. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The pledged shares and all proceeds,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Second amended and restated pledge agreement | Erstellt am 30. Mai 2003 Geliefert am 17. Juni 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the pledgor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the pledgor's right, title and interest in and to all dividends and interest on the pledged shares, all proceeds of the pledges shares and any of the other collateral, all collateral, liens and security interests, all other securities, money or other property, all other rights with respect to the foregoing collateral. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share pledge agreement | Erstellt am 15. Mai 2003 Geliefert am 23. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The pledged securities, all dividends, moneys and all other property and all cash, securities rights and interests in respect thereof. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Apr. 2003 Geliefert am 09. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Okt. 2001 Geliefert am 15. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0