CEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED

CEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04091152
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich CEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CEDAR UK LIMITED23. Jan. 200123. Jan. 2001
    DIPLEMA 499 LIMITED17. Okt. 200017. Okt. 2000

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis28. Feb. 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für CEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Kapitalaufstellung am 29. Nov. 2013

    • Kapital: GBP 1
    6 SeitenSH19

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Reduce share prem a/c 08/11/2013
    RES13

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Feb. 2013

    6 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mrs Barbara Ann Firth am 11. Dez. 2012

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Feb. 2012

    7 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Paul David Gibson am 06. Sept. 2012

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Feb. 2011

    7 SeitenAA

    legacy

    3 SeitenMG02

    Beendigung der Bestellung von Hilary Lowe als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Hilary Anne Lowe als Sekretär

    3 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Mark Harry Thompson als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Paul Gibson als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Ms Vinodka Murria am 01. Juni 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mrs Barbara Ann Firth am 01. Juni 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Paul David Gibson am 01. Jan. 2010

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Feb. 2010

    7 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von CEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FIRTH, Barbara Ann
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish73934790009
    GIBSON, Paul David
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish192439290001
    MURRIA, Vinodka
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish57998050002
    BRANIFF, Edward
    19 Red Oak Lane
    FOREIGN Kinnelon
    New Jersey 07405
    Usa
    Sekretär
    19 Red Oak Lane
    FOREIGN Kinnelon
    New Jersey 07405
    Usa
    Us80613310001
    GIBSON, Paul David
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Sekretär
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    British192439290001
    HOSIE, Michael Douglas
    Woodbine Cottage The Long Road
    GU10 4DL Rowledge
    Surrey
    Sekretär
    Woodbine Cottage The Long Road
    GU10 4DL Rowledge
    Surrey
    British23706640001
    LOWE, Hilary Anne
    Portsmouth Road
    KT11 3HQ Cobham
    Munro House
    Surrey
    Sekretär
    Portsmouth Road
    KT11 3HQ Cobham
    Munro House
    Surrey
    British159479760001
    MADDOX, Adrienne Anne
    6 Heather Grove
    Hartley Wintney
    RG27 8SE Hook
    Hampshire
    Sekretär
    6 Heather Grove
    Hartley Wintney
    RG27 8SE Hook
    Hampshire
    British84231690001
    TEACHEN, Sharon
    49 Arthur Road
    ME8 9BT Rainham
    Kent
    Sekretär
    49 Arthur Road
    ME8 9BT Rainham
    Kent
    British72383680001
    BRANIFF, Edward
    19 Red Oak Lane
    FOREIGN Kinnelon
    New Jersey 07405
    Usa
    Geschäftsführer
    19 Red Oak Lane
    FOREIGN Kinnelon
    New Jersey 07405
    Usa
    Us80613310001
    FRAGER, Todd
    100 E Pratt Street
    IRISH Baltimore
    Md 21202
    Usa
    Geschäftsführer
    100 E Pratt Street
    IRISH Baltimore
    Md 21202
    Usa
    Us91869050001
    HARRISON, Michael Geoffrey
    Clive House Portsmouth Road
    KT10 9LH Esher
    Surrey
    Geschäftsführer
    Clive House Portsmouth Road
    KT10 9LH Esher
    Surrey
    Great BritainBritish42238790001
    HOSIE, Michael Douglas
    Woodbine Cottage The Long Road
    GU10 4DL Rowledge
    Surrey
    Geschäftsführer
    Woodbine Cottage The Long Road
    GU10 4DL Rowledge
    Surrey
    EnglandBritish23706640001
    RAINE, Colin David
    11 Chiltern Road
    SL6 1XA Maidenhead
    Berkshire
    Geschäftsführer
    11 Chiltern Road
    SL6 1XA Maidenhead
    Berkshire
    British74086510001
    REARDON, Jonathan Andrew
    Westfield Latchmore Bank
    Little Hallingbury
    CM22 7PH Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Westfield Latchmore Bank
    Little Hallingbury
    CM22 7PH Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British46067390002
    RUMP, Thomas James
    15319 Chinaberry Street
    North Potomac
    Maryland Md 20878
    Usa
    Geschäftsführer
    15319 Chinaberry Street
    North Potomac
    Maryland Md 20878
    Usa
    American88726780001
    THOMPSON, Mark Harry
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    Geschäftsführer
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United KingdomBritish156095450001
    TIMOTHY, Fiona Maria
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    EnglandBritish161343370001
    TIMOTHY, Fiona Maria
    Holly Cottage
    Kings Lane
    SL6 9AY Cookham Dean
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Holly Cottage
    Kings Lane
    SL6 9AY Cookham Dean
    Berkshire
    EnglandBritish161343370001
    WEBSTER, Martin
    9 West Square
    SE11 4SN London
    Geschäftsführer
    9 West Square
    SE11 4SN London
    British56348760002

    Hat CEDAR CONSULTING HOLDINGS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 07. März 2007
    Geliefert am 10. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Juli 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Collateral assignment
    Erstellt am 17. Dez. 2004
    Geliefert am 31. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in the subordinate tcgi pledge agreement,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 31. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Third amended and restated pledge agreement
    Erstellt am 17. Dez. 2004
    Geliefert am 31. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The pledged shares and all proceeds,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 31. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Second amended and restated pledge agreement
    Erstellt am 30. Mai 2003
    Geliefert am 17. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the pledgor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the pledgor's right, title and interest in and to all dividends and interest on the pledged shares, all proceeds of the pledges shares and any of the other collateral, all collateral, liens and security interests, all other securities, money or other property, all other rights with respect to the foregoing collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Share pledge agreement
    Erstellt am 15. Mai 2003
    Geliefert am 23. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The pledged securities, all dividends, moneys and all other property and all cash, securities rights and interests in respect thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 30. Apr. 2003
    Geliefert am 09. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 11. Okt. 2001
    Geliefert am 15. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0