KAT-O-LOG LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameKAT-O-LOG LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04091992
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von KAT-O-LOG LIMITED?

    • Erzeugung von Elektrizität (35110) / Versorgung mit Elektrizität, Gas, Dampf und klimatisierten Luft
    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
    • Vermietung und Leasing von anderen Maschinen, Geräten und Sachanlagen n.a. (77390) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich KAT-O-LOG LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Old Town Hall
    71 Christchurch Road
    BH24 1DH Ringwood
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KAT-O-LOG LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2021

    Welche sind die letzten Einreichungen für KAT-O-LOG LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    18 SeitenLIQ13

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Leeward House Fitzroy Road Exeter Business Park Exeter Devon EX1 3LJ zum The Old Town Hall 71 Christchurch Road Ringwood BH24 1DH am 14. Okt. 2022

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 07. Okt. 2022

    LRESSP

    Änderung der Details des Direktors für Mr Adrian Gamble am 18. Aug. 2022

    2 SeitenCH01

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    2 SeitenMR04

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2021

    11 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Sept. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2020

    11 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Sept. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2019

    12 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Sept. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2018

    11 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Sept. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2017

    11 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    6 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2016

    8 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Sept. 2016 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2015

    8 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von KAT-O-LOG LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GAMBLE, Diana Ruth
    Adsborough
    TA2 8RN Taunton
    Leversdown House
    Somerset
    Sekretär
    Adsborough
    TA2 8RN Taunton
    Leversdown House
    Somerset
    BritishChartered Physiotherapist92119970002
    GAMBLE, Adrian
    Adsborough
    TA2 8RN Taunton
    Leversdown House
    Somerset
    Geschäftsführer
    Adsborough
    TA2 8RN Taunton
    Leversdown House
    Somerset
    United KingdomBritishCompany Director2353790006
    GAMBLE, Diana Ruth
    Adsborough
    TA2 8RN Taunton
    Leversdown House
    Somerset
    Geschäftsführer
    Adsborough
    TA2 8RN Taunton
    Leversdown House
    Somerset
    United KingdomBritishChartered Physiotherapist92119970002
    GAMBLE, Michael Darren, Rev
    71 Christchurch Road
    BH24 1DH Ringwood
    The Old Town Hall
    Geschäftsführer
    71 Christchurch Road
    BH24 1DH Ringwood
    The Old Town Hall
    EnglandBritishPriest169710090001
    BROOKES, Reginald Herbert
    21 Chatsworth Park
    BS35 1JF Thornbury
    South Gloucestershire
    Sekretär
    21 Chatsworth Park
    BS35 1JF Thornbury
    South Gloucestershire
    BritishConsultant74288720001
    GAMBLE, Clive Anthony
    3 Cider Cottages
    Plantation Road
    LU7 3HT Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Sekretär
    3 Cider Cottages
    Plantation Road
    LU7 3HT Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British83660590001
    NUNEZ-MAIRA, Marcos
    11 River Meadows
    Water Lane
    EX2 8BD Exeter
    Devon
    Sekretär
    11 River Meadows
    Water Lane
    EX2 8BD Exeter
    Devon
    British72406390001
    WALSH, Frances Elizabeth
    18 South Street
    Newport
    EX31 9DT Barnstaple
    Sekretär
    18 South Street
    Newport
    EX31 9DT Barnstaple
    BritishFinancial Controller68300980002
    KELIHER, James Adam
    Homestone House
    Fore Street
    EX9 7HB Otterton
    Devon
    Geschäftsführer
    Homestone House
    Fore Street
    EX9 7HB Otterton
    Devon
    EnglandBritishSolicitor159011340001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei KAT-O-LOG LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mrs Diana Ruth Gamble
    71 Christchurch Road
    BH24 1DH Ringwood
    The Old Town Hall
    06. Apr. 2016
    71 Christchurch Road
    BH24 1DH Ringwood
    The Old Town Hall
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: United Kingdom
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    Mr Adrian Gamble
    71 Christchurch Road
    BH24 1DH Ringwood
    The Old Town Hall
    06. Apr. 2016
    71 Christchurch Road
    BH24 1DH Ringwood
    The Old Town Hall
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: United Kingdom
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat KAT-O-LOG LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage
    Erstellt am 19. Okt. 2006
    Geliefert am 26. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit B3 brannam court roundswell business park barnstaple t/no DN536187. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juni 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 06. Okt. 2006
    Geliefert am 14. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juni 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 06. Okt. 2006
    Geliefert am 12. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H atlas packaging unit barrow way barnstaple t/no DN415584. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Mai 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 06. Okt. 2006
    Geliefert am 12. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h land adjacent atlas packaging unit barrow way barnstaple. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Mai 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Juni 2006
    Geliefert am 13. Juni 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a unit B3 (formerly 2C) brannam court brannam crescent roundswell business park barnstaple. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 13. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture (floating charge)
    Erstellt am 01. Juni 2006
    Geliefert am 13. Juni 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First floating charge all property and assets both present and future from time to time owned by the company or in which the company may have an interest. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 13. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. März 2006
    Geliefert am 11. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at barron way roundswell business park barnstaple devon. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 11. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture (floating charge)
    Erstellt am 11. Apr. 2003
    Geliefert am 23. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 23. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Apr. 2003
    Geliefert am 23. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold property known as land on south side of batton way roundswell barnstaple north devon title number DN415584. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 23. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat KAT-O-LOG LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    07. Okt. 2022Beginn der Liquidation
    18. Aug. 2023Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David Patrick Meany
    The Old Town Hall 71 Christchurch Road
    BH24 1DH Ringwood
    Praktiker
    The Old Town Hall 71 Christchurch Road
    BH24 1DH Ringwood
    Richard Wragg
    The Old Town Hall 71 Christchurch Road
    BH24 1DH Ringwood
    Hampshire
    Praktiker
    The Old Town Hall 71 Christchurch Road
    BH24 1DH Ringwood
    Hampshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0