MUNOC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED

MUNOC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMUNOC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04097557
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MUNOC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    • (7011) /

    Wo befindet sich MUNOC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Uhy Hacker Young
    St James Building
    M1 6HT 79 Oxford Street
    Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MUNOC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    OCM PROPERTY INVESTMENTS LIMITED04. Sept. 200304. Sept. 2003
    GALWAY DEVELOPMENTS LIMITED27. Okt. 200027. Okt. 2000

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MUNOC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Mai 2006

    Welche sind die letzten Einreichungen für MUNOC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    legacy

    2 SeitenLQ02

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 15. Sept. 2012

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 15. Sept. 2012

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 15. Sept. 2012

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 15. Sept. 2012

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 17. Dez. 2012

    2 Seiten3.6

    Hinweis auf den Abschlussbericht vor der Auflösung

    4 Seiten4.43

    legacy

    2 SeitenLQ02

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 28. Aug. 2012

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 06. Sept. 2012

    2 Seiten3.6

    legacy

    2 SeitenLQ02

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 27. Juli 2012

    2 Seiten3.6

    legacy

    1 SeitenLQ02

    legacy

    1 SeitenLQ02

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 05. Juli 2012

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 27. März 2012

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 27. Sept. 2011

    2 Seiten3.6

    legacy

    3 SeitenLQ01

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 27. März 2012

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 27. Sept. 2011

    2 Seiten3.6

    legacy

    3 SeitenLQ01

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 27. März 2012

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 27. Sept. 2011

    2 Seiten3.6

    legacy

    3 SeitenLQ01

    Wer sind die Geschäftsführer von MUNOC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MUNRO, Brian Martin
    C/O Uhy Hacker Young
    St James Building
    M1 6HT 79 Oxford Street
    Manchester
    Sekretär
    C/O Uhy Hacker Young
    St James Building
    M1 6HT 79 Oxford Street
    Manchester
    Irish71739370003
    MUNRO, Brian Martin
    C/O Uhy Hacker Young
    St James Building
    M1 6HT 79 Oxford Street
    Manchester
    Geschäftsführer
    C/O Uhy Hacker Young
    St James Building
    M1 6HT 79 Oxford Street
    Manchester
    United KingdomIrish71739370003
    DCS CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    1 Ashfield Road
    SK3 8UD Stockport
    Cheshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    1 Ashfield Road
    SK3 8UD Stockport
    Cheshire
    900020110001
    BULLER, Scott
    430 Walkden Road
    Worsley
    M28 2NE Manchester
    Geschäftsführer
    430 Walkden Road
    Worsley
    M28 2NE Manchester
    United KingdomBritish99053290002
    O'CONNOR, Gerard
    Greyhound Cottage
    1 Manor Road
    IG7 5PF Chigwell
    Essex
    Geschäftsführer
    Greyhound Cottage
    1 Manor Road
    IG7 5PF Chigwell
    Essex
    United KingdomIrish81856550002
    DCS NOMINEES LIMITED
    1 Ashfield Road
    SK3 8UD Stockport
    Cheshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    1 Ashfield Road
    SK3 8UD Stockport
    Cheshire
    900020100001

    Hat MUNOC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal and general charge
    Erstellt am 21. Nov. 2007
    Geliefert am 30. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H flat 11 north tower, victoria bridge street, salford (also k/a apt 1303) t/n GM884925. L/h flat 34 north tower, victoria bridge street, salford (also k/a apt 1602) t/n GM839663. L/h flat 35 north tower, victoria bridge street, salford (also k/a apt 1603) t/n GM839664 (for details of further properties charged please see form 395) by way of fixed charge other property at any time hereinafter vested in the company all the company's uncalled capital for the time being and all its intellectual property rights and all other f/h and l/h property the company's stock in trade and plant all it's land interests it's book debts by way of assignment the related rights the company's undertaking by way of floating charge. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National PLC
    Transaktionen
    • 30. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Jan. 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
      • Aktenzeichen 13
    Legal and general charge
    Erstellt am 21. Nov. 2007
    Geliefert am 30. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 5 and 7 duncan street salford t/nos GM870862 and LA51072 by way of fixed charge other property at any time hereinafter vested in the company all the company's uncalled capital for the time being and all its intellectual property rights and all other f/h and l/h property the company's stock in trade and plant all it's land interests it's book debts by way of assignment the related rights the company's undertaking by way of floating charge.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National PLC
    Transaktionen
    • 30. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Aug. 2007
    Geliefert am 05. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    16 ashtree road crumpsall manchester t/no LA285920. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 05. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 1701. Apr. 2010Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 1720. Sept. 2010Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 17
    Legal charge
    Erstellt am 31. Aug. 2007
    Geliefert am 05. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    18 ashtree road crumpsall manchester t/no LA67264. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 05. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 1801. Apr. 2010Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 1820. Sept. 2010Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 18
    Legal charge
    Erstellt am 31. Aug. 2007
    Geliefert am 05. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    19 columbia road bolton t/no LA341423. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 05. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 1901. Apr. 2010Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 1920. Sept. 2010Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 19
    Legal charge
    Erstellt am 31. Aug. 2007
    Geliefert am 05. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    21 columbia road bolton t/no LA341422. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 05. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 2001. Apr. 2010Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 2020. Sept. 2010Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 20
    Legal charge
    Erstellt am 25. Juli 2007
    Geliefert am 28. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a 11-21 crawford avenue bolton greater manchester t/n GM178147 the related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National PLC
    Transaktionen
    • 28. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Jan. 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
      • Aktenzeichen 12
    Legal charge
    Erstellt am 28. Juni 2007
    Geliefert am 11. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 49 richmond street manchester t/n GM832285 and all its fixtures and all income relating to the property and the proceeds of sale of the company in relation to the property.assigns the related rights.by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery.by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and the undertaking and all other property assets and rights present and future.assigns goodwill and intellectual property.
    Berechtigte Personen
    • Skipton Building Society
    Transaktionen
    • 11. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Dez. 2008Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 3624. Juli 2012Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
      • Aktenzeichen 9
      • Aktenzeichen 36
    Legal charge
    Erstellt am 28. Juni 2007
    Geliefert am 11. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 47 richmond street manchester t/n GM827495 and all its fixtures and all income relating to the property and the proceeds of sale of the company in relation to the property.assigns the related rights.by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery.by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and the undertaking and all other property assets and rights present and future.assigns goodwill and intellectual property.
    Berechtigte Personen
    • Skipton Building Society
    Transaktionen
    • 11. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Dez. 2008Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 3524. Juli 2012Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 3528. Aug. 2012Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 8
      • Aktenzeichen 35
    Legal charge
    Erstellt am 28. Juni 2007
    Geliefert am 11. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 45 richomond street manchester t/n GM809510 and all its fixtures and all income relating to the property and the proceeds of sale of the company in relation to the property.assigns the related rights.by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery.by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and the undertaking and all other property assets and rights present and future.assigns goodwill and intellectual property.
    Berechtigte Personen
    • Skipton Building Society
    Transaktionen
    • 11. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Dez. 2008Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 3424. Juli 2012Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 3415. Feb. 2013Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 7
      • Aktenzeichen 34
    Legal charge
    Erstellt am 28. Juni 2007
    Geliefert am 11. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 43 richmond street manchester t/n GM832286 and all its fixtures and all income relating to the property and the proceeds of sale of the company in relation to the property.assigns the related rights.by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery.by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and the undertaking and all other property assets and rights present and future.assigns goodwill and intellectual property.
    Berechtigte Personen
    • Skipton Building Society
    Transaktionen
    • 11. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Dez. 2008Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 2328. Sept. 2010Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 2326. Sept. 2012Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 6
      • Aktenzeichen 23
    Legal charge
    Erstellt am 28. Juni 2007
    Geliefert am 07. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    14 stone street manchester and all its fixtures and all income relating to the property and the proceeds of sale of the company in relation to the property.assigns the related rights.by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery.by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and the undertaking and all other property assets and rights present and future.assigns goodwill and intellectual property.
    Berechtigte Personen
    • Skipton Building Society
    Transaktionen
    • 07. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Dez. 2008Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 2428. Sept. 2010Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 3314. Juni 2011Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
      • Aktenzeichen 5
      • Aktenzeichen 24
      • Aktenzeichen 33
    Legal charge
    Erstellt am 28. Juni 2007
    Geliefert am 07. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    12 stone street manchester and all its fixtures and all income relating to the property and the proceeds of sale of the company in relation to the property.assigns the related rights.by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery.by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and the undertaking and all other property assets and rights present and future.assigns goodwill and intellectual property.
    Berechtigte Personen
    • Skipton Building Society
    Transaktionen
    • 07. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Dez. 2008Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 2528. Sept. 2010Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 3214. Juni 2011Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
      • Aktenzeichen 3
      • Aktenzeichen 25
      • Aktenzeichen 32
    Legal charge
    Erstellt am 28. Juni 2007
    Geliefert am 07. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    10 stone street manchester and all its fixtures and all income relating to the property and the proceeds of sale of the company in relation to the property.assigns the related rights.by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery.by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and the undertaking and all other property assets and rights present and future.assigns goodwill and intellectual property.
    Berechtigte Personen
    • Skipton Building Society
    Transaktionen
    • 07. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Dez. 2008Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 2816. Okt. 2010Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 3114. Juni 2011Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
      • Aktenzeichen 2
      • Aktenzeichen 28
      • Aktenzeichen 31
    Legal charge
    Erstellt am 28. Juni 2007
    Geliefert am 07. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    8 stone street manchester and all its fixtures and all income relating to the property and the proceeds of sale of the company in relation to the property.assigns the related rights.by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery.by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and the undertaking and all other property assets and rights present and future.assigns goodwill and intellectual property.
    Berechtigte Personen
    • Skipton Building Society
    Transaktionen
    • 07. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Dez. 2008Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 2628. Sept. 2010Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 2914. Juni 2011Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
      • Aktenzeichen 4
      • Aktenzeichen 26
      • Aktenzeichen 29
    Legal charge
    Erstellt am 28. Juni 2007
    Geliefert am 07. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    6 stone street manchester and all its fixtures and all income relating to the property and the proceeds of sale of the company in relation to the property.assigns the related rights.by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery.by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and the undertaking and all other property assets and rights present and future.assigns goodwill and intellectual property.
    Berechtigte Personen
    • Skipton Building Society
    Transaktionen
    • 07. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Dez. 2008Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 2728. Sept. 2010Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 3014. Juni 2011Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 3018. Aug. 2012Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 1
      • Aktenzeichen 27
      • Aktenzeichen 30
    Legal and general charge
    Erstellt am 25. Mai 2007
    Geliefert am 06. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the group on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H properties k/a 12 howe street, broughton, salford, greater manchester t/n GM106360, 47 station road, crumpsall, manchester t/n GM515297 and l/h property k/a 11-21 (odd numbers) crawford avenue, bolton, greater manchester, uncalled capital and all intellectual property rights, any securities, stock in trade and plant and by way of floating charge the undertaking and any assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National PLC
    Transaktionen
    • 06. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Jan. 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
      • Aktenzeichen 11
    Legal charge
    Erstellt am 25. Mai 2007
    Geliefert am 06. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the group on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 47 station road, crumpsall, manchester t/n GM515297, and all the related rights.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National PLC
    Transaktionen
    • 06. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Jan. 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
      • Aktenzeichen 10
    Legal charge
    Erstellt am 25. Mai 2007
    Geliefert am 06. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the group on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 12 howe street, broughton, salford, greater manchester t/n GM106360, and all the related rights.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National PLC
    Transaktionen
    • 06. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 30. März 2007
    Geliefert am 03. Apr. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 157 and 159 bury old road, salford, manchester t/nos LA52220 & LA241572.
    Berechtigte Personen
    • Davenham Trust PLC
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. März 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
      • Aktenzeichen 14
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. März 2007
    Geliefert am 21. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land and building k/a 27 and 29 polygon road, crumpsall, manchester t/nos LA227993 and GM350949. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juni 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
      • Aktenzeichen 16
    Legal charge
    Erstellt am 27. Feb. 2007
    Geliefert am 01. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings at 12 howe street off great clowes street salford manchester t/no gm 106360 and 82/84 bury old road whitefield t/nos gm 206617 and gm 37803 together with a separate fixed charge all goodwill and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transaktionen
    • 01. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 27. Feb. 2007
    Geliefert am 01. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    12 howe street salford t/nos gm 106306 and 82/84 bury old road whitefield manchester t/nos gm 37803 and gm 206617 together with a fixed charge all estates or interest in any f/h and l/h property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transaktionen
    • 01. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. Feb. 2007
    Geliefert am 22. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h land and buildings known as 10 mayfield road whalley range manchester t/n LA187660,. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC T/a Yorkshire Bank
    Transaktionen
    • 22. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juni 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
      • Aktenzeichen 15
    Legal charge
    Erstellt am 25. Sept. 2006
    Geliefert am 04. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The l/h land being 78-88 (even) bury old road whitefield t/n GM206617 and the l/h land being 84 bury old road whitefield t/n GM37803,. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 2214. Juli 2010Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 2221. Sept. 2012Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 22

    Hat MUNOC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen Molloy
    Property House
    Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    Receiver Manager
    Property House
    Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    David Robert Heap
    Property House Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    West Yorkshire
    Receiver Manager
    Property House Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    West Yorkshire
    2Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen Molloy
    Property House
    Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    Receiver Manager
    Property House
    Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    David Robert Heap
    Property House Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    West Yorkshire
    Receiver Manager
    Property House Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    West Yorkshire
    3Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen Molloy
    Property House
    Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    Receiver Manager
    Property House
    Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    David Robert Heap
    Property House Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    West Yorkshire
    Receiver Manager
    Property House Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    West Yorkshire
    4Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen Molloy
    Property House
    Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    Receiver Manager
    Property House
    Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    David Robert Heap
    Property House Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    West Yorkshire
    Receiver Manager
    Property House Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    West Yorkshire
    5Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen Molloy
    Property House
    Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    Receiver Manager
    Property House
    Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    David Robert Heap
    Property House Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    West Yorkshire
    Receiver Manager
    Property House Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    West Yorkshire
    6Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen Molloy
    Property House
    Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    Receiver Manager
    Property House
    Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    David Robert Heap
    Property House Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    West Yorkshire
    Receiver Manager
    Property House Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    West Yorkshire
    7Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen Molloy
    Property House
    Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    Receiver Manager
    Property House
    Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    David Robert Heap
    Property House Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    West Yorkshire
    Receiver Manager
    Property House Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    West Yorkshire
    8Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen Molloy
    Property House
    Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    Receiver Manager
    Property House
    Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    David Robert Heap
    Property House Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    West Yorkshire
    Receiver Manager
    Property House Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    West Yorkshire
    9Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen Molloy
    Property House
    Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    Receiver Manager
    Property House
    Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    David Robert Heap
    Property House Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    West Yorkshire
    Receiver Manager
    Property House Lister Lane
    HX1 5AS Halifax
    West Yorkshire
    10Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David Robert Acland
    Begbies Traynor
    1 Winckley Court
    PR1 8BU Chapel Street
    Preston
    Receiver Manager
    Begbies Traynor
    1 Winckley Court
    PR1 8BU Chapel Street
    Preston
    Steven John Williams
    Begbies Traynor
    1 Winckley Court
    PR1 8BU Chapel Street
    Preston
    Receiver Manager
    Begbies Traynor
    1 Winckley Court
    PR1 8BU Chapel Street
    Preston
    11Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David Robert Acland
    Begbies Traynor
    1 Winckley Court
    PR1 8BU Chapel Street
    Preston
    Receiver Manager
    Begbies Traynor
    1 Winckley Court
    PR1 8BU Chapel Street
    Preston
    Steven John Williams
    Begbies Traynor
    1 Winckley Court
    PR1 8BU Chapel Street
    Preston
    Receiver Manager
    Begbies Traynor
    1 Winckley Court
    PR1 8BU Chapel Street
    Preston
    12Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David Robert Acland
    Begbies Traynor
    1 Winckley Court
    PR1 8BU Chapel Street
    Preston
    Receiver Manager
    Begbies Traynor
    1 Winckley Court
    PR1 8BU Chapel Street
    Preston
    Steven John Williams
    Begbies Traynor
    1 Winckley Court
    PR1 8BU Chapel Street
    Preston
    Receiver Manager
    Begbies Traynor
    1 Winckley Court
    PR1 8BU Chapel Street
    Preston
    13Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David Robert Acland
    Begbies Traynor
    1 Winckley Court
    PR1 8BU Chapel Street
    Preston
    Receiver Manager
    Begbies Traynor
    1 Winckley Court
    PR1 8BU Chapel Street
    Preston
    Steven John Williams
    Begbies Traynor
    1 Winckley Court
    PR1 8BU Chapel Street
    Preston
    Receiver Manager
    Begbies Traynor
    1 Winckley Court
    PR1 8BU Chapel Street
    Preston
    14Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David John Whitehouse
    11 St James Square
    M2 6WH Manchester
    Receiver Manager
    11 St James Square
    M2 6WH Manchester
    Steven Muncaster
    11 St James Square
    M2 6DN Manchester
    Receiver Manager
    11 St James Square
    M2 6DN Manchester
    15Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Keith Roe
    Eddisons
    Pennine House
    LS1 5RN Russell Street
    Leeds
    Receiver Manager
    Eddisons
    Pennine House
    LS1 5RN Russell Street
    Leeds
    Anthony Lavern Spencer
    Eddisons
    Pennine House
    LS1 5RN Russell Street
    Leeds
    Receiver Manager
    Eddisons
    Pennine House
    LS1 5RN Russell Street
    Leeds
    16Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Keith Roe
    Eddisons
    Pennine House
    LS1 5RN Russell Street
    Leeds
    Receiver Manager
    Eddisons
    Pennine House
    LS1 5RN Russell Street
    Leeds
    Anthony Lavern Spencer
    Eddisons
    Pennine House
    LS1 5RN Russell Street
    Leeds
    Receiver Manager
    Eddisons
    Pennine House
    LS1 5RN Russell Street
    Leeds
    17Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jonathon David Brownlow
    334 Deansgate
    Manchester
    M3 4ly
    Receiver Manager
    334 Deansgate
    Manchester
    M3 4ly
    Jeffrey Ian Wignall
    334 Deansgate
    Manchester
    M3 4ly
    Receiver Manager
    334 Deansgate
    Manchester
    M3 4ly
    18Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jonathon David Brownlow
    334 Deansgate
    Manchester
    M3 4ly
    Receiver Manager
    334 Deansgate
    Manchester
    M3 4ly
    Jeffrey Ian Wignall
    334 Deansgate
    Manchester
    M3 4ly
    Receiver Manager
    334 Deansgate
    Manchester
    M3 4ly
    19Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jonathon David Brownlow
    334 Deansgate
    Manchester
    M3 4ly
    Receiver Manager
    334 Deansgate
    Manchester
    M3 4ly
    Jeffrey Ian Wignall
    334 Deansgate
    Manchester
    M3 4ly
    Receiver Manager
    334 Deansgate
    Manchester
    M3 4ly
    20Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jonathon David Brownlow
    334 Deansgate
    Manchester
    M3 4ly
    Receiver Manager
    334 Deansgate
    Manchester
    M3 4ly
    Jeffrey Ian Wignall
    334 Deansgate
    Manchester
    M3 4ly
    Receiver Manager
    334 Deansgate
    Manchester
    M3 4ly
    21
    DatumTyp
    22. Nov. 2012Abschluss der Liquidation
    04. Feb. 2010Antragsdatum
    29. März 2010Beginn der Liquidation
    27. Feb. 2013Aufgelöst am
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John H C Lee
    Belgrave Place Horsfields
    8 Manchester Road
    BL9 0ED Bury
    Lancs
    Praktiker
    Belgrave Place Horsfields
    8 Manchester Road
    BL9 0ED Bury
    Lancs
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Praktiker
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    22Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Anne Clare O'Keefe
    Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Receiver Manager
    Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Simon Wilson
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Receiver Manager
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Kevin James Coates
    Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Receiver Manager
    Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    23Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Anthony Gene Salata
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Receiver Manager
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Antony Mervyn Jorden
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Receiver Manager
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    24Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Anthony Gene Salata
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Receiver Manager
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Antony Mervyn Jorden
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Receiver Manager
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    25Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Anthony Gene Salata
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Receiver Manager
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Antony Mervyn Jorden
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Receiver Manager
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    26Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Anthony Gene Salata
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Receiver Manager
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Antony Mervyn Jorden
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Receiver Manager
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    27Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Anthony Gene Salata
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Receiver Manager
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Antony Mervyn Jorden
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Receiver Manager
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    28Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Anthony Gene Salata
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Receiver Manager
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Antony Mervyn Jorden
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Receiver Manager
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    29Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Antony Mervyn Jorden
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Receiver Manager
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Anthony Gene Salata
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Receiver Manager
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    30Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Antony Mervyn Jorden
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Receiver Manager
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Anthony Gene Salata
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Receiver Manager
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    31Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Antony Mervyn Jorden
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Receiver Manager
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Anthony Gene Salata
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Receiver Manager
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    32Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Antony Mervyn Jorden
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Receiver Manager
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Anthony Gene Salata
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Receiver Manager
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    33Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Antony Mervyn Jorden
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Receiver Manager
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Anthony Gene Salata
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Receiver Manager
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    34Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Antony Mervyn Jorden
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Receiver Manager
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Anthony Gene Salata
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Receiver Manager
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    35Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Antony Mervyn Jorden
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Receiver Manager
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Anthony Gene Salata
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Receiver Manager
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    36Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Antony Mervyn Jorden
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Receiver Manager
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Anthony Gene Salata
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London
    Receiver Manager
    33 Cork Street
    W1S 3NQ London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0