SGFLD LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSGFLD LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04099830
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SGFLD LIMITED?

    • Finanzleasing (64910) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich SGFLD LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SGFLD LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SG FINANCE LEASING (DECEMBER) LIMITED07. Sept. 201207. Sept. 2012
    SG LEASING (SEPTEMBER) LIMITED28. Juni 200728. Juni 2007
    SG LEASING (SHIP 1) LIMITED26. Okt. 200026. Okt. 2000

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SGFLD LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Apr. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für SGFLD LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 SeitenLIQ13

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Group Legal Sg House 41 Tower Hill London EC3N 4SG zum 15 Canada Square London E14 5GL am 27. Aug. 2019

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 06. Aug. 2019

    LRESSP

    Beendigung der Bestellung von Lindsay Ginnette Sides als Geschäftsführer am 05. Aug. 2019

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Paul Shields als Geschäftsführer am 20. Mai 2019

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Stuart Donald Cook als Geschäftsführer am 05. Apr. 2019

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2018

    24 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Stephen Lethbridge Fowler am 20. Sept. 2018

    2 SeitenCH01

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    4 SeitenMR04

    Ernennung von Mr. Paul Shields als Direktor am 19. März 2018

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2017

    22 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    5 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    6 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    5 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    6 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Wer sind die Geschäftsführer von SGFLD LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BALINSKA-JUNDZILL, Catherine ('Kasia') Marie Madeleine
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Sekretär
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    British65878370001
    DENT, Nicholas Michael
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomBritish43922780002
    FOWLER, Stephen Lethbridge
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    EnglandBritish135237620002
    THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED
    Leonard Street
    EC2A 4QS London
    83
    Bevollmächtigter Sekretär
    Leonard Street
    EC2A 4QS London
    83
    900013740001
    BISHOP, Julian Kenneth, Mr.
    Wrenfield
    The Chase
    KT22 0HR Oxshott
    Surrey
    Geschäftsführer
    Wrenfield
    The Chase
    KT22 0HR Oxshott
    Surrey
    EnglandBritish20351210002
    COOK, Stuart Donald
    c/o Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    Geschäftsführer
    c/o Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    United KingdomBritish191477240004
    COXON, David
    c/o Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    United Kingdom
    United KingdomBritish121539300001
    HASTINGS, Christopher Alan
    Flat 11 Haverley
    85-87 Worple Road
    SW19 4JH London
    Geschäftsführer
    Flat 11 Haverley
    85-87 Worple Road
    SW19 4JH London
    United KingdomBritish68475890001
    MEAGHER, Patrick Joseph
    Sacombs Ash
    Sacombs Lane, Allens Green
    CM21 0LU Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Sacombs Ash
    Sacombs Lane, Allens Green
    CM21 0LU Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    British62293450003
    MESNIL, Marc Rene
    7 Rue D' Odessa
    FOREIGN 75014 Paris
    France
    Geschäftsführer
    7 Rue D' Odessa
    FOREIGN 75014 Paris
    France
    France75589840001
    NIMMO, Mark Alexander
    c/o Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    Geschäftsführer
    c/o Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    EnglandBritish33420600001
    SHIELDS, Paul
    c/o Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    Geschäftsführer
    c/o Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    EnglandBritish244361960001
    SIDES, Lindsay Ginnette
    c/o Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    Geschäftsführer
    c/o Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    EnglandBritish212141970001
    TAYLOR, Paul Richard
    Saint Aidans
    70 Oak Hill Road
    TN13 1NT Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    Saint Aidans
    70 Oak Hill Road
    TN13 1NT Sevenoaks
    Kent
    British75085060001
    WILLIAMS, Gareth, Mr.
    c/o Group Legal
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o Group Legal
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg House
    United Kingdom
    United KingdomBritish120326750001
    LUCIENE JAMES LIMITED
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    900003210001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SGFLD LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Sg Leasing (March) Limited
    Sg House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    C/O Group Legal
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Sg House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    C/O Group Legal
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageEngland And Wales
    RegistrierungsortRegistrar Of Companies For England And Wales
    Registrierungsnummer00775046
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat SGFLD LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security agreement
    Erstellt am 31. Aug. 2012
    Geliefert am 13. Sept. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly known as sg leasing (september) limited or any assignee or transferee to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor shall pay discharge and perform the secured liabilities when they become due and for payment or discharge all the security created under the charge is created in favour of the sub-lessee is created over the assigned property is held as a continuing security for the payment dishcarge and performance of all the secured liabilities and is made with full title guarantee in accordance with the law of prroperty (miscellaneour provisions) ACT5 1994 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Sparkassen Leasing Ag & Co. Kg
    Transaktionen
    • 13. Sept. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 23. März 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of covenants
    Erstellt am 18. Dez. 2008
    Geliefert am 07. Jan. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the lessor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The vessel being the bulk carrier named cape saturn official number 390149, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • U-Ming Marine Transport (Hong Kong) Limited
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Dez. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of covenants
    Erstellt am 18. Dez. 2008
    Geliefert am 07. Jan. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the lessor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The vessel being the bulk carrier named cape mars official number 390148, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • U-Ming Marine Transport (Hong Kong) Limited
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Dez. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Lessor assignment and charge
    Erstellt am 18. Dez. 2008
    Geliefert am 07. Jan. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the lessor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights title and interest in the hull and war insurances and the requistion compensation in relation to the vessel cape saturn and the account moneys and the lessor proceeds accounts, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • U-Ming Marine Transport (Hong Kong) Limited
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Dez. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Lessor assignment and charge
    Erstellt am 18. Dez. 2008
    Geliefert am 07. Jan. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the lessor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights title and interest in the hull and war insurances and the requistion compensation in relation to the vessel cape mars and the account moneys and the lessor proceeds accounts, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • U-Ming Marine Transport (Hong Kong) Limited
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Dez. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Head lessor's post delivery assignment
    Erstellt am 01. Nov. 2002
    Geliefert am 22. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the assignor's rights title and interest and benefit (but without the burden of any obligation or duty) in and under the assignor's insurances.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cos Knight Shipping Inc,
    Transaktionen
    • 22. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Dez. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    First preferred ship mortgage in respect of M.V. "cos knight"
    Erstellt am 01. Nov. 2002
    Geliefert am 22. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The vessel registered in the ownership of the lessor under the laws and flag of the republic of panama with provisional patente de naveacion number 30680-pext and radio call letters hopm with the registration dimensions and tonnages. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cos Knight Shipping Inc.
    Transaktionen
    • 22. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Dez. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Head lessor's pre delivery assignment re;-hull no.1241 Dated 8TH january 2002 between the company (as assignor) and co's knight shipping inc.
    Erstellt am 08. Jan. 2002
    Geliefert am 21. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Following the sale of the vessel being a 52,270 dwt geared bulk carrier having hull no. 1241 at tsuneshi shipbuilding co.limited a percentage of the net sale proceeds pursuant to the timecharter by demise dated 26TH october 2001 between the company and chargee in respect of the vessel
    Kurze Angaben
    All the assignors rights title and interest and benefit in and to a). The shipsales contract b). Each refund guarantee c). The itochu guarantee. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cos.Knight Shipping Inc.
    Transaktionen
    • 21. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Jan. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Lessor account security deed
    Erstellt am 08. Jan. 2002
    Geliefert am 21. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities due from the company to the lessee pursuant to clauses 17-5, 27-3 and 27-5 of the lease agreement between the company and cos knight shipping inc. Dated 26TH october 2001 in accordance with the deed of proceeds and priorities dated 26TH october 2001
    Kurze Angaben
    All right title benefit and interest in and to the company in and to the proceeds account being the dollar account number 31001030 held with the london branch of societe generale and any sub-account thereof.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale Asia Limited
    Transaktionen
    • 21. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Dez. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat SGFLD LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    06. Aug. 2019Beginn der Liquidation
    03. Apr. 2020Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0