CONTENTFILM UK DISTRIBUTION LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CONTENTFILM UK DISTRIBUTION LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04102082 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CONTENTFILM UK DISTRIBUTION LIMITED?
- Verleih von Fernsehprogrammen (59133) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich CONTENTFILM UK DISTRIBUTION LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 151 Shaftesbury Avenue WC2H 8AL London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CONTENTFILM UK DISTRIBUTION LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| WINCHESTER FILM DISTRIBUTION LIMITED | 31. Okt. 2000 | 31. Okt. 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CONTENTFILM UK DISTRIBUTION LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CONTENTFILM UK DISTRIBUTION LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 041020820010, erstellt am 20. Jan. 2020 | 64 Seiten | MR01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 041020820009, erstellt am 31. Dez. 2019 | 20 Seiten | MR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Geoffrey Richard Webb als Geschäftsführer am 10. Dez. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Geoffrey Richard Webb als Sekretär am 10. Dez. 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Toby Mccathie als Geschäftsführer am 01. Nov. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Change of details for Content Media Corporation Worldwide Limited as a person with significant control on 19. Sept. 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 19-21 Heddon Street London W1B 4BG zum 151 Shaftesbury Avenue London WC2H 8AL am 22. Nov. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2018 bis 31. Dez. 2017 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Erick Kwak als Direktor am 26. Juni 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Reed Schmidt als Geschäftsführer am 26. Juni 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Toby Mccathie als Direktor am 26. Juni 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2019 bis 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2017 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 041020820008, erstellt am 28. Juli 2017 | 51 Seiten | MR01 | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 8 Seiten | MA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CONTENTFILM UK DISTRIBUTION LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWAK, Erick | Geschäftsführer | Heddon Street W1B 4BG London 19-21 Heddon Street England | United States | American | 250687840001 | |||||
| TAYLOR, Shawn Karl | Sekretär | Maple Lodge 12a Old Compton Lane GU9 8BS Farnham Surrey | British | 52001980004 | ||||||
| WEBB, Geoffrey Richard | Sekretär | Shaftesbury Avenue WC2H 8AL London 151 England | Australian | 96546010001 | ||||||
| WILKES, Jonathan Mark | Sekretär | 14 Zenobia Mansions Queens Club Gardens W14 9TD London | British | 83076550001 | ||||||
| EDEN SECRETARIES LIMITED | Sekretär | The Glassmill 1 Battersea Bridge Road SW11 3BG London | 54410910002 | |||||||
| GORNALL, Laurence | Geschäftsführer | 27 Lugard Road Peckham SE15 2TB London | United Kingdom | British | 107357560001 | |||||
| MCCATHIE, Toby | Geschäftsführer | Heddon Street W1B 4BG London 19-21 Heddon Street England | England | British | 250670180001 | |||||
| PAYNE, Rodney Edward James | Geschäftsführer | 38 Hale Lane Mill Hill NW7 3PR London | United Kingdom | British | 12727550001 | |||||
| SCHMIDT, John Reed | Geschäftsführer | 19-21 Heddon Street London W1B 4BG | United States | American | 97084530001 | |||||
| SMITH, Gary | Geschäftsführer | 10 Farquhar Road Edgbaston B15 3RB Birmingham West Midlands | England | British | 94244890001 | |||||
| SOUTHWORTH, Michael Denis | Geschäftsführer | Flat 1 5 St James Street SW1A 1ER London | British | 86487050001 | ||||||
| TAYLOR, Shawn Karl | Geschäftsführer | Maple Lodge 12a Old Compton Lane GU9 8BS Farnham Surrey | British | 52001980004 | ||||||
| WEBB, Geoffrey Richard | Geschäftsführer | Shaftesbury Avenue WC2H 8AL London 151 England | England | Australian | 156518590001 | |||||
| WILKES, Jonathan Mark | Geschäftsführer | 14 Zenobia Mansions Queens Club Gardens W14 9TD London | British | 83076550001 | ||||||
| GLASSMILL LIMITED | Geschäftsführer | The Glassmill 1 Battersea Bridge Road SW11 3BG London | 50180470008 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CONTENTFILM UK DISTRIBUTION LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kew Media Group Uk Holdings | 30. Okt. 2016 | Shaftesbury Avenue WC2H 8AL London 151 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat CONTENTFILM UK DISTRIBUTION LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 20. Jan. 2020 Geliefert am 22. Jan. 2020 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 31. Dez. 2019 Geliefert am 15. Jan. 2020 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 28. Juli 2017 Geliefert am 08. Aug. 2017 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 14. Juni 2013 Geliefert am 24. Juni 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 14. Juni 2013 Geliefert am 19. Juni 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Juli 2008 Geliefert am 30. Juli 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Juli 2005 Geliefert am 04. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of debenture | Erstellt am 26. März 2004 Geliefert am 06. Apr. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrowers to the chargee, the issuing bank or any lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First fixed charge all the tangible moveable property, all rights and claims to all monies to the credit of any bank accounts, all collection accounts, the intellectual property, all goodwill, all property rights, floating charge the undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 17. Dez. 2003 Geliefert am 23. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of fixed charge all intellectual property materials and derivative materials from time to time belonging to the company. The company rights and interest in and to monies from time to time standing to the credit of any collection account and the collateral from time to time belonging to the company. All of the company's right title interest and benefit in and to the film projects, the ancillary rights, the intellectual property rights and the contracts.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Dez. 2003 Geliefert am 23. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0