SUPERSTRIKE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSUPERSTRIKE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04105366
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SUPERSTRIKE LIMITED?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich SUPERSTRIKE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O VALENTINE & CO
    5 Stirling Court Yard Stirling Way
    WD6 2FX Borehamwood
    Hertfordshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SUPERSTRIKE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für SUPERSTRIKE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    12 SeitenLIQ13

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 2nd Floor Gadd House Arcadia Avenue London N3 2JU zum 5 Stirling Court Yard Stirling Way Borehamwood Hertfordshire WD6 2FX am 27. Feb. 2017

    2 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 2nd Floor Gadd House Arcadia Avenue London N3 2JU zum 2nd Floor Gadd House Arcadia Avenue London N3 2JU am 12. Okt. 2016

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 26. Sept. 2016

    LRESSP

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital30. Nov. 2015

    Kapitalaufstellung am 30. Nov. 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    5 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 13 Station Road Finchley London N3 2SB zum 2Nd Floor Gadd House Arcadia Avenue London N3 2JU am 30. Apr. 2015

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital19. Nov. 2014

    Kapitalaufstellung am 19. Nov. 2014

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Nov. 2013

    Kapitalaufstellung am 18. Nov. 2013

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    5 SeitenAA

    Ernennung von Mr Raid Musmar als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Walid Musmar als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Raid Musmar als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    6 SeitenAA

    legacy

    11 SeitenMG01

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    4 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Shelley Fields-Portelli als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von SUPERSTRIKE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MUSMAR, Raid
    Copenhagen Street
    N1 0XW London
    211
    England
    Geschäftsführer
    Copenhagen Street
    N1 0XW London
    211
    England
    EnglandBritish155821310002
    FELMAN, Bernard Jeffrey
    Little Manor
    34a The Avenue
    WD7 7DW Radlett
    Hertfordshire
    Sekretär
    Little Manor
    34a The Avenue
    WD7 7DW Radlett
    Hertfordshire
    British84055720001
    FIELDS-PORTELLI, Shelley
    Homefield Road
    WD23 3AP Bushey
    59
    Hertfordshire
    Sekretär
    Homefield Road
    WD23 3AP Bushey
    59
    Hertfordshire
    British122949490002
    MUSMAR, Walid Wasfi Wasif
    1 North End
    NW3 7HH London
    Sekretär
    1 North End
    NW3 7HH London
    British96650230001
    PREBBLE, Lance Edmund Knights
    14 Mount Grove
    HA8 9SX Edgware
    Middlesex
    Sekretär
    14 Mount Grove
    HA8 9SX Edgware
    Middlesex
    British75161340001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Sekretär
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    FIELDS, Antoni
    Ridings Lodge 15 Hedgerow Lane
    Arkley
    EN5 2DT Barnet
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Ridings Lodge 15 Hedgerow Lane
    Arkley
    EN5 2DT Barnet
    Hertfordshire
    EnglandBritish69727290003
    MUSMAR, Raid
    Royal Drive
    Friern Barnet
    N11 3FT London
    Flat 259 Princess Park Manor
    England
    Geschäftsführer
    Royal Drive
    Friern Barnet
    N11 3FT London
    Flat 259 Princess Park Manor
    England
    EnglandBritish155821310001
    MUSMAR, Walid Wasfi Wasif
    Park Drive
    NW11 7SP London
    22
    England
    Geschäftsführer
    Park Drive
    NW11 7SP London
    22
    England
    United Kingdom British 96650230005
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    Hat SUPERSTRIKE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 30. Jan. 2012
    Geliefert am 01. Feb. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Mortgage
    Erstellt am 31. Okt. 2008
    Geliefert am 05. Nov. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    61 balham high road london t/no 429829 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 10. März 2008
    Geliefert am 27. März 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    50A, 50-56 harleyford road london by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Sept. 2004
    Geliefert am 30. Sept. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Apartment 1A 11 quex road london. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Sept. 2004
    Geliefert am 30. Sept. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Apartment 1, 11 quex road london. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Sept. 2004
    Geliefert am 30. Sept. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Apartment 9A 9 quex road london. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Dez. 2003
    Geliefert am 30. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 61 balham high road in the l/b of wandsworth SW12 9AW t/no: 429829. together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 30. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. März 2002
    Geliefert am 30. März 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    136 archway road highgate london N6 5BH. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 30. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Nov. 2001
    Geliefert am 30. Nov. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee accordance with the mortgage conditions
    Kurze Angaben
    69 downhills park road london N17. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 30. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Nov. 2001
    Geliefert am 30. Nov. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies payable by the company to the chargee in accordance with the mortgage conditions and the performance by the company of all the company's other obligations under the mortgage
    Kurze Angaben
    The property known as 74 park lane london N17. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 30. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Okt. 2001
    Geliefert am 09. Nov. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £604,000.00 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property known as 61 balham high road london SW12 9AW. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Sept. 2001
    Geliefert am 12. Sept. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h properties being flats 1, 2 and 3 60-62 holloway road, london N7 as demised by three leases of even date made between crestpoly limited and superstrike limited. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Apr. 2001
    Geliefert am 01. Mai 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 33 westbere road london NW2 3SP. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 01. März 2001
    Geliefert am 14. März 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £1,300,000 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    170-174 albion road london. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. März 2001Registrierung einer Belastung (395)

    Hat SUPERSTRIKE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    26. Sept. 2016Beginn der Liquidation
    08. März 2018Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Mark Reynolds
    5 Stirling Court Stirling Way
    WD6 2FX Borehamwood
    Hertfordshire
    Praktiker
    5 Stirling Court Stirling Way
    WD6 2FX Borehamwood
    Hertfordshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0