HALLCO 1021 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHALLCO 1021 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04111742
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HALLCO 1021 LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich HALLCO 1021 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Eversley
    Gawsworth Road
    SK11 8UG Macclesfield
    Cheshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HALLCO 1021 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ROLAND BARDSLEY HOMES LIMITED13. Feb. 200113. Feb. 2001
    HALLCO 534 LIMITED21. Nov. 200021. Nov. 2000

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HALLCO 1021 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2019

    Welche sind die letzten Einreichungen für HALLCO 1021 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Okt. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    6 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Okt. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    5 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Okt. 2017 ohne Aktualisierungen

    2 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    8 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Okt. 2016 mit Aktualisierungen

    24 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    20 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital30. Dez. 2015

    Kapitalaufstellung am 30. Dez. 2015

    • Kapital: GBP 250,000
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    7 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom , 147 Broken Cross, Macclesfield, Cheshire, SK11 8TU zum Eversley Gawsworth Road Macclesfield Cheshire SK11 8UG am 08. Juli 2015

    2 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Okt. 2014

    14 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Nov. 2014

    Kapitalaufstellung am 10. Nov. 2014

    • Kapital: GBP 250,000
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 27. Nov. 2013

    14 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital02. Dez. 2013

    Kapitalaufstellung am 02. Dez. 2013

    • Kapital: GBP 250,000
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Nov. 2012

    14 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Claire Bardsley als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom , Globe Square, Dukinfield, Cheshire, SK16 4RG am 09. Okt. 2012

    2 SeitenAD01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    5 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Roland Bardsley als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von HALLCO 1021 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ALCOCK, John
    Deansgate
    M3 2QJ Manchester
    90
    Lancashire
    England
    Sekretär
    Deansgate
    M3 2QJ Manchester
    90
    Lancashire
    England
    British171499700001
    ALCOCK, John Herbert
    Deansgate
    M3 2QJ Manchester
    90
    Lancashire
    England
    Geschäftsführer
    Deansgate
    M3 2QJ Manchester
    90
    Lancashire
    England
    EnglandBritish45302690001
    BARDSLEY, Anne
    Deansgate
    M3 2QJ Manchester
    90
    Lancashire
    England
    Geschäftsführer
    Deansgate
    M3 2QJ Manchester
    90
    Lancashire
    England
    EnglandBritish171499490002
    MCCARREN, Lee Scott
    Chadwicks Close Farm
    Off Coal Pit Road Smithills
    BL1 7PB Bolton
    Lancashire
    Sekretär
    Chadwicks Close Farm
    Off Coal Pit Road Smithills
    BL1 7PB Bolton
    Lancashire
    British107908930001
    SHERRATT, Juanita Sandra
    66 Old Kiln Lane
    Grotton
    OL4 5RZ Oldham
    Greater Manchester
    Sekretär
    66 Old Kiln Lane
    Grotton
    OL4 5RZ Oldham
    Greater Manchester
    British75816200001
    HALLIWELLS SECRETARIES LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Bevollmächtigter Sekretär
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013280001
    ADAMS, Brian Kenneth
    16 Meadowbank Gardens
    WA3 5LX Glazebury
    Cheshire
    Geschäftsführer
    16 Meadowbank Gardens
    WA3 5LX Glazebury
    Cheshire
    British95853080001
    ASHWORTH, David James
    3 Hollybank Rise
    SK16 5EG Dukinfield
    Cheshire
    Geschäftsführer
    3 Hollybank Rise
    SK16 5EG Dukinfield
    Cheshire
    British75816270001
    BARDSLEY, Anne
    Cranbrook
    Oak Road Mottram
    SK10 4RA St Andrews
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Cranbrook
    Oak Road Mottram
    SK10 4RA St Andrews
    Cheshire
    EnglandBritish38204280002
    BARDSLEY, Claire Kelly
    Globe Lane
    SK16 4RG Dukinfield
    Globe Square
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Globe Lane
    SK16 4RG Dukinfield
    Globe Square
    Cheshire
    EnglandBritish141029570001
    BARDSLEY, Roland
    Middlewich Road
    Stanthorne
    CW10 9JD Middlewich
    Geschäftsführer
    Middlewich Road
    Stanthorne
    CW10 9JD Middlewich
    United KingdomBritish140518810002
    BARDSLEY, Roland
    Hill House Farm Singleton Road
    Weeton
    PR4 3JJ Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Hill House Farm Singleton Road
    Weeton
    PR4 3JJ Preston
    Lancashire
    British38204410001
    BARDSLEY, Sharon Anne
    Croft Cottage
    40 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Croft Cottage
    40 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    British113005600001
    BARDSLEY, Wayne Roland
    Middlewich Road
    Stanthorne
    CW10 9JD Middlewich
    Geschäftsführer
    Middlewich Road
    Stanthorne
    CW10 9JD Middlewich
    EnglandBritish125231330001
    HARPER, Paul
    4 Freshfield Road
    Heaton Mersey
    SK4 3HN Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    4 Freshfield Road
    Heaton Mersey
    SK4 3HN Stockport
    Cheshire
    British7152980001
    HOULIHAN, Colin Anthony
    Ednaston Grange
    Hollington Lane Ednaston
    DE6 3AE Brailsford Ashbourne
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Ednaston Grange
    Hollington Lane Ednaston
    DE6 3AE Brailsford Ashbourne
    Derbyshire
    EnglandBritish149560460001
    MACDOUGAL, Neil Charles
    The Garden House
    Off Chester Road, Tabley
    WA16 OHA Knutsford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Garden House
    Off Chester Road, Tabley
    WA16 OHA Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish93401120003
    MCCARREN, Lee Scott
    Chadwicks Close Farm
    Off Coal Pit Road Smithills
    BL1 7PB Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Chadwicks Close Farm
    Off Coal Pit Road Smithills
    BL1 7PB Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish107908930001
    MEARS, Helena Llewelyn
    September House
    38 Kingsley Road, Cottam
    PR4 0LT Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    September House
    38 Kingsley Road, Cottam
    PR4 0LT Preston
    Lancashire
    British121960240001
    PINDER, Ronald
    Fir Tree Cottage
    Lily Lanes
    OL6 9AD Ashton Under Lyne
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Fir Tree Cottage
    Lily Lanes
    OL6 9AD Ashton Under Lyne
    Lancashire
    British75816520001
    SPENCER, Keith
    2 The Paddock
    Greenfield
    OL3 7PU Oldham
    Lancashire
    Geschäftsführer
    2 The Paddock
    Greenfield
    OL3 7PU Oldham
    Lancashire
    British2715230001
    HALLIWELLS DIRECTORS LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013270001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HALLCO 1021 LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Gawsworth Road
    SK11 8UG Macclesfield
    Eversley
    Cheshire
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Gawsworth Road
    SK11 8UG Macclesfield
    Eversley
    Cheshire
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandUk
    RechtsgrundlageEngland And Wales
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer04111742
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat HALLCO 1021 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 06. Apr. 2004
    Geliefert am 10. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the south east side of ashworth street, bury, greater manchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. März 2004
    Geliefert am 24. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at new street/lord street eccleston chorley lancashire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Okt. 2003
    Geliefert am 08. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage chelford house offerton road offerton stockport t/no GM521542. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Mai 2003
    Geliefert am 30. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at high barn road royton greater manchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Apr. 2003
    Geliefert am 30. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at compstall road romiley greater manchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Feb. 2003
    Geliefert am 08. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage tahiti mill queens road ashton under lyne. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Feb. 2003
    Geliefert am 21. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at crompton way bolton. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Jan. 2003
    Geliefert am 22. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Cape mill shaw oldham t/n GM431352 (part) and GM426463 (part). By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Jan. 2003
    Geliefert am 15. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Okt. 2002
    Geliefert am 16. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a lodge mill ramsbottom described in a transfer dated 24/09/02 t/n LA873335 part and t/n LA775639 part. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Okt. 2002
    Geliefert am 16. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a the almonds hotel church lane marple t/n GM730810. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Okt. 2002
    Geliefert am 16. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The land at church road tarleton 87 church road and 5 gorse lane tarleton t/n LA885373 LA709879 and LA709919. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Okt. 2002
    Geliefert am 16. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a land on the east side of burnside hadfield glossop t/n DY340451. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Apr. 2002
    Geliefert am 12. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the property k/a land and dwelling house "the gerrards" stockport road hyde. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Apr. 2002
    Geliefert am 12. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 4 hough lane wilmslow t/no CH120763. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Apr. 2002
    Geliefert am 12. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a plots of land at springwood way limehurst ashton under lyne. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Okt. 2001
    Geliefert am 13. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a land at glenside drive woodley stockport greater manchester t/n GM177011. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 11. Okt. 2001
    Geliefert am 12. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 65 to 81 st petersgate stockport greater manchester t/no: GM216877. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 20. Juli 2001
    Geliefert am 26. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a stamford commercial mill claremont street hurst and part of land and buildings on the north side of crompton street ashton under lyne. T/nos LA144641 and part of GM757009. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 09. Apr. 2001
    Geliefert am 12. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a firstly land at 6 london road south poynton cheshire and secondly land adjoining t/n CH7328. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. März 2001
    Geliefert am 04. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a land at rankbottom hadfield - DY209035. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 15. März 2001
    Geliefert am 26. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over the company's estate or interest in any f/h or l/h property being part exchange properties for the time being belonging to or charged to the company other than the property hereinafter described.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 11. Dez. 2000
    Erworben am 02. März 2001
    Geliefert am 20. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All f/h and l/h property adjacent to hope street ramsbottom GM541578. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. März 2001Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 16. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Okt. 2000
    Erworben am 02. März 2001
    Geliefert am 20. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H land at clifton drive south lytham st annes lancashire LA783314. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. März 2001Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 16. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Okt. 2000
    Erworben am 02. März 2001
    Geliefert am 20. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H the ferns underwood road alderley edge cheshire CH265360 and CH168616. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. März 2001Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 16. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0