STRATOS SERVICES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSTRATOS SERVICES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04113443
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von STRATOS SERVICES LIMITED?

    • (6420) /

    Wo befindet sich STRATOS SERVICES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    99 City Road
    EC1Y 1AX London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von STRATOS SERVICES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für STRATOS SERVICES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    17 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 99 Gresham Street London EC2V 7NG am 12. März 2010

    2 SeitenAD01

    Ernennung von Alison Claire Horrocks als Sekretär

    3 SeitenAP03

    Ernennung von Alison Claire Horrocks als Direktor

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Richard Harris als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Richard Harris als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital24. Nov. 2009

    Kapitalaufstellung am 24. Nov. 2009

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Richard Harris am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Richard Harris am 01. Okt. 2009

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Maury Shenk am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Ian Alexander Canning am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    19 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    17 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    16 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Wer sind die Geschäftsführer von STRATOS SERVICES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HORROCKS, Alison Claire
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    Sekretär
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    British149532760001
    CANNING, Ian Alexander
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    Geschäftsführer
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    United KingdomBritish105522030004
    HORROCKS, Alison Claire
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    Geschäftsführer
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    EnglandBritish38922490004
    SHENK, Maury David
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    Geschäftsführer
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    United KingdomBritish153409550001
    BROUGH, Raymond Anthony
    Well House
    Wootton Drive, Petham
    CT4 5WD Canterbury
    Kent
    Sekretär
    Well House
    Wootton Drive, Petham
    CT4 5WD Canterbury
    Kent
    British75383590001
    FITZPATRICK, Paul
    32 Kingswood Drive
    Conception
    Bay South
    Newfouldland A1w 5mi
    Sekretär
    32 Kingswood Drive
    Conception
    Bay South
    Newfouldland A1w 5mi
    British85771850001
    HARRIS, Richard
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Sekretär
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    American117122620002
    HOLDEN, William
    107 Codroy Place
    St Johns
    Newfoundland
    A1e 4j2
    Canada
    Sekretär
    107 Codroy Place
    St Johns
    Newfoundland
    A1e 4j2
    Canada
    Canadian75104300001
    KUGELMAN, Paul Michael
    3802 Charles Street
    Alexandria
    IRISH Virginia
    22305
    Usa
    Sekretär
    3802 Charles Street
    Alexandria
    IRISH Virginia
    22305
    Usa
    British114468790001
    S & J REGISTRARS LIMITED
    99 Gresham Street
    EC2V 7NG London
    Sekretär
    99 Gresham Street
    EC2V 7NG London
    43122090005
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BENSON, Robert
    32 Winter Avenue
    St Johns
    A1A 1T3 Newfoundland
    Canada
    Geschäftsführer
    32 Winter Avenue
    St Johns
    A1A 1T3 Newfoundland
    Canada
    Canadian71185940001
    BROUGH, Raymond Anthony
    Well House
    Wootton Drive, Petham
    CT4 5WD Canterbury
    Kent
    Geschäftsführer
    Well House
    Wootton Drive, Petham
    CT4 5WD Canterbury
    Kent
    United KingdomBritish75383590001
    CIARDULLO, John Joseph
    29 Baccarat Crescent
    Brampton
    L7A 1K7 Ontario
    Canada
    Canada
    Geschäftsführer
    29 Baccarat Crescent
    Brampton
    L7A 1K7 Ontario
    Canada
    Canada
    Canadian73063580001
    HARRIS, Richard
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Geschäftsführer
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    UsaAmerican117122620002
    LLOYD, Carmen
    16508 Harbour Town Drive
    Silverspring
    Maryland 20905
    Usa
    Geschäftsführer
    16508 Harbour Town Drive
    Silverspring
    Maryland 20905
    Usa
    Canadian75441300001
    OAKE, David J
    11 Tracey Place
    St John's
    Nl
    A1a 4t1
    Canada
    Geschäftsführer
    11 Tracey Place
    St John's
    Nl
    A1a 4t1
    Canada
    Canadian92793820001
    PELTOLA, William Peltola
    48 Belsize Grove
    NW3 4TR London
    Geschäftsführer
    48 Belsize Grove
    NW3 4TR London
    American75805100001
    STURGE, Paula M
    5 Kensington Drive St Johns
    Newfoundland
    A1a 5a9
    Canada
    Geschäftsführer
    5 Kensington Drive St Johns
    Newfoundland
    A1a 5a9
    Canada
    Canadian74592610001
    WALMSLEY, Robert, Sir
    Pagan Solicitors
    12 St Catherine Street
    KY15 4HW Cupar
    Fife
    Geschäftsführer
    Pagan Solicitors
    12 St Catherine Street
    KY15 4HW Cupar
    Fife
    United KingdomBritish92095590003
    WOODS, Frank Derek
    750 Bay Street
    Suite 2307, Toronto
    M5G 1N6 Ontario
    Canada
    Canada
    Geschäftsführer
    750 Bay Street
    Suite 2307, Toronto
    M5G 1N6 Ontario
    Canada
    Canada
    Canadian73063530001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat STRATOS SERVICES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of confirmation
    Erstellt am 13. Feb. 2006
    Geliefert am 03. März 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the lenders or each of them and all monies due or to become due from the borrowers and any of them to the lenders and the chargee or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Canada Acting as Agent and as Security Trustee for Its Own Benefit as a Lenderand as Agent for the Lenders (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 03. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 03. Dez. 2004
    Geliefert am 11. Dez. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the lenders or each of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Canada Acting as Agent and as Security Trustee for Its Own Benefit as a Lenderand as Agent for the Lenders (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 05. Jan. 2001
    Geliefert am 20. Jan. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Canada (Acting as Agent for the Lenders and as Security Trustee for It's Ownbenefit as a Lender and as Agent for the Lenders)
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0