STRATOS GLOBAL HOLDINGS LIMITED

STRATOS GLOBAL HOLDINGS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSTRATOS GLOBAL HOLDINGS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04113448
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von STRATOS GLOBAL HOLDINGS LIMITED?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich STRATOS GLOBAL HOLDINGS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    99 City Road
    EC1Y 1AX London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von STRATOS GLOBAL HOLDINGS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für STRATOS GLOBAL HOLDINGS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für STRATOS GLOBAL HOLDINGS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Nov. 2015

    Kapitalaufstellung am 20. Nov. 2015

    • Kapital: GBP 29,900,011
    SH01

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    1 SeitenMR04

    Beendigung der Bestellung von Rich Harris als Geschäftsführer am 29. Mai 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. Dez. 2014

    Kapitalaufstellung am 23. Dez. 2014

    • Kapital: GBP 29,900,011
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    4 SeitenAA

    Ernennung von Mr Rupert Edward Pearce als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Rich Harris als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Jan. 2014

    Kapitalaufstellung am 10. Jan. 2014

    • Kapital: GBP 29,900,011
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Rick Medlock als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Rick Charles Medlock als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Ian Canning als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    4 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von STRATOS GLOBAL HOLDINGS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HORROCKS, Alison Claire
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    Sekretär
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    British149532020001
    HORROCKS, Alison Claire
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    Geschäftsführer
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    EnglandBritish38922490004
    PEARCE, Rupert Edward
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    Geschäftsführer
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    United KingdomBritish141426110001
    BROUGH, Raymond Anthony
    Well House
    Wootton Drive, Petham
    CT4 5WD Canterbury
    Kent
    Sekretär
    Well House
    Wootton Drive, Petham
    CT4 5WD Canterbury
    Kent
    British75383590001
    FITZPATRICK, Paul
    32 Kingswood Drive
    Conception
    Bay South
    Newfouldland A1w 5mi
    Sekretär
    32 Kingswood Drive
    Conception
    Bay South
    Newfouldland A1w 5mi
    British85771850001
    HARRIS, Richard
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Sekretär
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    American117122620002
    HOLDEN, William
    107 Codroy Place
    St Johns
    Newfoundland
    A1e 4j2
    Canada
    Sekretär
    107 Codroy Place
    St Johns
    Newfoundland
    A1e 4j2
    Canada
    Canadian75104300001
    KUGELMAN, Paul Michael
    3802 Charles Street
    Alexandria
    IRISH Virginia
    22305
    Usa
    Sekretär
    3802 Charles Street
    Alexandria
    IRISH Virginia
    22305
    Usa
    British114468790001
    S & J REGISTRARS LIMITED
    99 Gresham Street
    EC2V 7NG London
    Sekretär
    99 Gresham Street
    EC2V 7NG London
    43122090005
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BENSON, Robert
    32 Winter Avenue
    St Johns
    A1A 1T3 Newfoundland
    Canada
    Geschäftsführer
    32 Winter Avenue
    St Johns
    A1A 1T3 Newfoundland
    Canada
    Canadian71185940001
    BROUGH, Raymond Anthony
    Well House
    Wootton Drive, Petham
    CT4 5WD Canterbury
    Kent
    Geschäftsführer
    Well House
    Wootton Drive, Petham
    CT4 5WD Canterbury
    Kent
    United KingdomBritish75383590001
    CANNING, Ian Alexander
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    Geschäftsführer
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    United KingdomBritish105522030004
    CIARDULLO, John Joseph
    29 Baccarat Crescent
    Brampton
    L7A 1K7 Ontario
    Canada
    Canada
    Geschäftsführer
    29 Baccarat Crescent
    Brampton
    L7A 1K7 Ontario
    Canada
    Canada
    Canadian73063580001
    HARRIS, Rich
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    Geschäftsführer
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    EnglandAmerican184277130001
    HARRIS, Richard
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Geschäftsführer
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    UsaAmerican117122620002
    LLOYD, Carmen
    16508 Harbour Town Drive
    Silverspring
    Maryland 20905
    Usa
    Geschäftsführer
    16508 Harbour Town Drive
    Silverspring
    Maryland 20905
    Usa
    Canadian75441300001
    MEDLOCK, Rick Charles
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    Geschäftsführer
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    EnglandBritish181454030001
    OAKE, David J
    11 Tracey Place
    St John's
    Nl
    A1a 4t1
    Canada
    Geschäftsführer
    11 Tracey Place
    St John's
    Nl
    A1a 4t1
    Canada
    Canadian92793820001
    PELTOLA, William Peltola
    48 Belsize Grove
    NW3 4TR London
    Geschäftsführer
    48 Belsize Grove
    NW3 4TR London
    American75805100001
    SHENK, Maury David
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    Geschäftsführer
    City Road
    EC1Y 1AX London
    99
    United KingdomBritish153409550001
    STURGE, Paula M
    5 Kensington Drive St Johns
    Newfoundland
    A1a 5a9
    Canada
    Geschäftsführer
    5 Kensington Drive St Johns
    Newfoundland
    A1a 5a9
    Canada
    Canadian74592610001
    WALMSLEY, Robert, Sir
    Pagan Solicitors
    12 St Catherine Street
    KY15 4HW Cupar
    Fife
    Geschäftsführer
    Pagan Solicitors
    12 St Catherine Street
    KY15 4HW Cupar
    Fife
    United KingdomBritish92095590003
    WOODS, Frank Derek
    750 Bay Street
    Suite 2307, Toronto
    M5G 1N6 Ontario
    Canada
    Canada
    Geschäftsführer
    750 Bay Street
    Suite 2307, Toronto
    M5G 1N6 Ontario
    Canada
    Canada
    Canadian73063530001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat STRATOS GLOBAL HOLDINGS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of confirmation
    Erstellt am 13. Feb. 2006
    Geliefert am 03. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the lenders or each of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The securities and the derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Canada Acting as Agent and as Security Trustee for Its Own Benefit as a Lenderand as Agent for the Lenders (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 03. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of confirmation
    Erstellt am 13. Feb. 2006
    Geliefert am 03. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the lenders or each of them and all monies due or to become due from the borrowers and any of them to the lenders and the chargee or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Canada Acting as Agent and as Security Trustee for Its Own Benefit as a Lenderand as Agent for the Lenders (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 03. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge over shares
    Erstellt am 03. Dez. 2004
    Geliefert am 18. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrowers (or any of them) to the security trustee and to the lenders or each of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The charged property proceeds of sale or other realisation, the securities and derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Canada as Agent and Security Trustee for Its Own Benefit as a Lender and as Agentfor the Lenders (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Note pledge agreement
    Erstellt am 03. Dez. 2004
    Geliefert am 11. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the lender parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Notes means the promissory notes described in the schedule attached to from 395 and collateral means a security interest in the notes. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Canada (The Agent)
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Securities pledge agreement
    Erstellt am 03. Dez. 2004
    Geliefert am 11. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the lender parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The securities described in the schedule attached to form 395 being any cash dividends or other moneys. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Canada (The Agent)
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 03. Dez. 2004
    Geliefert am 11. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the lenders or each of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Canada Acting as Agent and as Security Trustee for Its Own Benefit as a Lenderand as Agent for the Lenders (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Note pledge agreement
    Erstellt am 05. Jan. 2001
    Geliefert am 24. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All debts liabilities and obligations of the company to the chargee (the agent) and the lenders pursuant to or in connection with the credit agreement and the other credit documents and all expenses costs and charges incurred in connection with the pledge the security interest or the realization of the collateral (all terms as defined)
    Kurze Angaben
    The note which means the two promissory notes dated january 5 2001 executed by stratos global limited and the collateral means a security interest in the notes together with all right title interest and benefit of the pldgor in and to the same. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Canada
    Transaktionen
    • 24. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Securities pledge agreement
    Erstellt am 05. Jan. 2001
    Geliefert am 20. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All debts, liabilities and obligations due or to become from the company to the chargee (as agent) and the lenders pursuant to or in connection with the guarantee; and the securities pledge agreement
    Kurze Angaben
    The securities as defined in the pledge.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Canada
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge over shares
    Erstellt am 05. Jan. 2001
    Geliefert am 20. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The payment and performance of all amounts owing under or pursuant to the guarantee and debenture as defined and all amounts owing under the charge from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All stocks shares warrants or other securities rights cash dividends inteerest or other property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Canada
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 05. Jan. 2001
    Geliefert am 20. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the debenture and the ontario law guarantee (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Canada Acting as Agent for the Lenders and as Security Trustee for Its Ownbenefit as a Lender and as Agent for the Lenders ("Security Trustee")
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0