GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED

GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04113718
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Avant House 6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    EARTHBOX LIMITED24. Nov. 200024. Nov. 2000

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 22. Dez. 2015

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Reduce share prem a/c 13/10/2015
    RES13

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2015 bis 30. Apr. 2016

    1 SeitenAA01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Colin Edward Lewis am 22. Okt. 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Jonathan Ross Brodie am 22. Okt. 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Giles Henry Sharp am 22. Okt. 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Joanne Elizabeth Massey am 22. Okt. 2015

    1 SeitenCH03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 30 High Street Westerham Kent TN16 1RG zum Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP am 23. Okt. 2015

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    6 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Jon William Mortimore als Geschäftsführer am 31. März 2015

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Giles Sharp als Direktor am 23. Jan. 2015

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Neil Fitzsimmons als Geschäftsführer am 12. Dez. 2014

    1 SeitenTM01

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    4 SeitenMR04

    Änderung der Details des Sekretärs für Joanne Elizabeth Massey am 15. Dez. 2014

    1 SeitenCH03

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital24. Nov. 2014

    Kapitalaufstellung am 24. Nov. 2014

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital25. Nov. 2013

    Kapitalaufstellung am 25. Nov. 2013

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Sekretär
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    147808010001
    BRODIE, Jonathan Ross
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    EnglandBritish62279790001
    LEWIS, Colin Edward
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    WalesWelsh59395180001
    SHARP, Giles Henry
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    United KingdomBritish194659450001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Sekretär
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Sekretär
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    1 Martlesham
    AL7 2QF Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Sekretär
    1 Martlesham
    AL7 2QF Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British72249480001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BRODIE, Jonathan Ross
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    Geschäftsführer
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    EnglandBritish62279790001
    BROWN, Carole Elizabeth
    11 Yelvertoft Road
    Crick
    NN6 7TR Northampton
    Barn 1
    England
    England
    Geschäftsführer
    11 Yelvertoft Road
    Crick
    NN6 7TR Northampton
    Barn 1
    England
    England
    EnglandBritish98235420004
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish154997530001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British78691990001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050003
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritish1898090001
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    KIRKPATRICK, James Mclellan
    Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    35
    Lanarkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    35
    Lanarkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish102797820001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Geschäftsführer
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    British3079600001
    MORTIMORE, Jon William
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish207729000002
    YARDLEY, Norman
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish153904770001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Standard security
    Erstellt am 11. Sept. 2009
    Geliefert am 24. Sept. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due of each residential obligor to any residential secured party and from each commercial obligor to any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects k/a and forming 159 ingram street glasgow and 97, 99, 99, an 101 hutcheson street glasgow, t/no.GLA143786 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transaktionen
    • 24. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Standard security
    Erstellt am 11. Sept. 2009
    Geliefert am 24. Sept. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due of each residential obligor to any residential secured party and from each commercial obligor to any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects k/a and forming 163-167 ingram street glasgow being the basement ground and first floor premises, t/no.GLA115087 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transaktionen
    • 24. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Sept. 2009
    • 18. Feb. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security agreement
    Erstellt am 01. Sept. 2009
    Geliefert am 14. Sept. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor and each commercial obligor to any residential secured party and any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 14. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2012Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A bond and floating charge
    Erstellt am 01. Sept. 2009
    Geliefert am 14. Sept. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each residential obligor and each commercial obligor to any residential secured party and any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The charged assets see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transaktionen
    • 14. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 30. Dez. 2008
    Geliefert am 09. Jan. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Dez. 2006
    Geliefert am 03. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The f/h property being 190 to 196 (even numbers) and 198A kennington park road, kennington t/n SGL90575.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Dez. 2006
    Geliefert am 03. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a crown and sceptre house, bridge street, hitchin t/n HD236815.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 29. März 2004
    Geliefert am 02. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property being land on the east side of reading road streatley t/n BK10836, land and buildings on the south side of high street streatley t/n BK10837, streatley house high street streatley t/n BK9117 for further details of the property charged please refer to the form 395. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A standard security which was presented in scotland for registration on 27 january 2004 and
    Erstellt am 22. Jan. 2004
    Geliefert am 04. Feb. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    (First) all and whole the subjects at 159 ingram street glasgow and 97, 99 and 101 hutcheson street glasgow t/n GLA143786 and (second) all and whole the subjects known as 163 to 167 ingram street glasgow t/n GLA115087.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Sept. 2003
    Geliefert am 15. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a new streets of london public house east moseley london t/n SY706112. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Nov. 2002
    Geliefert am 23. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a greennside mills wakefield road dalton huddersfield and land and buildings lying to the south of wakefield road kirklees and land on the south side of wakefield road dalton huddersfield t/n WYK647046, WYK130371, and WYK656479. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 18. Nov. 2002
    Geliefert am 23. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0