GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04113718 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Avant House 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| EARTHBOX LIMITED | 24. Nov. 2000 | 24. Nov. 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 22. Dez. 2015
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2015 bis 30. Apr. 2016 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Colin Edward Lewis am 22. Okt. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Jonathan Ross Brodie am 22. Okt. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Giles Henry Sharp am 22. Okt. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Joanne Elizabeth Massey am 22. Okt. 2015 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 30 High Street Westerham Kent TN16 1RG zum Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP am 23. Okt. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jon William Mortimore als Geschäftsführer am 31. März 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Giles Sharp als Direktor am 23. Jan. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Fitzsimmons als Geschäftsführer am 12. Dez. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 10 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Joanne Elizabeth Massey am 15. Dez. 2014 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY, Joanne Elizabeth | Sekretär | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | 147808010001 | |||||||
| BRODIE, Jonathan Ross | Geschäftsführer | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | England | British | 62279790001 | |||||
| LEWIS, Colin Edward | Geschäftsführer | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | Wales | Welsh | 59395180001 | |||||
| SHARP, Giles Henry | Geschäftsführer | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | United Kingdom | British | 194659450001 | |||||
| GANDHI, Devendra | Sekretär | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | British | 75350600002 | ||||||
| JOHNSON, Robin Simon | Sekretär | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | British | 11498320001 | ||||||
| SCUDAMORE, Rebecca Jane | Sekretär | 1 Martlesham AL7 2QF Welwyn Garden City Hertfordshire | British | 72249480001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BRODIE, Jonathan Ross | Geschäftsführer | Barn Cottage Moon Lane Dormansland RH7 6PD Lingfield Surrey | England | British | 62279790001 | |||||
| BROWN, Carole Elizabeth | Geschäftsführer | 11 Yelvertoft Road Crick NN6 7TR Northampton Barn 1 England England | England | British | 98235420004 | |||||
| CATCHPOLE, Elizabeth Margaret | Geschäftsführer | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent United Kingdom | England | British | 154997530001 | |||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Geschäftsführer | Langkawi 2 Ashlea Road SL9 8NY Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | 78691990001 | ||||||
| DIPRE, John Vivian | Geschäftsführer | The Warren KT21 2SE Ashtead Hollybank Surrey | United Kingdom | British | 9018280015 | |||||
| DIPRE, Remo | Geschäftsführer | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | 35117250001 | |||||
| FITZSIMMONS, Neil | Geschäftsführer | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 69006050003 | |||||
| FORSHAW, Christopher Michael John | Geschäftsführer | 44 Kerris Way Lower Earley RG6 5UW Reading Berkshire | England | British | 1898090001 | |||||
| GAFFNEY, David | Geschäftsführer | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Scotland | British | 84605410002 | |||||
| GANDHI, Devendra | Geschäftsführer | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | England | British | 75350600002 | |||||
| KIRKPATRICK, James Mclellan | Geschäftsführer | Cardowan Road Stepps G33 6HJ Glasgow 35 Lanarkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 102797820001 | |||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Geschäftsführer | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| METLISS, Cyril | Geschäftsführer | 25 Foscote Road Hendon NW4 3SE London | British | 3079600001 | ||||||
| MORTIMORE, Jon William | Geschäftsführer | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent United Kingdom | United Kingdom | British | 207729000002 | |||||
| YARDLEY, Norman | Geschäftsführer | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 153904770001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Hat GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Erstellt am 11. Sept. 2009 Geliefert am 24. Sept. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due of each residential obligor to any residential secured party and from each commercial obligor to any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the subjects k/a and forming 159 ingram street glasgow and 97, 99, 99, an 101 hutcheson street glasgow, t/no.GLA143786 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 11. Sept. 2009 Geliefert am 24. Sept. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due of each residential obligor to any residential secured party and from each commercial obligor to any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the subjects k/a and forming 163-167 ingram street glasgow being the basement ground and first floor premises, t/no.GLA115087 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 01. Sept. 2009 Geliefert am 14. Sept. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor and each commercial obligor to any residential secured party and any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A bond and floating charge | Erstellt am 01. Sept. 2009 Geliefert am 14. Sept. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each residential obligor and each commercial obligor to any residential secured party and any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The charged assets see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Dez. 2008 Geliefert am 09. Jan. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Dez. 2006 Geliefert am 03. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The f/h property being 190 to 196 (even numbers) and 198A kennington park road, kennington t/n SGL90575. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Dez. 2006 Geliefert am 03. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The f/h property k/a crown and sceptre house, bridge street, hitchin t/n HD236815. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. März 2004 Geliefert am 02. Apr. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The freehold property being land on the east side of reading road streatley t/n BK10836, land and buildings on the south side of high street streatley t/n BK10837, streatley house high street streatley t/n BK9117 for further details of the property charged please refer to the form 395. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented in scotland for registration on 27 january 2004 and | Erstellt am 22. Jan. 2004 Geliefert am 04. Feb. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben (First) all and whole the subjects at 159 ingram street glasgow and 97, 99 and 101 hutcheson street glasgow t/n GLA143786 and (second) all and whole the subjects known as 163 to 167 ingram street glasgow t/n GLA115087. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 26. Sept. 2003 Geliefert am 15. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a new streets of london public house east moseley london t/n SY706112. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Nov. 2002 Geliefert am 23. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a greennside mills wakefield road dalton huddersfield and land and buildings lying to the south of wakefield road kirklees and land on the south side of wakefield road dalton huddersfield t/n WYK647046, WYK130371, and WYK656479. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Nov. 2002 Geliefert am 23. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0