BOWERCRAFT LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBOWERCRAFT LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04114062
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BOWERCRAFT LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich BOWERCRAFT LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    843 Finchley Road
    NW11 8NA London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BOWERCRAFT LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für BOWERCRAFT LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für BOWERCRAFT LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Clive Portlock am 08. Juni 2015

    2 SeitenCH01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Clive Portlock am 13. März 2015

    2 SeitenCH01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Dez. 2014 bis 29. Dez. 2014

    1 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Aug. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. Aug. 2014

    Kapitalaufstellung am 08. Aug. 2014

    • Kapital: GBP 76
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    8 SeitenAA

    Änderung der Details des Sekretärs für Network Secretarial Services Limited am 04. Nov. 2013

    2 SeitenCH04

    Änderung der Details des Sekretärs für Network Secretarial Service Limited am 23. Okt. 2013

    1 SeitenCH04

    Änderung der Details des Sekretärs für Network Secretarial Service Limited am 22. Okt. 2013

    2 SeitenCH04

    Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Clive Portlock am 22. Okt. 2013

    2 SeitenCH01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2012 bis 30. Dez. 2012

    1 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital13. Aug. 2013

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 13. Aug. 2013

    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Andrew Clive Portlock am 01. Aug. 2013

    2 SeitenCH01

    Beendigung der Bestellung von Hendon Directors Ltd als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Ann Wiggins als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Andrew Clive Portlock als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Network Secretarial Service Limited als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Network Secretarial Service Limited als Sekretär

    2 SeitenAP04

    Ernennung von Network Secretarial Service Limited als Direktor

    2 SeitenAP02

    Beendigung der Bestellung von Jennifer Thornley als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Jennifer Thornley als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Wer sind die Geschäftsführer von BOWERCRAFT LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    NETWORK SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Byfleets Lane
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    The Old Applestore Field Place Estate
    West Sussex
    United Kingdom
    Sekretär
    Byfleets Lane
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    The Old Applestore Field Place Estate
    West Sussex
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer03277809
    50353670001
    PORTLOCK, Andrew Clive
    16 Garrick Street
    WC2E 9BA London
    3rd Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    16 Garrick Street
    WC2E 9BA London
    3rd Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish47417880004
    BENNISON, Peter
    3 Priory Terrace
    West Hampstead
    NW6 4DG London
    Sekretär
    3 Priory Terrace
    West Hampstead
    NW6 4DG London
    British88640070001
    BOWERS, Ann
    17 Diban Avenue
    RM12 4YE Hornchurch
    Essex
    Sekretär
    17 Diban Avenue
    RM12 4YE Hornchurch
    Essex
    British91640050001
    HAYWARD, Malcolm
    39 Selby Road
    W5 1LY Ealing
    Sekretär
    39 Selby Road
    W5 1LY Ealing
    British77388580004
    KINGSTON, Darren Howard
    17 Hollywood Court
    Deacons Hill
    WD6 3HU Elstree
    Hertfordshire
    Sekretär
    17 Hollywood Court
    Deacons Hill
    WD6 3HU Elstree
    Hertfordshire
    British73808770001
    THORNLEY, Jennifer
    57 Footscray Road
    Eltham
    SE9 2ST London
    Flat 2
    United Kingdom
    Sekretär
    57 Footscray Road
    Eltham
    SE9 2ST London
    Flat 2
    United Kingdom
    British170522870001
    WIGGINS, Ann
    Carling Close
    LE67 4EP Coalville
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Sekretär
    Carling Close
    LE67 4EP Coalville
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    British158846290002
    L & A SECRETARIAL LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Bevollmächtigter Sekretär
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001450001
    PRIORY SECRETARIAL LIMITED
    1st Floor Centre Heights
    137 Finchley Road
    NW3 6JG London
    Sekretär
    1st Floor Centre Heights
    137 Finchley Road
    NW3 6JG London
    109086400002
    BENNISON, Peter James
    5 Ashley Close
    NW4 1PH London
    Geschäftsführer
    5 Ashley Close
    NW4 1PH London
    EnglandBritish88640070003
    BENNISON, Peter
    3 Priory Terrace
    West Hampstead
    NW6 4DG London
    Geschäftsführer
    3 Priory Terrace
    West Hampstead
    NW6 4DG London
    British88640070001
    BROWN, Laurence Jeffrey
    Flat 17 Hollywood Court
    Deacons Hill Road, Elstree
    WD6 3HU Borehamwood
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Flat 17 Hollywood Court
    Deacons Hill Road, Elstree
    WD6 3HU Borehamwood
    Hertfordshire
    British65468260002
    BROWN, Laurence Jeffrey
    Flat 17 Hollywood Court
    Deacons Hill Road, Elstree
    WD6 3HU Borehamwood
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Flat 17 Hollywood Court
    Deacons Hill Road, Elstree
    WD6 3HU Borehamwood
    Hertfordshire
    British65468260002
    CHILDS, Patrick John
    17 Lancaster Mews
    W2 0NA London
    Geschäftsführer
    17 Lancaster Mews
    W2 0NA London
    British73808700001
    THORNLEY, Jennifer Catherine
    57 Footscray Road
    Eltham
    SE9 2ST London
    Flat 2
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    57 Footscray Road
    Eltham
    SE9 2ST London
    Flat 2
    United Kingdom
    UkBritish170523770001
    WATSON, Peter
    Aptdo 260 Baranita
    07850 Santcarles
    Ibiza
    Spain
    Geschäftsführer
    Aptdo 260 Baranita
    07850 Santcarles
    Ibiza
    Spain
    British76765940001
    WIGGINS, Ann
    Carling Close
    LE67 4EP Coalville
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Carling Close
    LE67 4EP Coalville
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    British91640050002
    WILKINSON, Alexandra
    47 Union Central Building
    78 Kingsland Road
    E2 8DP London
    Geschäftsführer
    47 Union Central Building
    78 Kingsland Road
    E2 8DP London
    British83939530001
    HENDON DIRECTORS LTD
    1st Floor Centre Heights
    137 Finchley Road
    NW3 6JG London
    Geschäftsführer
    1st Floor Centre Heights
    137 Finchley Road
    NW3 6JG London
    118922900002
    L & A REGISTRARS LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001440001
    NETWORK SECRETARIAL SERVICE LIMITED
    RH12 3PB Broadbridge Heath
    Field Place
    West Sussex
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    RH12 3PB Broadbridge Heath
    Field Place
    West Sussex
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer03277809
    177393510001
    PRIORY DIRECTORS LTD
    1st Floor Centre Heights
    137 Finchley Road
    NW3 6JG London
    Geschäftsführer
    1st Floor Centre Heights
    137 Finchley Road
    NW3 6JG London
    111151710002

    Hat BOWERCRAFT LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 19. Okt. 2012
    Geliefert am 25. Okt. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of its group members on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property being 53-61 tabernacle street and 32-36 (even) leonard street, london t/no NGL777301 by way of fixed charge the benefit of all agreements relating to the property, the rights under the apportionment of any managing agent, all rights title and interest in all contracts or policies of insurances, the benefit of all authorisations consents approvals resolutions, rights title and interest in and to the rental income. Assigns all rights title and interest both in rental income and all other rights.
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Aug. 2012
    Geliefert am 03. Sept. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property being 53-61 tabernacle street and 32-36 (even) leonard street london t/no.NGL777301 by way of fixed charge the benefit of all agreements relating to the property, the rights under the appointment of any managing agent, all rights title and interest in all insurances.
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC
    Transaktionen
    • 03. Sept. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture legal and equitable charge
    Erstellt am 10. Nov. 2008
    Geliefert am 13. Nov. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £180,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Priory Funding Limited
    Transaktionen
    • 13. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture legal and equitable charge
    Erstellt am 29. Okt. 2008
    Geliefert am 31. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £180,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    A floating charge over all the assets and undertaking whatsoever of the company (including uncalled capital). Several fixed charges over assets.
    Berechtigte Personen
    • Property Funding Limited
    Transaktionen
    • 31. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture and charge
    Erstellt am 21. Dez. 2007
    Geliefert am 11. Jan. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £330,750.00 and all other monies due or to become due
    Kurze Angaben
    A floating charge over all its assets and undertaking (including uncalled capital). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • London Property Holdings PLC
    Transaktionen
    • 11. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture legal and equitable charge
    Erstellt am 25. Apr. 2007
    Geliefert am 04. Mai 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge over 51-61 tabernacle street and 32-36 leonard street, london t/n ngl 777301 and the harrow harvester public house, leatherhead road, chessington, surrey t/n SGL68111 and any other f/h or l/h property and equitable charges on other assets.
    Berechtigte Personen
    • Dedicated Recoveries Limited
    Transaktionen
    • 04. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture (floating charge)
    Erstellt am 18. Okt. 2005
    Geliefert am 20. Okt. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    With full title guarantee charges by way of first floating charge all property and assets both present and future and from time to time owned by the company or in which the company may have an interest.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Okt. 2005
    Geliefert am 20. Okt. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 53 to 61 (odd) tabernacle street london t/no NGL777301. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Juni 2005
    Geliefert am 14. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the harrow public house, leatherhead road, chessington, kingston upon thames t/no. SGL68111. Fixed charge all buildings and other structures on, and items fixed to the property and any goodwill realting to the property or the business or undertaking conducted at the property.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Caroline Lesley Naylor
    Transaktionen
    • 14. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge of licensed premises
    Erstellt am 24. März 2005
    Geliefert am 13. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The harrow public house, leatherhead road, chessington, surrey by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. The benefit of all justices excise or other licences or registration certificates held from time to time in connection with the business carried on at the property and the right to recover and receive any compensation payable at any time on accoaccount of the non-renewal of such licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge of licensed premises
    Erstellt am 13. Aug. 2004
    Geliefert am 19. Aug. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    43-61 (odd) tabernacle street and 32-36 (even) leonard street islington by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. The benefit of all justices excise or other licences or registration certificates held from time to time in connection with the business carried on at the property and the right to recover and receive any compensation payable at any time on account of the non-renewal of such licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 13. Aug. 2004
    Geliefert am 17. Aug. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Juli 2002
    Geliefert am 16. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H properties being 43-61 (odd numbers) tabernacle street and 32 to 36 (even numbers) leonard street london EC1 t/no NGL777301.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 16. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. Apr. 2002
    Geliefert am 16. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 16. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Aug. 2001
    Geliefert am 24. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to an agreement of even date
    Kurze Angaben
    Freehold property k/a 43-61 tabernacle street and 32-36 leonard street london EC1 t/n NGL777301.
    Berechtigte Personen
    • Lamdale Trading Limited
    Transaktionen
    • 24. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. Juli 2001
    Geliefert am 18. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold property k/a 53-61 tabernacle street london (odd numbers) and 32-36 leonard street london (even numbers) t/n NGL777301. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0