D.U.K.E. & KENT ESTATES LIMITED

D.U.K.E. & KENT ESTATES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameD.U.K.E. & KENT ESTATES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04114371
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von D.U.K.E. & KENT ESTATES LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich D.U.K.E. & KENT ESTATES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von D.U.K.E. & KENT ESTATES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    VALAD & BENCHMARK ESTATES LIMITED28. Sept. 200728. Sept. 2007
    SCARBOROUGH & BENCHMARK ESTATES LIMITED05. Aug. 200405. Aug. 2004
    TEESPIN DEVELOPMENTS LIMITED21. Nov. 200021. Nov. 2000

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von D.U.K.E. & KENT ESTATES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für D.U.K.E. & KENT ESTATES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA
    R99PSF0Q

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA
    R99PSEKZ

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    12 SeitenLIQ13
    A8FTUOMB

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600
    A7XQ3XPV

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 1st Floor Unit 16 Manor Court Business Park Scarborough YO11 3TU zum The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG am 25. Jan. 2019

    2 SeitenAD01
    A7WSW17U

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01
    A7WSW17E

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 07. Jan. 2019

    LRESSP

    Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juni 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01
    X78XYIHK

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2017

    24 SeitenAA
    A72RV4CB

    Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juni 2017 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01
    X6935KE3

    Änderung der Details des Direktors für Valsec Director Limited am 24. Feb. 2017

    1 SeitenCH02
    X61AXKOP

    Änderung der Details des Sekretärs für Valad Secretarial Services Limited am 24. Feb. 2017

    1 SeitenCH04
    X61AWFMP

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2016

    22 SeitenAA
    A60H8YC3

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Jan. 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01
    X5XVK28P

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Jan. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01
    X5XIJGZL

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    2 SeitenMR04
    X5M7XQXJ

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    2 SeitenMR04
    X5M7XRGY

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    1 SeitenMR04
    X5M7XQJD

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    2 SeitenMR04
    X5M7XS96

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    1 SeitenMR04
    X5M5CNXL

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    2 SeitenMR04
    X5M5CQ88

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    2 SeitenMR04
    X5M5CQMY

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    2 SeitenMR04
    X5M5CQ3K

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    2 SeitenMR04
    X5M5CQ54

    Wer sind die Geschäftsführer von D.U.K.E. & KENT ESTATES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CROMWELL CORPORATE SECRETARIAL LIMITED
    Exchange Place 3
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor
    United Kingdom
    Sekretär
    Exchange Place 3
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    RegistrierungsnummerSC219311
    133355520004
    MADDY, James Edward
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Acoountant137459000002
    CROMWELL DIRECTOR LIMITED
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer5307786
    102622300003
    BROOK, Susan Margaret
    16 Bradley Lane
    Rufforth
    YO23 3QJ York
    North Yorkshire
    Sekretär
    16 Bradley Lane
    Rufforth
    YO23 3QJ York
    North Yorkshire
    British72328070001
    RICHARDSON, Paul
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    Sekretär
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    British60649820001
    DWS SECRETARIES LIMITED
    5 Chancery Lane
    WC2A 1LF London
    Bevollmächtigter Sekretär
    5 Chancery Lane
    WC2A 1LF London
    900020220001
    HAWKINS, John
    1 Central Avenue
    ME10 4AE Sittingbourne
    Bank Chambers
    Kent
    Geschäftsführer
    1 Central Avenue
    ME10 4AE Sittingbourne
    Bank Chambers
    Kent
    United KingdomBritishChartered Surveyor95431870001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishFinancial Controller56953000002
    RICHARDSON, Paul
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    BritishFinancial Controller60649820001
    TANDY, Didier Michel
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    West Yorkshire
    EnglandBritishChartered Surveyor69909950001
    DWS DIRECTORS LIMITED
    5 Chancery Lane
    WC2A 1LF London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    5 Chancery Lane
    WC2A 1LF London
    900020210001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei D.U.K.E. & KENT ESTATES LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Philip Lawrence Turpin
    Castle Street
    St Helier
    JE4 5UT Jersey
    13
    Jersey
    08. Jan. 2017
    Castle Street
    St Helier
    JE4 5UT Jersey
    13
    Jersey
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: Jersey
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.
    Mr Robin Baird
    Castle Street
    St Helier
    JE4 5UT Jersey
    13
    Jersey
    08. Jan. 2017
    Castle Street
    St Helier
    JE4 5UT Jersey
    13
    Jersey
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: Jersey
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.
    D.U.K.E. Development Group (Uk) Limited
    Manor Court Business Park
    Eastfield
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor, Unit 16
    England
    06. Apr. 2016
    Manor Court Business Park
    Eastfield
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor, Unit 16
    England
    Ja
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandUk
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortEngland And Wales
    Registrierungsnummer4045874
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für D.U.K.E. & KENT ESTATES LIMITED?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    07. Jan. 201708. Jan. 2017Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt.

    Hat D.U.K.E. & KENT ESTATES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental legal mortgage
    Erstellt am 27. Apr. 2012
    Geliefert am 03. Mai 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a link park lympne hythe t/no K938947 together with all buildings fixtures and fixed pant and machinery at any time thereon see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transaktionen
    • 03. Mai 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 19. Dez. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 22. März 2012
    Geliefert am 30. März 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land adjoining javelin house javelin way ashford t/no K967450 land lying to the south wast of ashford by-pass ashford t/no K282865 unit 7 henwood industrial estate ashford t/no K475948 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery (for further details of the properties charged please refer to the form MG01) see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transaktionen
    • 30. März 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 19. Dez. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of accession and charge
    Erstellt am 11. März 2011
    Geliefert am 25. März 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of its rights title and interest from time to time in respect of any sums payable to it pursuant to any insurance policies,any hedging agreement,all land in england and wales see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 25. März 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 19. Dez. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 27. März 2008
    Geliefert am 09. Apr. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as land at link park hythe kent t/NK704464 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Apr. 2008
    • 19. Dez. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Okt. 2005
    Geliefert am 02. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property known as land lying to the south west of ashford by pass ashford t/n K282865,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Dez. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Okt. 2005
    Geliefert am 02. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property known as 73 college road and land at the back of 71 college road maidstone t/n K556795 and K475948,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Dez. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Okt. 2005
    Geliefert am 02. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property known as 20/20 business centre liphook way allington maidstone t/n K653051,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Dez. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 2005
    Geliefert am 11. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a phase 5 lordswood industrial estate gleaming wood drive chatham. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Dez. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Juli 2004
    Geliefert am 09. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property unit 7 henwood industrial estate ashford t/n K432203. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Dez. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 11. Apr. 2002
    Geliefert am 18. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land on boxley road maidstone kent t/n K769425. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Dez. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 29. Jan. 2002
    Geliefert am 02. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land on the west side of the B2068 road on the north side of the M20 at junction 11 shepway kent t/n K676495. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Dez. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 23. Feb. 2001
    Geliefert am 28. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 28. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Dez. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat D.U.K.E. & KENT ESTATES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    07. Jan. 2019Beginn der Liquidation
    16. Jan. 2020Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Paul David Williams
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Praktiker
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Geoffrey Wayne Bouchier
    The Shard,32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Praktiker
    The Shard,32 London Bridge Street
    SE1 9SG London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0