KNOLLYS HOUSE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | KNOLLYS HOUSE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04126088 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von KNOLLYS HOUSE LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
- Vermietung und Verpachtung von Immobilien von Wohnungsbaugesellschaften (68201) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich KNOLLYS HOUSE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 100 Victoria Street SW1E 5JL London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von KNOLLYS HOUSE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SHELFCO (NO.2053) LIMITED | 15. Dez. 2000 | 15. Dez. 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KNOLLYS HOUSE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für KNOLLYS HOUSE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Louise Miller als Geschäftsführer am 01. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Elizabeth Miles als Direktor am 01. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ls Director Limited am 28. Juni 2017 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Ls Nominees Holdings Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Arnaouti als Geschäftsführer am 31. März 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Louise Miller als Direktor am 01. März 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Michael Arnaouti am 16. Jan. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ls Director Limited am 10. Jan. 2017 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Ls Company Secretaries Limited am 10. Jan. 2017 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Land Securities Management Services Limited am 10. Jan. 2017 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 5 Strand London WC2N 5AF zum 100 Victoria Street London SW1E 5JL am 10. Jan. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Marshall Gill als Geschäftsführer am 14. Juli 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Michael Arnaouti als Direktor am 01. Juli 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von KNOLLYS HOUSE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS COMPANY SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom |
| 159674790001 | ||||||||||
| MILES, Elizabeth | Geschäftsführer | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | United Kingdom | British | 235498150001 | |||||||||
| LAND SECURITIES MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom |
| 74974580001 | ||||||||||
| LS DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom |
| 133814600001 | ||||||||||
| CONWAY HUGHES, Christopher John | Sekretär | 18 Mansel Road Wimbledon SW19 4AA London | British | 4560800002 | ||||||||||
| DUDGEON, Peter Maxwell | Sekretär | 41 Links Road KT17 3PP Epsom Surrey | British | 14674480002 | ||||||||||
| DUDGEON, Peter Maxwell | Sekretär | 41 Links Road KT17 3PP Epsom Surrey | British | 14674480002 | ||||||||||
| EPS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Lacon House Theobalds Road WC1X 8RW London | 67339580001 | |||||||||||
| ARNAOUTI, Michael | Geschäftsführer | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | England | British | 539040004 | |||||||||
| BIRD, Michael Anthony | Geschäftsführer | Meadow House Swan Barn Road GU27 2HY Haslemere Surrey | United Kingdom | British | 28326660002 | |||||||||
| BROWNE, Andrew Sheridan | Geschäftsführer | 16 Thornton Place W1H 1FL London | British | 23582690003 | ||||||||||
| CONWAY HUGHES, Christopher John | Geschäftsführer | 18 Mansel Road Wimbledon SW19 4AA London | British | 4560800002 | ||||||||||
| GILL, Christopher Marshall | Geschäftsführer | Strand WC2N 5AF London 5 United Kingdom | United Kingdom | British | 133825020001 | |||||||||
| GOLDHILL, Michael Louis | Geschäftsführer | 6 Keats Grove Hampstead NW3 2RT London | London, United Kingdom | British | 13575700001 | |||||||||
| JOBBURN, Stephen John | Geschäftsführer | 8 Hyde Park Gardens Mews W2 2NU London | United Kingdom | British | 157523770001 | |||||||||
| JOHNSON, Neville William | Geschäftsführer | 2 Howitts Close KT10 8LX Esher Surrey | United Kingdom | British | 14674100001 | |||||||||
| LEFTERIS, Mary | Geschäftsführer | 59 Kingwell Road Hadley Wood EN4 0HZ Barnet Hertfordshire | British | 39469990001 | ||||||||||
| MILLER, Louise | Geschäftsführer | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | United Kingdom | British | 199935770001 | |||||||||
| LAND SECURITIES MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | 5 Strand WC2N 5AF London | 74974580001 | |||||||||||
| LAND SECURITIES PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED | Geschäftsführer | Strand WC2N 5AF London 5 United Kingdom |
| 100069790001 | ||||||||||
| MIKJON LIMITED | Geschäftsführer | Lacon House 84 Theobald's Road WC1X 8RW London | 72341560001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei KNOLLYS HOUSE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ls Nominees Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Victoria Street SW1E 5JL London 100 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat KNOLLYS HOUSE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Obligor accession deed | Erstellt am 20. Feb. 2007 Geliefert am 22. Feb. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any obligor secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All rights title and interests in any real property, all plant machinery and other chattels, the obligor accounts, all shares and all dividends, all rights under any agreement, all intellectual property rights, all interest in any eligible investments, all goodwill, all uncalled share capital, all monetary claims and related rights. By way of assignment all rental income, all proceeds receivable and all documents. By way of first floating charge all present and future assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 20. Feb. 2007 Geliefert am 22. Feb. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any obligor secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Property k/a 47 mark lane, 48 mark lane and 7 byward street, 15 seething lane, 14 seething lane and land and buildings on the north side of byward street and the west side of seething lane, t/no's LN237663, 85111, 243166, LN68020 and LN221549. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Juli 2005 Geliefert am 25. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the security agent on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Juli 2005 Geliefert am 20. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrower to chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Nov. 2001 Geliefert am 04. Dez. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All liabilities of the borrower (as defined) to the chargee under or in connection with the facility agreement ,the security documents (both terms as defined) and any related hedging arrangements between the borrower and the bank together with the expenses (as defined) under this debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 26. Juli 2001 Geliefert am 15. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All the liabilities of hemingway investment partnership (the borrower) to the royal bank of scotland PLC (the bank) of any kind under or in connection with a facility agreement dated 18 july 2001 and made between inter alia, the borrower and the bank, as amended or supplemented (including without limitation an increase in the facility amount) from time to time, the various security documents executed in connection therewith and any related hedging arrangements between the borrower and the bank together with expenses relating to the foregoing | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage all the freehold and leasehold property and its proceeds of sale now vested in the company including the freehold property known as knolly's house, 1-12 byward street, 14-15 seething lane and 46-48 mark lane, london EC3 t/ns LN221549, 85111, 243166, LN237663 and LN68020. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0