SAPPHIRE (CARDIFF) NOMINEE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SAPPHIRE (CARDIFF) NOMINEE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04126131 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SAPPHIRE (CARDIFF) NOMINEE LIMITED?
- (7415) /
- (7487) /
Wo befindet sich SAPPHIRE (CARDIFF) NOMINEE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | GRANT THORNTON UK LLP 30 Finsbury Square EC2P 2YU London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SAPPHIRE (CARDIFF) NOMINEE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| G.P.E. (CARDIFF) NOMINEE LIMITED | 05. Feb. 2001 | 05. Feb. 2001 |
| SHELFCO (NO.2067) LIMITED | 15. Dez. 2000 | 15. Dez. 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SAPPHIRE (CARDIFF) NOMINEE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SAPPHIRE (CARDIFF) NOMINEE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Feb. 2012 | 10 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 22. Feb. 2012 | 10 Seiten | 2.35B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 23. Aug. 2011 | 9 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 1 Seiten | 2.31B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 23. Feb. 2011 | 15 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 6 Seiten | 2.16B | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 18 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 18 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 25 Harley Street London W1G 9BR am 06. Sept. 2010 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Malcolm Robin Turner am 01. Jan. 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Stephane Abraham Joseph Nahum am 01. Jan. 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Malcolm Robin Turner am 01. Jan. 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SAPPHIRE (CARDIFF) NOMINEE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E L SERVICES LIMITED | Sekretär | 25 Harley Street W1G 9BR London | 78638580003 | |||||||
| NAHUM, Stephane Abraham Joseph | Geschäftsführer | Millbank Tower 21-24 Millbank SW1P 4QP London 4th Floor | England | French | 99292580003 | |||||
| TURNER, Malcolm Robin | Geschäftsführer | Millbank SW1P 4QP London 4th Floor Millbank Tower 21-24 | United Kingdom | British | 60293070008 | |||||
| BLAIR, James Don | Sekretär | 9 Rosebank Grove EH5 3QN Edinburgh Midlothian | British | 85605320001 | ||||||
| MARTIN, Desna Lee | Sekretär | 72 Thurleigh Road SW12 8UD London | British | 62162550003 | ||||||
| EPS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Lacon House Theobalds Road WC1X 8RW London | 67339580001 | |||||||
| BARROTT, Ronald Stephen | Geschäftsführer | Foxborough Drovers Hill GL55 6UW Chipping Campden Gloucestershire | England | British | 9892700002 | |||||
| BRADLEY, Pauline Anne | Geschäftsführer | Spruce Tree House By Gleneagles PH4 1RG Auchterarder Perthshire | British | 122926460001 | ||||||
| CORCORAN, John Anthony | Geschäftsführer | 7 Milton Avenue Mosman New South Wales 2088 Australia | Australian | 79804100001 | ||||||
| CUMMINGS, Peter Joseph | Geschäftsführer | Glen View 6 Barloan Crescent G82 2AT Dumbarton Dunbartonshire | Scotland | British | 68241910003 | |||||
| GITTENS, Paul Alexander | Geschäftsführer | 29 Woodland Way Woodford Wells IG8 0QQ Woodford Essex | British | 14920090001 | ||||||
| KERR, Donald | Geschäftsführer | 28 Burnbank EH20 9NE Straiton Midlothian | British | 84247450001 | ||||||
| MACKINTOSH, Iain Stewart | Geschäftsführer | 9 Greenbank Terrace EH10 6ER Edinburgh Midlothian | British | 94163020001 | ||||||
| MACLEOD, Alan Donald Ewen | Geschäftsführer | 12 Violet Terrace EH11 1NZ Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 107116780001 | |||||
| MCDIVEN, Ross Arnold | Geschäftsführer | U 9 38 Bay Street NSW 2028 Double Bay New South Wales Australia | Australian | 108719480001 | ||||||
| MIDDLETON, Douglas Alister | Geschäftsführer | 16 Wesley Crescent Bonnyrigg EH19 3RT Edinburgh | British | 73738070001 | ||||||
| MURPHY, Kevin Joseph John | Geschäftsführer | 77b Home Park Road Wimbledon SW19 7HS London | British | 106832380002 | ||||||
| NATHAN, Timothy Paul | Geschäftsführer | 19 Elms Avenue N10 2JN London | England | British | 104162560001 | |||||
| PESKIN, Richard Martin | Geschäftsführer | 41 Circus Road St Johns Wood NW8 9JH London | England | British | 35018930001 | |||||
| SHAW, Peter David Marley | Geschäftsführer | Worth Cottage 9 Batchworth Heath WD3 1QB Rickmansworth Hertfordshire | British | 74197750001 | ||||||
| WATTERS, Michael John | Geschäftsführer | 51b Chesham Road Bryanston South Africa | South African | 79419220001 | ||||||
| WHITELEY, John Howard | Geschäftsführer | 14 Fallows Green AL5 4HD Harpenden Hertfordshire | England | British | 48980090002 | |||||
| MIKJON LIMITED | Geschäftsführer | Lacon House 84 Theobald's Road WC1X 8RW London | 72341560001 |
Hat SAPPHIRE (CARDIFF) NOMINEE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 31. Aug. 2005 Geliefert am 02. Sept. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that f/h land k/a the queens arcade cardiff t/n WA631557. All that f/h land k/a 3 st johns street cardiff t/n WA472989. All that f/h land known as 4 st johns street cardiff t/n WA41679. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Aug. 2005 Geliefert am 03. Sept. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Nov. 2001 Geliefert am 26. Nov. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a queen's arcade , 2/3 working street, 9 st john street, 3 st john street and 4 st john street cardiff t/nos: WA631557 WA416979 WA472989 and WA111979. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Nov. 2001 Geliefert am 22. Nov. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities due or to become due from the company (the "chargor") to the lenders (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat SAPPHIRE (CARDIFF) NOMINEE LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0