WOLFTEAM LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWOLFTEAM LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04127954
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WOLFTEAM LIMITED?

    • (5530) /

    Wo befindet sich WOLFTEAM LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o BEGBIES TRAYNOR (CENTRAL) LLP
    2 Collingwood Street
    NE1 1JF Newcastle Upon Tyne
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WOLFTEAM LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für WOLFTEAM LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Apr. 2011

    5 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom St Matthews House Haugh Lane Industrial Estate Hexham Northumberland NE46 3PU am 18. Nov. 2010

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Okt. 2010

    5 Seiten4.68

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 14. Okt. 2009

    10 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    10 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 16. Apr. 2009

    10 Seiten2.24B

    Vorschlag des Verwalters

    29 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    9 Seiten2.16B

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2007

    8 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    3 Seiten403a

    legacy

    3 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von WOLFTEAM LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CHAPMAN, Elaine
    Bewsehill Crescent
    NE21 6BW Winlaton
    39
    Tyne And Wear
    Sekretär
    Bewsehill Crescent
    NE21 6BW Winlaton
    39
    Tyne And Wear
    British128633130001
    LILLEY, Paul Neil
    Lee Moor House
    Juniper
    NE46 1SS Hexham
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Lee Moor House
    Juniper
    NE46 1SS Hexham
    Northumberland
    United KingdomBritish83531040003
    SULLIVAN, Christopher John
    8 Spring Gardens
    Waddington
    BB7 3HH Blackburn
    Lancashire
    Geschäftsführer
    8 Spring Gardens
    Waddington
    BB7 3HH Blackburn
    Lancashire
    EnglandBritish101400140001
    BOLEER, Steven Michael
    Brookfield
    Long Tail Hill
    LA23 3JD Bowness On Windermere
    Cumbria
    Sekretär
    Brookfield
    Long Tail Hill
    LA23 3JD Bowness On Windermere
    Cumbria
    British73818480001
    EDWARDS, Paul Alexander
    Lauriston
    62 Main Road
    NE40 3AJ Ryton
    Tyne & Wear
    Sekretär
    Lauriston
    62 Main Road
    NE40 3AJ Ryton
    Tyne & Wear
    British91098740003
    HEELEY, David
    Woodlands
    10 Woodlands Drive
    HP9 1JY Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Woodlands
    10 Woodlands Drive
    HP9 1JY Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British34731630003
    LILLEY, Francesca Ariadne Harvey
    Lee Moor House
    Juniper
    NE46 1SS Hexham
    Northumberland
    Sekretär
    Lee Moor House
    Juniper
    NE46 1SS Hexham
    Northumberland
    British88765130003
    MIDDLETON, Anthony
    10 St Nicholas Street
    PR4 2WB Wrea Green
    Lancashire
    Sekretär
    10 St Nicholas Street
    PR4 2WB Wrea Green
    Lancashire
    British115884010001
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite
    Lauren Court
    M33 2AF Wharf Road
    Sale
    Greater Manchester
    Bevollmächtigter Sekretär
    The Britannia Suite
    Lauren Court
    M33 2AF Wharf Road
    Sale
    Greater Manchester
    900018560001
    BOLEER, Steven Michael
    Brookfield
    Long Tail Hill
    LA23 3JD Bowness On Windermere
    Cumbria
    Geschäftsführer
    Brookfield
    Long Tail Hill
    LA23 3JD Bowness On Windermere
    Cumbria
    British73818480001
    MIDDLETON, Anthony John, Mr.
    Shrublands
    10 St Nicholas Grove Wrea Green
    PR4 2WB Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Shrublands
    10 St Nicholas Grove Wrea Green
    PR4 2WB Preston
    Lancashire
    United KingdomBritish104886040001
    MIDDLETON, Deni
    10 Saint Nicholas Grove
    PR4 2WB Wrea Green
    Lancashire
    Geschäftsführer
    10 Saint Nicholas Grove
    PR4 2WB Wrea Green
    Lancashire
    British69077360004
    DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite
    Lauren Court
    M33 2AF Wharf Road
    Sale
    Greater Manchester
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    The Britannia Suite
    Lauren Court
    M33 2AF Wharf Road
    Sale
    Greater Manchester
    900018550001

    Hat WOLFTEAM LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Third party legal charge
    Erstellt am 20. Sept. 2007
    Geliefert am 26. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the principal debtor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 13 upper dicconson street wigan and including all rights attached or appurtenant to it and all buildings,erections fixtures and fittings (including trade fixtures and fittings). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alliance and Leicester PLC
    Transaktionen
    • 26. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Third party legal charge
    Erstellt am 20. Sept. 2007
    Geliefert am 26. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the principal debtor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 8 st helens road ormskirk and including all rights attached or appurtenant to it and all buildings erections fixtures and fittings (including trade fixtures and fittings). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alliance and Leicester PLC
    Transaktionen
    • 26. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Third party legal charge
    Erstellt am 20. Sept. 2007
    Geliefert am 26. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the principal debtor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a the old post office springfield street palmyra square north warrington includings all rights attached or appurtenant to it and all buildings,erections fixtures and fittings (including trade fixtures and fittings) fixed plant and machinery from time to time on it. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alliance and Leicester PLC
    Transaktionen
    • 26. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Third party legal charge
    Erstellt am 08. Sept. 2007
    Geliefert am 26. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the grill group limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H part of 9-17 (odd) george street st helens t/no MS482892 all buildings erections fixtures and fittings all benefits in respect of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alliance & Leicester PLC
    Transaktionen
    • 26. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 08. Sept. 2007
    Geliefert am 25. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company to the security beneficiaries or any of them or to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Paul Neil Lilley for Each of the Security Beneficiaries
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 08. Sept. 2007
    Geliefert am 18. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alliance & Leicester Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 08. Sept. 2007
    Geliefert am 13. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) or to the trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Octopus Investments Limited (As Security Trustee for the Security Beneficiaries) (the Trust)
    Transaktionen
    • 13. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Okt. 2006
    Geliefert am 31. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or the shire group limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 8 st helens road ormskirk lancashire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Okt. 2006
    Geliefert am 31. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or the shire group limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a palmyra square north warrington.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Okt. 2006
    Geliefert am 31. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or the shire group limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 325 garstang road fulwood.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Okt. 2006
    Geliefert am 31. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or the shire group limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 9 george street st helens merseyside.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Okt. 2006
    Geliefert am 31. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or the shire group limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 13 upper dicconson street wigan.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Okt. 2006
    Geliefert am 26. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land at 9-17 (odd) george street st helens.
    Berechtigte Personen
    • Christine Elizabeth Bolger
    Transaktionen
    • 26. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 18. Okt. 2006
    Geliefert am 21. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    A legal mortgage over all land in england and wales vested in the company but not registered a fixed charge over certian identified assets of the company including all land a floating charge over all of the companys undertaking property assets rights and revenues whatever and wherever in the world. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 09. Juni 2005
    Geliefert am 22. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Jan. 2004
    Geliefert am 10. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of keyman life policy, intimated date 30 october 2003 and
    Erstellt am 26. Okt. 2003
    Geliefert am 01. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Standard life : policy number: X4839520 date : 12/02/2003 sum : £100000 life assured: anthony john middleton & steven michael bolger.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat WOLFTEAM LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    17. Okt. 2008Beginn der Verwaltung
    23. Okt. 2009Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Andrew D Haslam
    2 Collingwood Street
    NE1 1JF Newcastle Upon Tyne
    Praktiker
    2 Collingwood Street
    NE1 1JF Newcastle Upon Tyne
    Simon Lundy
    2 Collingwood Street
    NE1 1JF Newcastle Upon Tyne
    Praktiker
    2 Collingwood Street
    NE1 1JF Newcastle Upon Tyne
    2
    DatumTyp
    23. Okt. 2009Beginn der Liquidation
    27. Juli 2011Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Andrew D Haslam
    2 Collingwood Street
    NE1 1JF Newcastle Upon Tyne
    Praktiker
    2 Collingwood Street
    NE1 1JF Newcastle Upon Tyne
    Simon Lundy
    2 Collingwood Street
    NE1 1JF Newcastle Upon Tyne
    Praktiker
    2 Collingwood Street
    NE1 1JF Newcastle Upon Tyne

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0