MWB SERVICED OFFICE HOLDINGS LIMITED

MWB SERVICED OFFICE HOLDINGS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMWB SERVICED OFFICE HOLDINGS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04129282
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MWB SERVICED OFFICE HOLDINGS LIMITED?

    • Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich MWB SERVICED OFFICE HOLDINGS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MWB SERVICED OFFICE HOLDINGS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MWB (HOTEL LP SHAREHOLDER) LIMITED18. Dez. 200018. Dez. 2000

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MWB SERVICED OFFICE HOLDINGS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für MWB SERVICED OFFICE HOLDINGS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    26 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 11. Nov. 2016

    22 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 11. Nov. 2015

    27 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 11. Nov. 2014

    23 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 12. Nov. 2013

    32 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 09. Juni 2013

    32 Seiten2.24B

    legacy

    3 SeitenMG02

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    1 Seiten2.23B

    Beendigung der Bestellung von Michael Bibring als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    6 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    63 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 179 Great Portland Street London W1W 5LS* am 14. Dez. 2012

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Beendigung der Bestellung von Gail Robson als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Jagtar Singh als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Richard Balfour-Lynn als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2011

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital13. Dez. 2011

    Kapitalaufstellung am 13. Dez. 2011

    • Kapital: GBP 3
    SH01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2010 bis 30. Juni 2011

    3 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Rücktritt des Auditors

    5 SeitenAUD

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    12 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von MWB SERVICED OFFICE HOLDINGS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FILEX SERVICES LIMITED
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    Sekretär
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    3620420001
    ROBSON, Gail
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    Sekretär
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    British100895090001
    BALFOUR-LYNN, Richard Gary
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    Geschäftsführer
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    United KingdomBritish34251500001
    BIBRING, Michael Albert
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    EnglandBritish9320160002
    BLURTON, Andrew Francis
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    EnglandBritish53724380001
    HARRISON, John William
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    Geschäftsführer
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    United KingdomBritish69263980002
    SHASHOU, Joseph Saleem
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    Geschäftsführer
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    United KingdomBrazilian51723030002
    SINGH, Jagtar
    West Garden Place
    Kendal Street
    W2 2AQ London
    1
    Geschäftsführer
    West Garden Place
    Kendal Street
    W2 2AQ London
    1
    United KingdomBritish121710890001
    FILEX NOMINEES LIMITED
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    900020280001

    Hat MWB SERVICED OFFICE HOLDINGS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 12. Juni 2008
    Geliefert am 26. Juni 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 26. Juni 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge over shares
    Erstellt am 18. Sept. 2006
    Geliefert am 27. Sept. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First fixed charge its entire right,title and interest in and to the shares. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juli 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge on shares
    Erstellt am 10. Nov. 2005
    Geliefert am 29. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from mwb business exchange UK limited or the chargors to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    With full title guarantee by way of fixed charge the investments and all dividends,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Postbank Ag, London Branch as Trustee for Itself and the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 29. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge on shares
    Erstellt am 10. Nov. 2005
    Geliefert am 29. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from mwb business exchange UK limited or the chargors to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    With full title guarantee by way of fixed charge the investments and all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Postbank Ag, London Branch as Trustee for Itself and the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 29. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Shares charge (senior)
    Erstellt am 01. Juli 2003
    Geliefert am 22. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the principal debtor or the chargors to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge the investments and all dividends, interest and other money payable in respect of the investments.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bhf-Bank Aktiengesellschaft, London Branch (The Agent)
    Transaktionen
    • 22. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Shares charge (mezzanine)
    Erstellt am 01. Juli 2003
    Geliefert am 22. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the principal debtor or the chargors to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge the investments and all dividends, interest and other money payable in respect of the investments.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bhf-Bank Aktiengesellschaft, London Branch (The Agent)
    Transaktionen
    • 22. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental charge
    Erstellt am 23. Dez. 2002
    Geliefert am 10. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from mwb business exchange limited or the company to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge the shares being 25 shares of £1.00 in the share capital of mwb business exchange limited and all dividends, interest and other money payable to the company in respect of the shares, all of those assets and rights referred to in clause 3 of the share charge.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bhf-Bank Aktiengesellschaft, London Branch (The Agent)
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental charge
    Erstellt am 23. Dez. 2002
    Geliefert am 10. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from mwb business exchange limited or the company to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge the shares being 25 shares of £1.00 in the share capital of mwb business exchange limited and all dividends, interest and other money payable to the company in respect of the shares, all of those assets and rights referred to in clause 3 of the share charge.
    Berechtigte Personen
    • Ing Bhf-Bank Aktiengesellschaft, London Branch (The Agent)
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge on shares (senior)
    Erstellt am 28. Juni 2002
    Geliefert am 04. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All liabilities of the principal debtor or the chargor owed or expressed to be owed to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The investments and all dividends, interest and other money payable to the chargor in respect of the investments. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bhf-Bank Ag (The "Agent")
    Transaktionen
    • 04. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge on shares (mezzanine)
    Erstellt am 28. Juni 2002
    Geliefert am 04. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All liabilities of the principal debtor or the chargor owed or expressed to be owed to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The investments and all dividends, interest and other money payable to the chargor in respect of the investments. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bhf-Bank Ag (The "Agent")
    Transaktionen
    • 04. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat MWB SERVICED OFFICE HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    12. Nov. 2013Ende der Verwaltung
    10. Dez. 2012Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Philip Stephen Bowers
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praktiker
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Neville Barry Khan
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    2
    DatumTyp
    12. Nov. 2013Beginn der Liquidation
    15. Apr. 2018Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Philip Stephen Bowers
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praktiker
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Neville Barry Khan
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3BQ 66 Shoe Lane
    London
    Praktiker
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3BQ 66 Shoe Lane
    London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0