K P GENERAL PARTNER LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameK P GENERAL PARTNER LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04129627
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von K P GENERAL PARTNER LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich K P GENERAL PARTNER LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    81 Cromwell Road
    SW7 5BW London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von K P GENERAL PARTNER LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    DWSCO 2122 LIMITED21. Dez. 200021. Dez. 2000

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von K P GENERAL PARTNER LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für K P GENERAL PARTNER LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Beendigung der Bestellung von Valsec Company Secretarial Services Limited als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2010

    1 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. Dez. 2010

    Kapitalaufstellung am 29. Dez. 2010

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Ernennung von Valsec Company Secretarial Services Limited als Sekretär

    3 SeitenAP04

    Beendigung der Bestellung von Valad Secretarial Services Limited als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Dez. 2008 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Dez. 2007 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2009

    1 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Sekretärs für Valad Secretarial Services Limited am 21. Dez. 2009

    2 SeitenCH04

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Dez. 2008 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Simon John Patrick Lear am 01. Okt. 2009

    3 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mark Nicholas Balchin am 01. Okt. 2009

    3 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2008

    1 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    2 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2007

    1 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2006

    1 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von K P GENERAL PARTNER LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BALCHIN, Mark Nicholas
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    Geschäftsführer
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    UkBritish812680001
    LEAR, Simon John Patrick
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    Geschäftsführer
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    United KingdomBritish138750860001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    Sekretär
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    British812680001
    DWS SECRETARIES LIMITED
    5 Chancery Lane
    WC2A 1LF London
    Bevollmächtigter Sekretär
    5 Chancery Lane
    WC2A 1LF London
    900020220001
    VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Melville Street
    EH3 7NS Edinburgh
    4a
    United Kingdom
    Sekretär
    Melville Street
    EH3 7NS Edinburgh
    4a
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    RegistrierungsnummerSC219311
    133355520001
    VALSEC COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Sekretär
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer7307485
    154205080001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    VAN REYK, Philip
    Cherry Tree House
    Chequers Lane
    RG27 0NT Eversley
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Cherry Tree House
    Chequers Lane
    RG27 0NT Eversley
    Hampshire
    EnglandBritish76943220003
    DWS DIRECTORS LIMITED
    5 Chancery Lane
    WC2A 1LF London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    5 Chancery Lane
    WC2A 1LF London
    900020210001

    Hat K P GENERAL PARTNER LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 06. März 2002
    Geliefert am 12. März 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 57-59 cromwell road london t/n NGL377987. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Sept. 2001
    Geliefert am 25. Sept. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 57-59 cromwell road london t/no: NGL377987. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Equitable charge
    Erstellt am 02. Mai 2001
    Geliefert am 12. Mai 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H properties being 67 charlesworth house and garage 48, 77 charlesworth house and garage 51, 85 charlesworth house and garage 53 and 87 charlesworth house and garage 68 all at 46-52 stanhope gardens kensington and chelsea t/nos: BGL27244 BGL27220 BGL27222 and BGL27224. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Mai 2001
    Geliefert am 12. Mai 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as 57-79 cromwell road london title number NGL377987 all buildings and other structures all plant machinery by way of an assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 02. Mai 2001
    Geliefert am 12. Mai 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or partnership (as defined) to the chargee on any account whatsoever under this debenture
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0